• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • William Alexander HEANEY

    Natürliche Person

    TitelMr
    VornameWilliam
    Zweites VornamenAlexander
    NachnameHEANEY
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv4
    Inaktiv9
    Zurückgetreten33
    Gesamt46

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    WAYPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED24. Feb. 2022AktivChief Operations OfficerGeschäftsführer
    Maddox Street
    W1S 2QH London
    17-19
    England
    United KingdomBritish
    WAYPOINT INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED24. Feb. 2022AktivChief Operating OfficerGeschäftsführer
    Maddox Street
    W1S 2QH London
    17-19
    England
    United KingdomBritish
    BROOK STREET ASSOCIATES LIMITED03. Mai 2013AktivManagement ConsultantGeschäftsführer
    14 Deanway
    HP8 4JH Chalfont St Giles
    Clematis Cottage
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    EROICA MANAGEMENT SERVICES LIMITED28. Jan. 2008AktivCompany SecretarySekretär
    Maddox Street
    W1S 2QH London
    17-19
    England
    British
    SQUARE ROOT CONSULTING LLP22. Nov. 2007AufgelöstBestelltes Mitglied der LLP
    Clematis Cottage
    14 Deanway
    HP8 4JH Chalfont St. Giles
    United Kingdom
    LSR TRUSTEE LIMITED22. März 2007AufgelöstSekretär
    Clematis Cottage
    14 Deanway
    HP8 4JH Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British
    CPAM REALISATIONS LIMITED28. Okt. 2003AufgelöstCompany SecretaryGeschäftsführer
    Clematis Cottage
    14 Deanway
    HP8 4JH Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish
    PHOENIX ACQUISITIONS LIMITED20. Okt. 2003AufgelöstCompany SecretarySekretär
    Clematis Cottage
    14 Deanway
    HP8 4JH Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British
    CPS REALISATIONS LIMITED28. Aug. 2003AufgelöstCompany SecretaryGeschäftsführer
    Clematis Cottage
    14 Deanway
    HP8 4JH Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish
    CPAM REALISATIONS LIMITED13. Dez. 2001AufgelöstSekretär
    Clematis Cottage
    14 Deanway
    HP8 4JH Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British
    C REALISATIONS LIMITEDAufgelöstSekretär
    Clematis Cottage
    14 Deanway
    HP8 4JH Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British
    CHESTERTON INTERNATIONAL LIMITEDAufgelöstSekretär
    Clematis Cottage
    14 Deanway
    HP8 4JH Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British
    CPS REALISATIONS LIMITEDAufgelöstSekretär
    Clematis Cottage
    14 Deanway
    HP8 4JH Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British
    NOS 6 LIMITED28. März 200730. Juli 2021AktivSekretär
    Clematis Cottage
    14 Deanway
    HP8 4JH Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British
    ALINA HOLDINGS PLC08. März 200730. Juli 2021AktivSekretär
    Clematis Cottage
    14 Deanway
    HP8 4JH Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British
    NOS 4 LIMITED08. März 200730. Juli 2021AktivSekretär
    Clematis Cottage
    14 Deanway
    HP8 4JH Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British
    NOS 5 LIMITED08. März 200730. Juli 2021AktivSekretär
    Clematis Cottage
    14 Deanway
    HP8 4JH Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British
    NOS 7 LIMITED28. März 200730. Juli 2021AufgelöstSekretär
    Clematis Cottage
    14 Deanway
    HP8 4JH Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British
    GILFIN PROPERTY HOLDINGS LIMITED29. Aug. 200724. Nov. 2019AufgelöstSekretär
    Clematis Cottage
    14 Deanway
    HP8 4JH Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British
    ALINA HOLDINGS PLC10. Nov. 201608. Dez. 2016AktivCompany Secretary/DirectorGeschäftsführer
    Grosvenor Street
    W1K 3JH London
    65
    United KingdomBritish
    NOS 8 LIMITED28. März 200722. Juli 2016AufgelöstSekretär
    Clematis Cottage
    14 Deanway
    HP8 4JH Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British
    NOS LIMITED08. März 200722. Juli 2016AufgelöstSekretär
    Clematis Cottage
    14 Deanway
    HP8 4JH Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British
    EROICA MANAGEMENT SERVICES LIMITED03. März 201530. Sept. 2015AktivCompany Secretary/DirectorGeschäftsführer
    Deanway
    HP8 4JH Chalfont St. Giles
    14
    Buckinghamshire
    England
    United KingdomBritish
    205 HIGH ST (CROWTHORNE) MANAGEMENT COMPANY LIMITED26. Feb. 200726. Nov. 2014AktivCompany SecretarySekretär
    Clematis Cottage
    14 Deanway
    HP8 4JH Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British
    NOS 3 LIMITED08. März 200707. Aug. 2014AufgelöstSekretär
    Clematis Cottage
    14 Deanway
    HP8 4JH Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British
    NOS 2 LIMITED08. März 200707. Aug. 2014LiquidationSekretär
    Clematis Cottage
    14 Deanway
    HP8 4JH Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British
    CO REALISATIONS LIMITED04. Dez. 199828. Apr. 2005AufgelöstGeschäftsführer
    Clematis Cottage
    14 Deanway
    HP8 4JH Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish
    CO REALISATIONS LIMITED03. März 199028. Apr. 2005AufgelöstSekretär
    Clematis Cottage
    14 Deanway
    HP8 4JH Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British
    WORKPLACE MANAGEMENT (HEALTHCARE) LIMITED21. Feb. 200009. Juni 2004AufgelöstCompany SecretaryGeschäftsführer
    Clematis Cottage
    14 Deanway
    HP8 4JH Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish
    WORKPLACE MANAGEMENT (HEALTHCARE) LIMITED27. Okt. 199909. Juni 2004AufgelöstCompany SecretarySekretär
    Clematis Cottage
    14 Deanway
    HP8 4JH Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British
    WORKPLACE MANAGEMENT (WESTMINSTER) LIMITED19. Sept. 200217. Dez. 2003AktivCompany SecretaryGeschäftsführer
    Clematis Cottage
    14 Deanway
    HP8 4JH Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish
    WORKPLACE MANAGEMENT (WESTMINSTER) LIMITED03. Aug. 199917. Dez. 2003AktivSekretär
    Clematis Cottage
    14 Deanway
    HP8 4JH Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British
    EXCHEQUER PARTNERSHIP (NO.2) PLC26. Juli 200215. Dez. 2003AktivCompany SecretaryGeschäftsführer
    Clematis Cottage
    14 Deanway
    HP8 4JH Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish
    EXCHEQUER PARTNERSHIP (NO.2) HOLDINGS LIMITED26. Juli 200215. Dez. 2003AktivCompany SecretaryGeschäftsführer
    Clematis Cottage
    14 Deanway
    HP8 4JH Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish
    EXCHEQUER PARTNERSHIP PLC01. Juli 200015. Dez. 2003AktivCompany SecretaryGeschäftsführer
    Clematis Cottage
    14 Deanway
    HP8 4JH Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0