NOS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNOS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05342077
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NOS LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
    • Verwaltung von Immobilien auf Provisions- oder Vertragsbasis (68320) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich NOS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Coopers Yard
    Curran Road
    CF10 5NB Cardiff
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von NOS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    EVER 2550 LIMITED25. Jan. 200525. Jan. 2005

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NOS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für NOS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für NOS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Beendigung der Bestellung von William Alexander Heaney als Sekretär am 22. Juli 2016

    1 SeitenTM02

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    7 Seiten4.71

    Beendigung der Bestellung von Steven Robert Faber als Geschäftsführer am 11. Apr. 2016

    1 SeitenTM01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Mai 2015

    5 Seiten4.68

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital30. Jan. 2015

    Kapitalaufstellung am 30. Jan. 2015

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O Internos Global 65 Grosvenor Street London W1K 3JL* am 06. Juni 2014

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    4 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESSP

    Beendigung der Bestellung von Nicholas Vetch als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Stephen East als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital27. Jan. 2014

    Kapitalaufstellung am 27. Jan. 2014

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 6Th Floor Palladium House 1-4 Argyll Street London W1F 7TA* am 17. Sept. 2013

    1 SeitenAD01

    Beendigung der Bestellung von Victoria Whitehouse als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Michael Riley als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Nicholas Gregory als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Steven Robert Faber als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Nicholas John Vetch als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Stephen John East als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2012

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2011

    3 SeitenAA

    legacy

    5 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Wer sind die Geschäftsführer von NOS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CREDALI, Giuseppe Antonio, Mr.
    3 Richmond Gardens
    WV5 0LQ Wombourne
    West Midlands
    Sekretär
    3 Richmond Gardens
    WV5 0LQ Wombourne
    West Midlands
    British81507150004
    HEANEY, William Alexander
    Clematis Cottage
    14 Deanway
    HP8 4JH Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Clematis Cottage
    14 Deanway
    HP8 4JH Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British2538150001
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Sekretär
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    60471940015
    EAST, Stephen John
    c/o Internos Global
    Grosvenor Street
    W1K 3JL London
    65
    England
    Geschäftsführer
    c/o Internos Global
    Grosvenor Street
    W1K 3JL London
    65
    England
    EnglandBritishCompany Director108586450001
    FABER, Steven Robert
    Curran Road
    CF10 5NB Cardiff
    Coopers Yard
    Geschäftsführer
    Curran Road
    CF10 5NB Cardiff
    Coopers Yard
    EnglandBritishChartered Surveyor102825930002
    GREGORY, Nicholas John
    Rands
    Rands Road, High Roding
    CM6 1NH Dunmow
    Essex
    Geschäftsführer
    Rands
    Rands Road, High Roding
    CM6 1NH Dunmow
    Essex
    EnglandBritishCompany Director84754890001
    RILEY, Michael Edward
    34 Thornton Avenue
    SO31 9FJ Warsash
    The Ferry House
    England
    Geschäftsführer
    34 Thornton Avenue
    SO31 9FJ Warsash
    The Ferry House
    England
    United KingdomBritishCompany Director94724020003
    VETCH, Nicholas John
    c/o Internos Global
    Grosvenor Street
    W1K 3JL London
    65
    England
    Geschäftsführer
    c/o Internos Global
    Grosvenor Street
    W1K 3JL London
    65
    England
    EnglandBritishCompany Director6270470003
    WHITEHOUSE, Victoria Ann
    The Old Granary
    5 Shurnock Court Saltway
    B96 6JT Feckenham
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    The Old Granary
    5 Shurnock Court Saltway
    B96 6JT Feckenham
    Worcestershire
    EnglandBritishChartered Accountant212489080001
    EVERDIRECTOR LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Lancashire
    60471930010

    Hat NOS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Juli 2005
    Geliefert am 04. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    2 castle street & 33/34 blue boar row, salisbury, t/n WT208556, together with all of its rights in all buildings, structures, erections, fixtures and fittings (including trade fixtures and fittings) and any proceeds of disposal of the mortgaged property.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juni 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 29. Juni 2005
    Geliefert am 07. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property at shops units 1, 2 and 4 capital square, victoria road, chelmsford. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juni 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 25. Mai 2005
    Geliefert am 25. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    40-42 hanbury road bargoed caerphilly t/no CYM1143. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juni 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 03. Mai 2005
    Geliefert am 19. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    102 crwys road,cardiff; WA323716. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juni 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 03. Mai 2005
    Geliefert am 19. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1-6 st martins row,albany rd,roath,cardiff; WA280567. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juni 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Apr. 2005
    Geliefert am 26. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H palma court 27 brookend street ross on wye. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juni 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 15. Apr. 2005
    Geliefert am 30. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Prospect house 25-27 worcester street kidderminster t/no HW182226. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juni 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Floating charge
    Erstellt am 13. Apr. 2005
    Geliefert am 27. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First floating charge over all the secured assets being the undertaking goodwill property assets revenues and rights (including uncalled capital) of the company both present and future,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Castlemore Holdings Limited
    Transaktionen
    • 27. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Juni 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 13. Apr. 2005
    Geliefert am 21. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juni 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Apr. 2005
    Geliefert am 16. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 5B pentwyn road blackwood. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juni 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Hat NOS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    23. Mai 2014Beginn der Liquidation
    18. Aug. 2016Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Wilfred Vaughan Jones
    11 Coopers Yard
    Curran Road
    CF10 5NB Cardiff
    Praktiker
    11 Coopers Yard
    Curran Road
    CF10 5NB Cardiff
    Susan Clay
    11 Coopers Yard
    Curran Road
    CF10 5NB Cardiff
    Praktiker
    11 Coopers Yard
    Curran Road
    CF10 5NB Cardiff

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0