Alastair Cameron DAVID
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | Alastair |
Zweites Vornamen | Cameron |
Nachname | DAVID |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 1 |
Inaktiv | 14 |
Zurückgetreten | 15 |
Gesamt | 30 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACORNS CHILDREN'S HOSPICE TRUST | 26. Juli 2017 | Aktiv | Retired | Geschäftsführer | Drakes Court, Alcester Road Wythall B47 6JR Birmingham | England | British | |
JAMAS ASSOCIATES LIMITED | 01. Juni 2016 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Cloister Way CV32 6QE Leamington Spa 4 England | England | British | |
IT'S BESTDIRECT.COM LTD | 31. Okt. 2009 | Aufgelöst | Chartered Accountant | Geschäftsführer | Station Road LE17 4AP Lutterworth 37 Leicestershire United Kingdom | England | British | |
EPZILON LIMITED | 19. Nov. 2008 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Northumberland Road CV32 6HG Leamington Spa 108 Warwickshire United Kingdom | England | British | |
HUSKY DIRECT LIMITED | 31. Mai 2008 | Aufgelöst | Sekretär | Northumberland Road CV32 6HG Leamington Spa 108 Warwickshire United Kingdom | British | |||
HUSKY HOME APPLIANCES LIMITED | 31. Mai 2008 | Aufgelöst | Sekretär | Northumberland Road CV32 6HG Leamington Spa 108 Warwickshire United Kingdom | British | |||
HUSKY COMMERCIAL (UK) LIMITED | 31. Mai 2008 | Aufgelöst | Sekretär | Northumberland Road CV32 6HG Leamington Spa 108 Warwickshire United Kingdom | British | |||
TRADE ONLY (WHOLESALE) LIMITED | 31. Mai 2008 | Aufgelöst | Sekretär | Northumberland Road CV32 6HG Leamington Spa 108 Warwickshire United Kingdom | British | |||
HUSKY COMMERCIAL EQUIPMENT LIMITED | 31. Mai 2008 | Aufgelöst | Sekretär | Northumberland Road CV32 6HG Leamington Spa 108 Warwickshire United Kingdom | British | |||
HUSKY GROUP LIMITED | 25. Apr. 2008 | Aufgelöst | Finance Director | Sekretär | Northumberland Road CV32 6HG Leamington Spa 108 Warwickshire United Kingdom | British | ||
HUSKY HOME APPLIANCES LIMITED | 17. Jan. 2005 | Aufgelöst | Managing Director | Geschäftsführer | Northumberland Road CV32 6HG Leamington Spa 108 Warwickshire United Kingdom | England | British | |
HUSKY DIRECT LIMITED | 17. Jan. 2005 | Aufgelöst | Managing Director | Geschäftsf ührer | Northumberland Road CV32 6HG Leamington Spa 108 Warwickshire United Kingdom | England | British | |
HUSKY GROUP LIMITED | 17. Jan. 2005 | Aufgelöst | Finance Director | Geschäftsführer | Northumberland Road CV32 6HG Leamington Spa 108 Warwickshire United Kingdom | England | British | |
HUSKY COMMERCIAL (UK) LIMITED | 17. Jan. 2005 | Aufgelöst | Managing Director | Geschäftsführer | Northumberland Road CV32 6HG Leamington Spa 108 Warwickshire United Kingdom | England | British | |
HUSKY COMMERCIAL EQUIPMENT LIMITED | 17. Jan. 2005 | Aufgelöst | Managing Director | Geschäftsführer | Northumberland Road CV32 6HG Leamington Spa 108 Warwickshire United Kingdom | England | British | |
HUSKY INTERNATIONAL LIMITED | 11. Okt. 2009 | 07. Apr. 2016 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Northumberland Road CV32 6HG Leamington Spa 108 Warwickshire England | England | British |
HUSKY RETAIL LIMITED | 19. Nov. 2008 | 07. Apr. 2016 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Northumberland Road CV32 6HG Leamington Spa 108 Warwickshire United Kingdom | England | British |
HUSKY REFRIGERATORS (UK) LIMITED | 19. Nov. 2008 | 07. Apr. 2016 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Northumberland Road CV32 6HG Leamington Spa 108 Warwickshire United Kingdom | England | British |
JUPITER INDUSTRIES LIMITED | 31. Mai 2008 | 07. Apr. 2016 | Aktiv | Sekretär | Northumberland Road CV32 6HG Leamington Spa 108 Warwickshire United Kingdom | British | ||
HUSKY IRELAND LIMITED | 28. Apr. 2006 | 09. Apr. 2010 | Aufgelöst | Finance Director | Geschäftsführer | 108 Northumberland Road Leamington Spa CV32 6HG Warwickshire | England | British |
HUSKY TECHNICAL SERVICES LTD | 01. Juli 2009 | 09. Apr. 2010 | Liquidation | Director | Geschäftsführer | 108 Northumberland Road Leamington Spa CV32 6HG Warwickshire | England | British |
PRESSAC FINANCE OVERSEAS | 06. Aug. 2002 | 31. Dez. 2004 | Aktiv | Company Director/Accountant | Geschäftsführer | Northumberland Road CV32 6HG Leamington Spa 108 Warwickshire United Kingdom | England | British |
PRESSAC FINANCE OVERSEAS | 06. Aug. 2002 | 31. Dez. 2004 | Aktiv | Company Director/Accountant | Sekretär | Northumberland Road CV32 6HG Leamington Spa 108 Warwickshire United Kingdom | British | |
PRESSAC HOLDINGS LLC | 13. Sept. 2001 | 31. Dez. 2004 | Aktiv | Chartered Accountant | Geschäftsführer | Northumberland Road CV32 6HG Leamington Spa 108 Warwickshire United Kingdom | England | British |
PRESSAC INVESTMENTS LIMITED | 01. Mai 2002 | 31. Dez. 2004 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | Northumberland Road CV32 6HG Leamington Spa 108 Warwickshire United Kingdom | England | British |
PRESSAC INVESTMENTS LIMITED | 23. Dez. 1996 | 31. Dez. 2004 | Aufgelöst | Sekretär | Northumberland Road CV32 6HG Leamington Spa 108 Warwickshire United Kingdom | British | ||
PRESSAC PLC | 11. Feb. 1992 | 31. Dez. 2004 | Aufgelöst | Sekretär | Northumberland Road CV32 6HG Leamington Spa 108 Warwickshire United Kingdom | British | ||
JML REALISATIONS LIMITED | 18. Sept. 2002 | 22. Jan. 2003 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | Northumberland Road CV32 6HG Leamington Spa 108 Warwickshire United Kingdom | England | British |
00554636 LIMITED | 29. Aug. 2000 | 28. Juni 2002 | Aufgelöst | Sekretär | Northumberland Road CV32 6HG Leamington Spa 108 Warwickshire United Kingdom | British | ||
PRESSAC (UK) LIMITED | 23. Sept. 1997 | 30. Apr. 1998 | Aufgelöst | Sekretär | Northumberland Road CV32 6HG Leamington Spa 108 Warwickshire United Kingdom | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0