00554636 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | 00554636 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00554636 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von 00554636 LIMITED?
- (3210) /
Wo befindet sich 00554636 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Ernst & Young Llp PO BOX 61 LS1 2JN Leeds |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von 00554636 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PRESSAC INTERCONNECT LIMITED | 02. Okt. 1997 | 02. Okt. 1997 |
| PRESSAC LIMITED | 15. Sept. 1955 | 15. Sept. 1955 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von 00554636 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2003 |
Welche sind die letzten Einreichungen für 00554636 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss | 4 Seiten | AC92 | ||||||||||
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers | 3 Seiten | 3.6 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 405(2) | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers | 3 Seiten | 3.6 | ||||||||||
Verschiedenes Form 3.2 - statement of affairs | 9 Seiten | MISC | ||||||||||
Bericht des Verwaltungsverwalters | 15 Seiten | 3.10 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 405(1) | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2003 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | 0 Seiten | 363(288) | ||||||||||
legacy | 0 Seiten | 363(353) | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2002 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | 0 Seiten | 363(288) | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2001 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 11 Seiten | MA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 5 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von 00554636 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARRINGTON, Paul Hiram | Sekretär | 14 Portland Crescent Stapleford NG9 7GT Nottingham Nottinghamshire | British | 103684450001 | ||||||
| ASTILL, John Thomas | Geschäftsführer | 10 Appian Close Borrowash DE72 3LY Derby Derbyshire | United Kingdom | British | 58693960001 | |||||
| CLAY, Phillip | Geschäftsführer | 32 Quarry Road NG15 9AP Nottingham Nottinghamshire | United Kingdom | British | 103878240001 | |||||
| RIPPIN, David John | Geschäftsführer | 66 Lock Lane Long Eaton NG10 3DD Nottingham Nottinghamshire | British | 29781200001 | ||||||
| WARWICK, John Andrew | Geschäftsführer | 43 St Therese Circle Hanceville Alabama 35077 United States | American | 90441930001 | ||||||
| WHITTAKER, David | Geschäftsführer | 30 Orchard Close Boulton Moor DE24 5AE Derby | British | 82130600002 | ||||||
| BARKER, Anthony | Sekretär | 11 Pollards Close Derbywash DE72 3QU Derbyshire | British | 83350930001 | ||||||
| DAVID, Alastair Cameron | Sekretär | Northumberland Road CV32 6HG Leamington Spa 108 Warwickshire United Kingdom | British | 130261580001 | ||||||
| IDDON, Nicholas Peter | Sekretär | 24 The Willows Pleasley NG19 7SN Mansfield Nottinghamshire | British | 85524130001 | ||||||
| LANGWORTHY, David Anthony | Sekretär | 173 Cole Lane Borrowash DE72 3GP Derby Derbyshire | British | 3176320001 | ||||||
| PROSSER, Michael Trevelyan | Sekretär | 73 Merlin Way Mickleover DE3 5UJ Derby Derbyshire | British | 69196950002 | ||||||
| BARKER, Anthony | Geschäftsführer | 11 Pollards Close Derbywash DE72 3QU Derbyshire | British | 83350930001 | ||||||
| GORDON, Harry Stuart | Geschäftsführer | Greylands Mereside Road Mere WA16 6QQ Knutsford Cheshire | British | 25073230002 | ||||||
| IDDON, Nicholas Peter | Geschäftsführer | 24 The Willows Pleasley NG19 7SN Mansfield Nottinghamshire | British | 85524130001 | ||||||
| JEPSON, Michael John | Geschäftsführer | 4a The Grove DE72 3AE Breaston Derbyshire | British | 46915290001 | ||||||
| KILMURRY, Martin | Geschäftsführer | 5557 Parkview Circle Birmingham Alabama 35242 Usa | British | 70733870002 | ||||||
| KING, Anthony Clive Garner | Geschäftsführer | Gowan Bank 47 Broadway DE56 4BU Duffield Derbyshire | England | British | 108853950001 | |||||
| LANGWORTHY, David Anthony | Geschäftsführer | 173 Cole Lane Borrowash DE72 3GP Derby Derbyshire | British | 3176320001 | ||||||
| LEWIS, Huw Roderic | Geschäftsführer | 26 Chattaway Drive Balsall Common CV7 7QH Coventry Warwickshire | British | 13419660001 | ||||||
| MILLINGTON, Terence John | Geschäftsführer | 319 Leake Road Gotham NG11 0LE Nottingham Nottinghamshire | British | 3315380001 | ||||||
| MUIR, Iain Brodie | Geschäftsführer | 36 Muir Road EH48 2QH Bathgate West Lothian | British | 61285110001 | ||||||
| PROSSER, Michael Trevelyan | Geschäftsführer | 73 Merlin Way Mickleover DE3 5UJ Derby Derbyshire | British | 69196950002 | ||||||
| ROPER, Colin | Geschäftsführer | 3 Lancaster Avenue Stapleford NG9 7HH Nottingham Nottinghamshire | British | 3315400001 | ||||||
| SNAITH, Colin | Geschäftsführer | Springfield Lodge 1 Raneleigh Road WR14 1BQ Malvern Link Worcestershire | British | 86828990001 | ||||||
| STIBBARDS, Kevin Brian | Geschäftsführer | 6 Langar Lane Harby LE14 4BL Melton Mowbray Leicestershire | British | 74827280001 | ||||||
| VAISEY, Alfred John | Geschäftsführer | 8 Jacques Close Water Orton BA6 1TJ Warwickshire | British | 30421960001 | ||||||
| WHITE, Geoffrey Charles | Geschäftsführer | 8 Rawlings Street SW3 2LS London | British | 86433340001 | ||||||
| WHITTAKER, David | Geschäftsführer | 106 Gray Run Huntsville Alabama 35824 Usa | British | 82130600001 |
Hat 00554636 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 28. Juni 2002 Geliefert am 08. Juli 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Juni 2002 Geliefert am 02. Juli 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattels mortgage | Erstellt am 23. März 1995 Geliefert am 23. März 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben One new presco 60 ton press serial no :- 5441. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattels mortgage | Erstellt am 15. Dez. 1994 Geliefert am 15. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben One new ultrasonic film coating machine, serial no. 15942908. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattels mortgage | Erstellt am 12. Apr. 1994 Geliefert am 12. Apr. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben One new kaco plant solder cell ii, serial no: 6ES5710/8M41 one new demag ET25-80 compact injection moulding machine, serial no: 7111-0039. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat 00554636 LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Administrativer Receiver bestellt |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0