• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Ronald Miller MILLAR

    Natürliche Person

    TitelMr
    VornameRonald
    Zweites VornamenMiller
    NachnameMILLAR
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv4
    Inaktiv2
    Zurückgetreten27
    Gesamt33

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    PAYSEND NOMINEES LIMITED14. Juni 2022AktivDirector/CeoGeschäftsführer
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    Suite 2, Ground Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    CCY PROVIDER LIMITED19. Sept. 2018AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    Suite 2, Ground Floor
    Scotland
    United KingdomBritish
    PAYSEND TECHNOLOGY LIMITED10. Juli 2018AktivDirectorGeschäftsführer
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    Suite 2, Ground Floor
    Scotland
    United KingdomBritish
    PAYSEND GROUP LIMITED04. Apr. 2017AktivChartered AccountantGeschäftsführer
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    Suite 2, Ground Floor
    Scotland
    United KingdomBritish
    PAYSEND PLC31. März 2010AktivChartered AccountantGeschäftsführer
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    Suite 2, Ground Floor
    Scotland
    United KingdomBritish
    PROFILE SOFTWARE LIMITED25. Juli 2001AufgelöstChartered AccountantGeschäftsführer
    Cluny Court
    John Smith Business Park
    KY2 6QJ Kirkcaldy
    Fife
    United KingdomBritish
    MGT TECHNOLOGY LIMITED06. März 201321. Okt. 2022AktivDirectorGeschäftsführer
    John Smith Business Park
    Kirkcaldy
    KY2 6QJ Fife
    Cluny Court
    Scotland
    United KingdomBritish
    PAYWIZARD LIMITED15. Juni 200028. Juni 2022AktivChartered AccountantGeschäftsführer
    Cluny Court
    John Smith Business Park
    KY2 6QJ Kirkcaldy
    Fife
    United KingdomBritish
    SINGULA DECISIONS LIMITED04. Juni 199728. Juni 2022AktivChartered AccountantGeschäftsführer
    John Smith Business Park
    KY2 6QJ Kirkcaldy
    Cluny Court
    Fife
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    SINGULA DECISIONS LIMITED13. Mai 199804. Juli 2000AktivSekretär
    49 Guthrie Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SD Auchterarder
    Perthshire
    British
    JADEOVAL LIMITED18. Feb. 1998AufgelöstChartered AccountantGeschäftsführer
    49 Guthrie Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SD Auchterarder
    Perthshire
    British
    ARGENT ESTATES LIMITED18. Nov. 199603. Feb. 1998AktivAccountantGeschäftsführer
    49 Guthrie Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SD Auchterarder
    Perthshire
    British
    ALBANY COURTYARD INVESTMENTS LIMITED10. Juli 199603. Feb. 1998AktivAccountantGeschäftsführer
    49 Guthrie Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SD Auchterarder
    Perthshire
    British
    ARGENT GROUP DEVELOPMENTS LIMITED13. Mai 199403. Feb. 1998AktivSekretär
    49 Guthrie Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SD Auchterarder
    Perthshire
    British
    ALBANY COURTYARD INVESTMENTS LIMITED13. Mai 199403. Feb. 1998AktivSekretär
    49 Guthrie Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SD Auchterarder
    Perthshire
    British
    ARGENT GROUP DEVELOPMENTS LIMITED20. Apr. 199403. Feb. 1998AktivAccountantGeschäftsführer
    49 Guthrie Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SD Auchterarder
    Perthshire
    British
    ARGENT (CRYSTAL PEAKS) LIMITED10. Jan. 199703. Feb. 1998AufgelöstCompany DirectorGeschäftsführer
    49 Guthrie Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SD Auchterarder
    Perthshire
    British
    BRINDLEYPLACE LIMITED18. Nov. 199603. Feb. 1998AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    49 Guthrie Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SD Auchterarder
    Perthshire
    British
    ARGENT (READING) LIMITED19. Juli 199603. Feb. 1998AufgelöstCompany DirectorGeschäftsführer
    49 Guthrie Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SD Auchterarder
    Perthshire
    British
    ARGENT DEVELOPMENT CONSORTIUM LIMITED10. Juli 199603. Feb. 1998AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    49 Guthrie Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SD Auchterarder
    Perthshire
    British
    ARGENT DEVELOPMENT CONSORTIUM LIMITED14. Dez. 199503. Feb. 1998AufgelöstSekretär
    49 Guthrie Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SD Auchterarder
    Perthshire
    British
    ARGENT DEVELOPMENT MANAGEMENT LIMITED31. Aug. 199403. Feb. 1998AufgelöstFinance DirectorGeschäftsführer
    49 Guthrie Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SD Auchterarder
    Perthshire
    British
    BRINDLEYPLACE LIMITED06. Juli 199403. Feb. 1998AufgelöstFinance DirectorSekretär
    49 Guthrie Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SD Auchterarder
    Perthshire
    British
    NO. 5 BRINDLEYPLACE LIMITED06. Mai 199403. Feb. 1998AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    49 Guthrie Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SD Auchterarder
    Perthshire
    British
    ARGENT (ST JOHN'S LEEDS) LIMITED06. Mai 199403. Feb. 1998AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    49 Guthrie Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SD Auchterarder
    Perthshire
    British
    BANDACTUAL LIMITED11. März 199403. Feb. 1998AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    49 Guthrie Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SD Auchterarder
    Perthshire
    British
    ARWP (EXETER) LIMITED11. März 199403. Feb. 1998AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    49 Guthrie Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SD Auchterarder
    Perthshire
    British
    SCHEMEPROOF LIMITED11. März 199403. Feb. 1998AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    49 Guthrie Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SD Auchterarder
    Perthshire
    British
    ARWP (TONBRIDGE) LIMITED11. März 199403. Feb. 1998AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    49 Guthrie Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SD Auchterarder
    Perthshire
    British
    ARWP (BIRSTALL) LIMITED11. März 199403. Feb. 1998AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    49 Guthrie Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SD Auchterarder
    Perthshire
    British
    ARGENT GROUP LIMITED23. März 199406. Jan. 1998AktivAccountantSekretär
    49 Guthrie Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SD Auchterarder
    Perthshire
    British
    CHASOPHIE LIMITED08. Feb. 199418. Feb. 1994AktivAccountantGeschäftsführer
    49 Guthrie Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SD Auchterarder
    Perthshire
    British
    ARGENT GROUP LIMITED05. Juli 199313. Juli 1993AktivAccountantGeschäftsführer
    49 Guthrie Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SD Auchterarder
    Perthshire
    British

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0