ARGENT DEVELOPMENT CONSORTIUM LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ARGENT DEVELOPMENT CONSORTIUM LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03134233 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ARGENT DEVELOPMENT CONSORTIUM LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich ARGENT DEVELOPMENT CONSORTIUM LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 5 Albany Courtyard Piccadilly W1J 0HF London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ARGENT DEVELOPMENT CONSORTIUM LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ARGENT DEVELOPMENT CONSORTIUM LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 24. Feb. 2012
| 8 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 9 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Roger Nigel Madelin am 28. Jan. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 9 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David John Gratiaen Partridge am 01. Apr. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Susan Dollinger als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Amanda Thomson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Freeman als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Freeman als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Quentin Burgess als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ARGENT DEVELOPMENT CONSORTIUM LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROWER, Aubyn James Sugden | Sekretär | Marchants Lower Station Road Newick BN8 4HT Lewes East Sussex | British | 45043490002 | ||||||
| SADLER, Anita Joanne | Sekretär | 8 Eddiscombe Road SW6 4UA London | British | 104279900001 | ||||||
| MADELIN, Roger Nigel | Geschäftsführer | Spring Grove Road TW10 6EH Richmond 6 Surrey United Kingdom | England | British | 11621570009 | |||||
| MOUSLEY, Emily Ann | Geschäftsführer | 5 Albany Courtyard Piccadilly W1J 0HF London | United Kingdom | British | 155262770001 | |||||
| PARTRIDGE, David John Gratiaen | Geschäftsführer | 39/41 All Saints Road Notting Hill W11 1HE London Flat 4 United Kingdom | United Kingdom | British | 41215410019 | |||||
| MILLAR, Ronald | Sekretär | 49 Guthrie Court Gleneagles Village PH3 1SD Auchterarder Perthshire | British | 70586450001 | ||||||
| FETTER SECRETARIES LIMITED | Sekretär | C/O Kendall Freeman 43 Fetter Lane EC4A 1JU London | 71203580001 | |||||||
| ALSTON, Charles Stephen Withycombe | Geschäftsführer | 8 Baronsmead Road Barnes SW13 9RR London | British | 66505450002 | ||||||
| BIRCH, Michael Philip | Geschäftsführer | Lych Gate Littlewick Green SL6 3QU Maidenhead Berkshire | Britain | British | 141799780001 | |||||
| BURGESS, Quentin James Neilson | Geschäftsführer | The Red House Chelwood Vachery TN22 3HR Nutley East Sussex | England | British | 42896080002 | |||||
| BURTON, Mark Ashley | Geschäftsführer | South Lodge Hannington RG26 5TX Tadley Hampshire | England | British | 125593340001 | |||||
| DOLLINGER, Susan Betty | Geschäftsführer | 285 Smith Ridge Rd South Salem 10590 FOREIGN New York Usa | Usa | American | 66549310001 | |||||
| FEWINGS, Martyn Trevor | Geschäftsführer | Cherry Tree Cottage Lords Hill Common Shamley Green GU5 0TJ Guildford Surrey | British | 41415180001 | ||||||
| FREEMAN, Michael Ian | Geschäftsführer | 9 Connaught Square W2 2HG London | United Kingdom | British | 2119280002 | |||||
| FREEMAN, Peter Geoffrey | Geschäftsführer | 11 Holland Park W11 3TH London | United Kingdom | British | 11621550012 | |||||
| LINEHAM, Timothy Mark Vaughan | Geschäftsführer | Eastgate House Park Lane TN15 0JD Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | 66505360002 | |||||
| MARTIN, Andrew John, Mr. | Geschäftsführer | Hazelryst Rystwood Road RH18 5LX Forest Row East Sussex | England | British | 3565840001 | |||||
| MCLEAN, John | Geschäftsführer | 17a Grove End Road NW8 London | Canadian | 50389210001 | ||||||
| MILLAR, Ronald | Geschäftsführer | 49 Guthrie Court Gleneagles Village PH3 1SD Auchterarder Perthshire | British | 70586450001 | ||||||
| MILTON, Neil Douglas | Geschäftsführer | Littlemead Albourne Road BN6 9ES Hurstpierpoint West Sussex | United Kingdom | British | 149369870001 | |||||
| PEDLOW, Joseph Martin | Geschäftsführer | 24 Eton Avenue NW3 3HL London | American | 55169650001 | ||||||
| THOMSON, Amanda Jane | Geschäftsführer | Flat 2 43 Eton Avenue Belsize Park NW3 3EP London | United Kingdom | British | 47240760001 | |||||
| FETTER INCORPORATIONS LIMITED | Geschäftsführer | C/O Kendall Freeman 43 Fetter Lane EC4A 1JU London | 71203570001 | |||||||
| FETTER SECRETARIES LIMITED | Geschäftsführer | C/O Kendall Freeman 43 Fetter Lane EC4A 1JU London | 71203580001 |
Hat ARGENT DEVELOPMENT CONSORTIUM LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 15. Apr. 2002 Geliefert am 30. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor and each investor to each finance party and to the counterparty under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. Apr. 2002 Geliefert am 30. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor and each investor to each finance party and to the counterparty under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Senior supplemental debenture between the chargor and bayerische hypo- und vereinsbank aktiengesellschaft (the agent) | Erstellt am 26. Sept. 2001 Geliefert am 08. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities of the chargor and each investor to each finance party and to the counterparty under each finance document (all terms as defined) | |
Kurze Angaben All shares held by it and/or any nominee on its behalf and all related rights which means any dividend or interest paid or payable in relation to any share. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Junior supplemental debenture between the chargor and bayerische hypo- und vereinsbank aktiengesellschaft (the agent) | Erstellt am 26. Sept. 2001 Geliefert am 08. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities of the chargor and each investor to each finance party and to the counterparty under each finance document (all terms as defined) | |
Kurze Angaben All shares held by it and/or any nominee on its behalf and all related rights which means any dividend or interest paid or payable in relation to any share. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Jan. 1996 Geliefert am 23. Jan. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent due or to become due from the company and each investor (as defined) to the chargee under each finance document (as defined in the charge) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Jan. 1996 Geliefert am 05. Jan. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities of the company and/or each or all of the other companies named therein to the chargees pursuant to the terms of the mezzanine loan facility dated 20/12/95 together with the finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben F/H property k/a suffolk house laurence pountney hill london t/no NGL95424. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0