Nazir SARKAR
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | Nazir |
Nachname | SARKAR |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 14 |
Zurückgetreten | 34 |
Gesamt | 48 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS FRADLEY PARK LIMITED | 20. Juli 2011 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Pier Road BS20 7DZ Portishead Whitehaven Bristol England | United Kingdom | British | |
PEPPER SRM LIMITED | 21. Jan. 2011 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Pier Road Portishead BS20 7DZ Bristol Whitehaven England | United Kingdom | British | |
GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED | 21. Jan. 2011 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Pier Road Portishead BS20 7DZ Bristol Whitehaven | United Kingdom | British | |
COMPUTERSHARE PEP NOMINEES LIMITED | 21. Jan. 2011 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 4 North St. Andrew Street EH2 1HJ Edinburgh Edinburgh House Scotland | United States | British | |
LEGOTLA INVESTMENTS (UK) LIMITED | 21. Jan. 2011 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | The Pavilions Bridgwater Road BS13 8AE Bristol | United Kingdom | British | |
COMPUTERSHARE INVESTMENTS (UK) (NO.4) LIMITED | 21. Jan. 2011 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Pier Road BS20 7DZ Portishead Whitehaven Bristol England | United Kingdom | British | |
PATHBOLD LIMITED | 21. Jan. 2011 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Bridgwater Road BS13 8AE Bristol The Pavilions | United Kingdom | British | |
NRC INVESTMENTS (UK) LIMITED | 21. Jan. 2011 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | The Pavilions Bridgwater Road BS13 8AE Bristol | United Kingdom | British | |
SOURCE ONE COMMUNICATIONS (UK) LIMITED | 21. Jan. 2011 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Pier Road Portishead BS20 7DZ Bristol Whitehaven England | United Kingdom | British | |
COMPUTERSHARE COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | 21. Jan. 2011 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Pier Road BS20 7DZ Portishead Whitehaven Bristol England | United Kingdom | British | |
COMPUTERSHARE INVESTMENTS (UK) (NO.5) LIMITED | 21. Jan. 2011 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | The Pavilions Bridgwater Road BS13 8AE Bristol | United Kingdom | British | |
COMPUTERSHARE (RUSSIA) LIMITED | 21. Jan. 2011 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | The Pavilions Bridgwater Road BS13 8AE Bristol | United Kingdom | British | |
SHAREHOLDER INVESTMENTS RESEARCH LIMITED | 21. Jan. 2011 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Pier Road Portishead BS20 7DZ Bristol Whitehaven England | United Kingdom | British | |
COMPUTERSHARE INVESTMENTS (UK) (NO 6) LIMITED | 21. Jan. 2011 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Bridgewater Road BS13 8AE Bristol The Pavilions | United Kingdom | British | |
COMPUTERSHARE INVESTMENTS (UK) (NO. 8) LIMITED | 15. Dez. 2011 | 01. Sept. 2022 | Aufgelöst | Chartered Accountant | Geschäftsführer | Bridgwater Road BS13 8AE Bristol The Pavilions | England | British |
COMPUTERSHARE ENTITY SOLUTIONS (UK) LIMITED | 21. Jan. 2011 | 01. Sept. 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | The Pavilions Bridgwater Road BS13 8AE Bristol | England | British |
COMPUTERSHARE LIMITED | 21. Jan. 2011 | 01. Juni 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | The Pavilions Bridgwater Road BS13 8AE Bristol | England | British |
COMPUTERSHARE INVESTMENTS (UK) (NO.3) LIMITED | 21. Jan. 2011 | 01. Juni 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Bridgwater Road BS13 8AE Bristol The Pavilions England | England | British |
SETL DEVELOPMENT LIMITED | 17. Jan. 2018 | 03. Dez. 2019 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Bridgwater Road BS13 8AE Bristol The Pavilions United Kingdom | England | British |
COMPUTERSHARE VOUCHER SERVICES LIMITED | 21. Jan. 2011 | 12. Aug. 2019 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Bridgwater Road BS13 8AE Bristol The Pavilions | United States | British |
COMPUTERSHARE IP (UK) LIMITED | 12. Nov. 2018 | 31. Juli 2019 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Bridgwater Road BS13 8AE Bristol The Pavilions United Kingdom | United States | British |
DPS TRUSTEES LIMITED | 01. Dez. 2017 | 31. Juli 2019 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Bridgwater Road BS13 8AE Bristol The Pavilions United Kingdom | United States | British |
COMPUTERSHARE INVESTMENTS (UK) (NO. 9) LIMITED | 24. Feb. 2014 | 31. Juli 2019 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Bridgwater Road BS13 8AE Bristol The Pavilions | United States | British |
COMPUTERSHARE GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES LIMITED | 04. Apr. 2011 | 31. Juli 2019 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Bridgwater Road BS13 8AE Bristol The Pavilions | United States | British |
EES TRUSTEES LIMITED | 04. Apr. 2011 | 31. Juli 2019 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Bridgwater Road BS13 8AE Bristol The Pavilions | United States | British |
EES CAPITAL TRUSTEES LIMITED | 04. Apr. 2011 | 31. Juli 2019 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Bridgwater Road BS13 8AE Bristol The Pavilions | United States | British |
EES CORPORATE TRUSTEES LIMITED | 04. Apr. 2011 | 31. Juli 2019 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Bridgwater Road BS13 8AE Bristol The Pavilions | United States | British |
COMPUTERSHARE INVESTMENTS (UK) (NO.2) LIMITED | 21. Jan. 2011 | 31. Juli 2019 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | The Pavilions Bridgwater Road BS13 8AE Bristol | United States | British |
COMPUTERSHARE INVESTMENTS (UK) LIMITED | 21. Jan. 2011 | 31. Juli 2019 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | The Pavilions Bridgwater Road BS13 8AE Bristol | United States | British |
COMPUTERSHARE REGIONAL SERVICES LIMITED | 21. Jan. 2011 | 31. Juli 2019 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | The Pavilions Bridgwater Road BS13 8AE Bristol | United States | British |
COMPUTERSHARE INVESTMENTS (UK) (NO 7) LIMITED | 21. Jan. 2011 | 31. Juli 2019 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Bridgewater Road BS13 8AE Bristol The Pavilions | United States | British |
COMPUTERSHARE SERVICES NOMINEES LIMITED | 21. Jan. 2011 | 31. Juli 2019 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | 4 North St. Andrew Street EH2 1HJ Edinburgh Edinburgh House Scotland | United States | British |
COMPUTERSHARE TECHNOLOGY SERVICES (UK) LIMITED | 21. Jan. 2011 | 31. Juli 2019 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | The Pavilions Bridgwater Road BS13 8AE Bristol | United States | British |
COMPUTERSHARE TRUSTEES LIMITED | 21. Jan. 2011 | 31. Juli 2019 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | The Pavilions Bridgwater Road BS13 8AE Bristol | United States | British |
COMPUTERSHARE COMPANY NOMINEES LIMITED | 10. Jan. 2011 | 31. Juli 2019 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | 4 North St. Andrew Street EH2 1HJ Edinburgh Edinburgh House Scotland | United States | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0