CVS FRADLEY PARK LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CVS FRADLEY PARK LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02372388 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CVS FRADLEY PARK LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich CVS FRADLEY PARK LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Pavilions Bridgwater Road BS13 8AE Bristol United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CVS FRADLEY PARK LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BUSY BEES FRADLEY PARK LIMITED | 21. Dez. 2006 | 21. Dez. 2006 |
| BUSY BEES CHILDCARE LIMITED | 12. Mai 1998 | 12. Mai 1998 |
| BUSY BEES CONSULTANCY LIMITED | 14. Apr. 1989 | 14. Apr. 1989 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CVS FRADLEY PARK LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CVS FRADLEY PARK LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jochen Braasch als Geschäftsführer am 19. Juli 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2011 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Jonathan Dolbear als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Nazir Sarkar als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Jochen Braasch als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Apr. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2010 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed busy bees fradley park LIMITED\certificate issued on 02/02/11 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Morris als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Morris als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Morris als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Hood als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Nicholas Stuart Robert Oldfield am 15. Apr. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Nicholas Stuart Robert Oldfield am 14. Apr. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2009 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Apr. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CVS FRADLEY PARK LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOTHA, Llewellyn Kevan | Sekretär | Penthouse A, Spring Leigh Church Road, Leigh Woods BS8 3PG Bristol North Somerset | South African | 105560560001 | ||||||
| DOLBEAR, Jonathan | Sekretär | Bridgwater Road BS13 8AE Bristol The Pavilions United Kingdom | 161908740001 | |||||||
| BOTHA, Llewellyn Kevan | Geschäftsführer | Penthouse A, Spring Leigh Church Road, Leigh Woods BS8 3PG Bristol North Somerset | United Kingdom | South African | 105560560001 | |||||
| OLDFIELD, Nicholas Stuart Robert | Geschäftsführer | Holt Greenleigh Farm Holt Limeburn Hill BS40 8QR Chew Magna Greenleigh Farm Bristol England | England | British | 116701010001 | |||||
| SARKAR, Nazir | Geschäftsführer | Pier Road BS20 7DZ Portishead Whitehaven Bristol England | United Kingdom | British | 157131040003 | |||||
| IRONS, Simon Andrew | Sekretär | The Cottage The Grange High Street ST14 8LD Marchington | British | 55976790005 | ||||||
| WOODWARD, Lynn Carol | Sekretär | 75 Upper Way Upper Longdon WS15 1QD Rugeley Staffordshire | British | 3850190003 | ||||||
| ASTON, Ruth | Geschäftsführer | 1 Chestnut Close WS15 4TH Rugeley Staffordshire | British | 83076110001 | ||||||
| BEENE, Sarah Barbara | Geschäftsführer | 15 Galahad Drive Stretton DE13 0GY Burton On Trent Staffordshire | British | 83584430001 | ||||||
| BRAASCH, Jochen | Geschäftsführer | Chandos Woodfield Road, Redland BS6 6PL Bristol 15 England | England | German | 153472260001 | |||||
| DALBY, Joanne Mary | Geschäftsführer | 12 The Green Barton Under Needwood DE13 8JB Burton On Trent Staffordshire | England | British | 83076130001 | |||||
| DONOVAN, Lisa | Geschäftsführer | 43 Morgan Close CV7 8PR New Arley Warwickshire | British | 83076140001 | ||||||
| GALLAGHER, Patrick | Geschäftsführer | Hawden Street 4051 Wilston 21 Queenstown Australia | Australian | 130462890001 | ||||||
| HOOD, James Terence | Geschäftsführer | Redland Road BS6 6YA Bristol 140b Avon United Kingdom | England | British | 189833420001 | |||||
| HORTON, Mathew | Geschäftsführer | Kennedy Terrace 4064 Paddington 50 Queensland Australia | Australian | 130462790001 | ||||||
| IRONS, Simon Andrew | Geschäftsführer | The Cottage The Grange High Street ST14 8LD Marchington | England | British | 55976790005 | |||||
| MORRIS, Christopher John | Geschäftsführer | 608 Spice Quay Heights 32 Shad Thames SE1 2YL London | Australia | Australian | 114812600001 | |||||
| PHIZACKLEA, Clare | Geschäftsführer | 9 Jackson Road WS13 7PR Lichfield Staffordshire | England | British | 42266000001 | |||||
| RANDLES, Margaret Josephine | Geschäftsführer | 222 Beacon Street WS13 7BH Lichfield Staffordshire | England | British | 9070120002 | |||||
| RANDLES, Peter Frederick | Geschäftsführer | 222 Beacon Street WS13 6EN Lichfield Staffordshire | English | 3850170002 | ||||||
| THACKRAY, David Ian | Geschäftsführer | 37 Burton Old Road WS13 6EN Lichfield Staffordshire | British | 9070100001 | ||||||
| THACKRAY, Sally Jane | Geschäftsführer | 37 Burton Old Road WS13 6EN Lichfield Staffordshire | English | 29107050001 | ||||||
| WAUGH, John | Geschäftsführer | Dudley Street 4065 Bardon 35a Queensland Australia | New Zealander | 130463000001 | ||||||
| WOODWARD, John Brian | Geschäftsführer | 75 Upper Way Upper Longdon WS15 1QD Rugeley Staffordshire | England | British | 9070090003 | |||||
| WOODWARD, Lynn Carol | Geschäftsführer | 75 Upper Way Upper Longdon WS15 1QD Rugeley Staffordshire | British | 3850190003 |
Hat CVS FRADLEY PARK LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Erstellt am 08. Juli 2002 Geliefert am 10. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage the l/h property situate and known as land at dera pyestock farnborough hampshire. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Juli 2002 Geliefert am 10. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage the f/h property situate and known as nursery premises st david's park ewloe t/n WA604709. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Juni 2002 Geliefert am 16. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities whatsoever due or to become due from the company to the noteholders or to the chargee (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Juni 2002 Geliefert am 16. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities whatsoever due or to become due from the company to the noteholders or to the chargee (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Juni 2002 Geliefert am 10. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Juni 2000 Geliefert am 12. Juli 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property k/a nursery premises st davids park ewloe flintshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Feb. 2000 Geliefert am 17. Feb. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities of the company to the chargee and the holders from time to time of the notes under or pursuant to a second investor loan note instrument dated 4TH february 2000 constituting fixed rate guaranteed secured loan notes due 2012 (the loan note instrument) including in respect of the notes (as defined) issued pursuant thereto | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Feb. 2000 Geliefert am 17. Feb. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities of the company to the chargee and the holders from time to time of the notes under or pursuant to a first investor loan note instrument dated 4TH february 2000 constituting fixed rate guaranteed secured loan notes due 2012 (the loan note instrument) including in respect of the notes (as defined) issued pursuant thereto | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Feb. 2000 Geliefert am 11. Feb. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of specific security | Erstellt am 01. Mai 1992 Geliefert am 11. Mai 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All monies on any currency standing to to the credit of any accounts designated busy bees LTD/british rail equipment accno 70958836. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Okt. 1990 Geliefert am 24. Okt. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0