CVS FRADLEY PARK LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCVS FRADLEY PARK LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02372388
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CVS FRADLEY PARK LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich CVS FRADLEY PARK LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    The Pavilions
    Bridgwater Road
    BS13 8AE Bristol
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CVS FRADLEY PARK LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BUSY BEES FRADLEY PARK LIMITED21. Dez. 200621. Dez. 2006
    BUSY BEES CHILDCARE LIMITED12. Mai 199812. Mai 1998
    BUSY BEES CONSULTANCY LIMITED14. Apr. 198914. Apr. 1989

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CVS FRADLEY PARK LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für CVS FRADLEY PARK LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beendigung der Bestellung von Jochen Braasch als Geschäftsführer am 19. Juli 2012

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital17. Juli 2012

    Kapitalaufstellung am 17. Juli 2012

    • Kapital: GBP 10,300
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2011

    6 SeitenAA

    Ernennung von Mr Jonathan Dolbear als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Ernennung von Nazir Sarkar als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Jochen Braasch als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Apr. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2010

    13 SeitenAA

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed busy bees fradley park LIMITED\certificate issued on 02/02/11
    3 SeitenCERTNM
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name02. Feb. 2011

    Namensänderung durch Beschluss

    NM01
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 04. Jan. 2011

    RES15

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 13. Jan. 2011

    RES15

    Beendigung der Bestellung von Christopher Morris als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Christopher Morris als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Christopher Morris als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von James Hood als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Nicholas Stuart Robert Oldfield am 15. Apr. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Nicholas Stuart Robert Oldfield am 14. Apr. 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2009

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Apr. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von CVS FRADLEY PARK LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BOTHA, Llewellyn Kevan
    Penthouse A, Spring Leigh
    Church Road, Leigh Woods
    BS8 3PG Bristol
    North Somerset
    Sekretär
    Penthouse A, Spring Leigh
    Church Road, Leigh Woods
    BS8 3PG Bristol
    North Somerset
    South African105560560001
    DOLBEAR, Jonathan
    Bridgwater Road
    BS13 8AE Bristol
    The Pavilions
    United Kingdom
    Sekretär
    Bridgwater Road
    BS13 8AE Bristol
    The Pavilions
    United Kingdom
    161908740001
    BOTHA, Llewellyn Kevan
    Penthouse A, Spring Leigh
    Church Road, Leigh Woods
    BS8 3PG Bristol
    North Somerset
    Geschäftsführer
    Penthouse A, Spring Leigh
    Church Road, Leigh Woods
    BS8 3PG Bristol
    North Somerset
    United KingdomSouth African105560560001
    OLDFIELD, Nicholas Stuart Robert
    Holt
    Greenleigh Farm Holt Limeburn Hill
    BS40 8QR Chew Magna
    Greenleigh Farm
    Bristol
    England
    Geschäftsführer
    Holt
    Greenleigh Farm Holt Limeburn Hill
    BS40 8QR Chew Magna
    Greenleigh Farm
    Bristol
    England
    EnglandBritish116701010001
    SARKAR, Nazir
    Pier Road
    BS20 7DZ Portishead
    Whitehaven
    Bristol
    England
    Geschäftsführer
    Pier Road
    BS20 7DZ Portishead
    Whitehaven
    Bristol
    England
    United KingdomBritish157131040003
    IRONS, Simon Andrew
    The Cottage
    The Grange High Street
    ST14 8LD Marchington
    Sekretär
    The Cottage
    The Grange High Street
    ST14 8LD Marchington
    British55976790005
    WOODWARD, Lynn Carol
    75 Upper Way
    Upper Longdon
    WS15 1QD Rugeley
    Staffordshire
    Sekretär
    75 Upper Way
    Upper Longdon
    WS15 1QD Rugeley
    Staffordshire
    British3850190003
    ASTON, Ruth
    1 Chestnut Close
    WS15 4TH Rugeley
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    1 Chestnut Close
    WS15 4TH Rugeley
    Staffordshire
    British83076110001
    BEENE, Sarah Barbara
    15 Galahad Drive
    Stretton
    DE13 0GY Burton On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    15 Galahad Drive
    Stretton
    DE13 0GY Burton On Trent
    Staffordshire
    British83584430001
    BRAASCH, Jochen
    Chandos
    Woodfield Road, Redland
    BS6 6PL Bristol
    15
    England
    Geschäftsführer
    Chandos
    Woodfield Road, Redland
    BS6 6PL Bristol
    15
    England
    EnglandGerman153472260001
    DALBY, Joanne Mary
    12 The Green
    Barton Under Needwood
    DE13 8JB Burton On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    12 The Green
    Barton Under Needwood
    DE13 8JB Burton On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritish83076130001
    DONOVAN, Lisa
    43 Morgan Close
    CV7 8PR New Arley
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    43 Morgan Close
    CV7 8PR New Arley
    Warwickshire
    British83076140001
    GALLAGHER, Patrick
    Hawden Street
    4051
    Wilston
    21
    Queenstown
    Australia
    Geschäftsführer
    Hawden Street
    4051
    Wilston
    21
    Queenstown
    Australia
    Australian130462890001
    HOOD, James Terence
    Redland Road
    BS6 6YA Bristol
    140b
    Avon
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Redland Road
    BS6 6YA Bristol
    140b
    Avon
    United Kingdom
    EnglandBritish189833420001
    HORTON, Mathew
    Kennedy Terrace
    4064
    Paddington
    50
    Queensland
    Australia
    Geschäftsführer
    Kennedy Terrace
    4064
    Paddington
    50
    Queensland
    Australia
    Australian130462790001
    IRONS, Simon Andrew
    The Cottage
    The Grange High Street
    ST14 8LD Marchington
    Geschäftsführer
    The Cottage
    The Grange High Street
    ST14 8LD Marchington
    EnglandBritish55976790005
    MORRIS, Christopher John
    608 Spice Quay Heights
    32 Shad Thames
    SE1 2YL London
    Geschäftsführer
    608 Spice Quay Heights
    32 Shad Thames
    SE1 2YL London
    AustraliaAustralian114812600001
    PHIZACKLEA, Clare
    9 Jackson Road
    WS13 7PR Lichfield
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    9 Jackson Road
    WS13 7PR Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritish42266000001
    RANDLES, Margaret Josephine
    222 Beacon Street
    WS13 7BH Lichfield
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    222 Beacon Street
    WS13 7BH Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritish9070120002
    RANDLES, Peter Frederick
    222 Beacon Street
    WS13 6EN Lichfield
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    222 Beacon Street
    WS13 6EN Lichfield
    Staffordshire
    English3850170002
    THACKRAY, David Ian
    37 Burton Old Road
    WS13 6EN Lichfield
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    37 Burton Old Road
    WS13 6EN Lichfield
    Staffordshire
    British9070100001
    THACKRAY, Sally Jane
    37 Burton Old Road
    WS13 6EN Lichfield
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    37 Burton Old Road
    WS13 6EN Lichfield
    Staffordshire
    English29107050001
    WAUGH, John
    Dudley Street
    4065
    Bardon
    35a
    Queensland
    Australia
    Geschäftsführer
    Dudley Street
    4065
    Bardon
    35a
    Queensland
    Australia
    New Zealander130463000001
    WOODWARD, John Brian
    75 Upper Way
    Upper Longdon
    WS15 1QD Rugeley
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    75 Upper Way
    Upper Longdon
    WS15 1QD Rugeley
    Staffordshire
    EnglandBritish9070090003
    WOODWARD, Lynn Carol
    75 Upper Way
    Upper Longdon
    WS15 1QD Rugeley
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    75 Upper Way
    Upper Longdon
    WS15 1QD Rugeley
    Staffordshire
    British3850190003

    Hat CVS FRADLEY PARK LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 08. Juli 2002
    Geliefert am 10. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the l/h property situate and known as land at dera pyestock farnborough hampshire. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Juli 2002
    Geliefert am 10. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the f/h property situate and known as nursery premises st david's park ewloe t/n WA604709. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. Juni 2002
    Geliefert am 16. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities whatsoever due or to become due from the company to the noteholders or to the chargee (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Stuart and Sarah Carr
    Transaktionen
    • 16. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. Juni 2002
    Geliefert am 16. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities whatsoever due or to become due from the company to the noteholders or to the chargee (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Gresham Trust PLC
    Transaktionen
    • 16. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. Juni 2002
    Geliefert am 10. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Juni 2000
    Geliefert am 12. Juli 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a nursery premises st davids park ewloe flintshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 12. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 04. Feb. 2000
    Geliefert am 17. Feb. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities of the company to the chargee and the holders from time to time of the notes under or pursuant to a second investor loan note instrument dated 4TH february 2000 constituting fixed rate guaranteed secured loan notes due 2012 (the loan note instrument) including in respect of the notes (as defined) issued pursuant thereto
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The South Place Gresham Partnership 2000 (The Trustee)(a Limited Partnership Acting by Its Manager Gresham Trust PLC)
    Transaktionen
    • 17. Feb. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 04. Feb. 2000
    Geliefert am 17. Feb. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities of the company to the chargee and the holders from time to time of the notes under or pursuant to a first investor loan note instrument dated 4TH february 2000 constituting fixed rate guaranteed secured loan notes due 2012 (the loan note instrument) including in respect of the notes (as defined) issued pursuant thereto
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The South Place Gresham Partnership 2000 (The Trustee)(a Limited Partnership Acting by Its Manager Gresham Trust PLC)
    Transaktionen
    • 17. Feb. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 04. Feb. 2000
    Geliefert am 11. Feb. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 11. Feb. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of specific security
    Erstellt am 01. Mai 1992
    Geliefert am 11. Mai 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All monies on any currency standing to to the credit of any accounts designated busy bees LTD/british rail equipment accno 70958836.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Mai 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Dez. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 04. Okt. 1990
    Geliefert am 24. Okt. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 24. Okt. 1990Registrierung einer Belastung
    • 04. Dez. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0