Vanda MURRAY
Natürliche Person
| Titel | Mrs |
|---|---|
| Vorname | Vanda |
| Nachname | MURRAY |
| Geburtsdatum | |
| Ist Unternehmensleiter | Nein |
| Ernennungen | |
| Aktiv | 5 |
| Inaktiv | 2 |
| Zurückgetreten | 28 |
| Gesamt | 35 |
Ernennungen
| Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGLISH NATIONAL OPERA | 26. Feb. 2026 | Aktiv | Geschäftsführer | London Coliseum St Martins Lane WC2N 4ES London | England | British | ||
| HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 01. Feb. 2024 | Aktiv | Geschäftsführer | Wigmore Street W1U 1QY London 105 England | England | British | ||
| YORKSHIRE WATER SERVICES LIMITED | 01. Juli 2021 | Aktiv | Geschäftsführer | Western House Halifax Road BD6 2SZ Bradford West Yorkshire | England | British | ||
| KELDA EUROBOND CO LIMITED | 01. Juli 2021 | Aktiv | Geschäftsführer | Halifax Road BD6 2SZ Bradford Western House West Yorkshire | England | British | ||
| MARSHALLS PLC | 09. Mai 2018 | Aktiv | Geschäftsführer | Premier Way Lowfields Business Park HX5 9HT Elland Landscape House West Yorkshire | England | British | ||
| VPHASE SMART ENERGY LIMITED | 23. Nov. 2010 | Aufgelöst | Geschäftsführer | c/o Atticus Legal Llp Liverpool Road Castlefield M3 4SB Manchester Castlefield House Greater Manchester England | England | British | ||
| VANDA MURRAY ASSOCIATES LIMITED | 08. Apr. 2005 | Aufgelöst | Geschäftsführer | 10 Westminster Road SK10 1BX Macclesfield Westminster House Cheshire United Kingdom | England | British | ||
| THE GROWTH COMPANY LIMITED | 12. Feb. 2015 | 17. Sept. 2024 | Aktiv | Geschäftsführer | Lee House 90,Great Bridgewater Street M1 5JW Manchester | England | British | |
| BUNZL PUBLIC LIMITED COMPANY | 01. Feb. 2015 | 24. Apr. 2024 | Aktiv | Geschäftsführer | York House 45 Seymour Street W1H 7JT London Bunzl Plc United Kingdom | England | British | |
| MANCHESTER AIRPORTS HOLDINGS LIMITED | 28. Feb. 2013 | 31. März 2024 | Aktiv | Geschäftsführer | Floor Olympic House Manchester Airport M90 1QX Manchester 6th Greater Manchester United Kingdom | England | British | |
| MGF LIMITED | 09. Juni 2014 | 30. Juni 2021 | Aktiv | Geschäftsführer | Grant House Lockett Road WN4 8DE Ashton In Makerfield Mgf Ltd Lancashire England | England | British | |
| JUST CHILDCARE HOLDINGS LIMITED | 05. Nov. 2015 | 02. Juni 2021 | Aktiv | Geschäftsführer | Progress Way Denton M34 2GP Manchester Ridgway House England | England | British | |
| REDROW LIMITED | 01. Aug. 2017 | 06. Nov. 2020 | Aktiv | Geschäftsführer | St. Davids Park CH5 3RX Ewloe Redrow House Flintshire United Kingdom | England | British | |
| FENNER GROUP HOLDINGS LIMITED | 11. Jan. 2012 | 31. Mai 2018 | Aktiv | Geschäftsführer | Hesslewood Country Office Park Ferriby Road HU13 0PW Hessle East Yorkshire | England | British | |
| EXOVA GROUP LIMITED | 16. Apr. 2014 | 29. Juni 2017 | Aktiv | Geschäftsführer | Centenary Park Eccles M50 1RE Salford 6 Coronet Way Manchester United Kingdom | England | British | |
| APTITUDE SOFTWARE GROUP PLC | 01. Sept. 2011 | 18. Juli 2016 | Aktiv | Geschäftsführer | 128 Queen Victoria Street EC4V 4BJ London Old Change House England | England | British | |
| CHEMRING GROUP PLC | 01. Nov. 2011 | 19. März 2015 | Aktiv | Geschäftsführer | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | England | British | |
| CARILLION PLC | 01. Juni 2005 | 07. Mai 2014 | Liquidation | Geschäftsführer | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | England | British | |
| PREFCAP LIMITED | 07. Juli 2010 | 20. Sept. 2013 | Aufgelöst | Geschäftsführer | Cross Street M2 4JU Manchester Steam Packet House 76 | England | British | |
| TRILOGY LOGISTICS REIT LIMITED | 11. Feb. 2010 | 28. Feb. 2013 | Aktiv | Geschäftsführer | c/o The Manchester Airport Group Plc Floor Olympic House Manchester Airport M90 1QX Manchester 6th Greater Manchester England | England | British | |
| NORTHWEST BUSINESS LINK | 02. Feb. 2009 | 30. März 2012 | Aufgelöst | Geschäftsführer | SK10 | England | British | |
| SIG PLC | 01. Juli 2009 | 16. März 2011 | Aktiv | Geschäftsführer | 17 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Signet House United Kingdom | England | British | |
| EAZYFONE LIMITED | 01. Feb. 2007 | 31. Dez. 2009 | Aufgelöst | Geschäftsführer | 12 Betchworth Way SK10 2PA Tytherington Macclesfield Cheshire | England | British | |
| TMI ENTERPRISES LIMITED | 19. Mai 2006 | 30. Apr. 2007 | Aufgelöst | Geschäftsführer | SK10 | England | British | |
| THE MANUFACTURING INSTITUTE | 13. Juni 2002 | 30. Apr. 2007 | Aufgelöst | Geschäftsführer | 12 Betchworth Way SK10 2PA Tytherington Macclesfield Cheshire | England | British | |
| ULTRAFRAME (UK) LIMITED | 01. Sept. 2004 | 10. Juli 2006 | Aktiv | Geschäftsführer | 12 Betchworth Way SK10 2PA Tytherington Macclesfield Cheshire | England | British | |
| ULTRAFRAME LIMITED | 18. Jan. 2002 | 10. Juli 2006 | Aufgelöst | Geschäftsführer | 12 Betchworth Way SK10 2PA Tytherington Macclesfield Cheshire | England | British | |
| TPMI (TRADING) LIMITED | 26. Nov. 2004 | 19. Mai 2006 | Aufgelöst | Geschäftsführer | SK10 | England | British | |
| BLICK GROUP MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 30. Juni 2003 | 31. Juli 2004 | Aktiv | Geschäftsführer | 12 Betchworth Way SK10 2PA Tytherington Macclesfield Cheshire | England | British | |
| SECURITAS TECHNOLOGY OPERATIONS LIMITED | 22. Okt. 2001 | 31. Juli 2004 | Aufgelöst | Geschäftsführer | 12 Betchworth Way SK10 2PA Tytherington Macclesfield Cheshire | England | British | |
| PARKARE LIMITED | 09. Mai 2001 | 31. Juli 2004 | Aktiv | Geschäftsführer | 12 Betchworth Way SK10 2PA Tytherington Macclesfield Cheshire | England | British | |
| STANLEY SECURITY SOLUTIONS - EUROPE LIMITED | 02. Juni 1999 | 31. Juli 2004 | Aktiv | Geschäftsführer | 12 Betchworth Way SK10 2PA Tytherington Macclesfield Cheshire | England | British | |
| SNEDDON LIMITED | 06. Nov. 1996 | 31. Juli 2004 | Aktiv | Geschäftsführer | 12 Betchworth Way SK10 2PA Tytherington Macclesfield Cheshire | England | British | |
| PAC INTERNATIONAL LIMITED | 21. März 1996 | 31. Juli 2004 | Aktiv | Geschäftsführer | 12 Betchworth Way SK10 2PA Tytherington Macclesfield Cheshire | England | British | |
| SECURITAS TECHNOLOGY OPERATIONS LIMITED | 01. Okt. 1998 | 09. Nov. 1999 | Aufgelöst | Geschäftsführer | Allenwood Wood Lane South Adlington SK10 4PJ Macclesfield Cheshire | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0