ULTRAFRAME LIMITED
Überblick
Unternehmensname | ULTRAFRAME LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03330992 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ULTRAFRAME LIMITED?
- Sonstige Herstellung n.e.c. (32990) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich ULTRAFRAME LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o INQUESTA CORPORATE RECOVERY & INSOLVENCY 11-15 New Road M26 1LS Manchester |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ULTRAFRAME LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
ULTRAFRAME PLC | 12. Sept. 1997 | 12. Sept. 1997 |
ULTRAFRAME GROUP LIMITED | 26. März 1997 | 26. März 1997 |
VIRTUALCHOICE LIMITED | 10. März 1997 | 10. März 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ULTRAFRAME LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Okt. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ULTRAFRAME LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 10 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Enterprise Works Salthill Road Clitheroe Lancashire BB7 1PE zum C/O Inquesta Corporate Recovery & Insolvency 11-15 New Road Manchester M26 1LS am 02. Feb. 2017 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 4 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jonathon Steven Kennedy als Geschäftsführer am 09. Dez. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jordan Robert Kennedy als Geschäftsführer am 09. Dez. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Patrick Brian Kennedy als Geschäftsführer am 09. Dez. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Okt. 2015 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David John Challinor als Geschäftsführer am 30. Sept. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Okt. 2014 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 01. Nov. 2013 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 02. Nov. 2012 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Jonathon Steven Kennedy als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Jordan Robert Kennedy als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Patrick Brian Kennedy als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. März 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Julian Slade als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Iain Thomson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ULTRAFRAME LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLADE, Julian | Geschäftsführer | c/o Inquesta Corporate Recovery & Insolvency New Road M26 1LS Manchester 11-15 | England | British | Managing Director | 120063840001 | ||||
HENRY, James Martin | Sekretär | 27 Bradyll Court Brockhall Village, Old Langho BB6 8AS Blackburn Lancashire | British | Director | 60401500002 | |||||
LEES, Stuart | Sekretär | Springfield Macclesfield Road SK9 7BW Alderley Edge Cheshire | British | Company Director | 70032700001 | |||||
MOORE, David Alan | Sekretär | 5 Hayhurst Road BB7 9RL Whalley Lancashire | British | Finanace Director | 33832050001 | |||||
SMETHURST, Edward Gerald | Sekretär | Ashworth Brook Farm Meadow Head Lane Norden OL11 5UL Rochdale Lancashire | British | Company Director | 86741880001 | |||||
SMETHURST, Edward Gerald | Sekretär | Ashworth Brook Farm Meadow Head Lane Norden OL11 5UL Rochdale Lancashire | British | 86741880001 | ||||||
BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester | 900001550001 | |||||||
BROGAN, Bernard Desmond | Geschäftsführer | Blakeley Lodge Egginton Road Etwall DE65 6NQ Derby Derbyshire | England | British | Director | 70252730001 | ||||
CHALLINOR, David John | Geschäftsführer | Enterprise Works Salthill Road BB7 1PE Clitheroe Lancashire | United Kingdom | British | Finance Director | 138870170001 | ||||
EDWARDS, Robert Millner | Geschäftsführer | Sunnyfields West Bradford Road Waddington BB7 3JD Clitheroe Lancashire | British | Company Director | 45357650001 | |||||
EWING, David Leslie | Geschäftsführer | 1707 East Lake Drive Elkhart Indiana 46514 Usa | Usa | Director | 70903540001 | |||||
GALE, Paul Nicolas | Geschäftsführer | Meadow Head Farm Hothersall Lane PR3 2XB Longridge | England | British | Director | 147357260001 | ||||
GREENHALGH, Donald | Geschäftsführer | The Hayricks Bolton Road PR6 9HN Anderton Lancashire | British | Director | 47084170002 | |||||
HENRY, James Martin | Geschäftsführer | 27 Bradyll Court Brockhall Village, Old Langho BB6 8AS Blackburn Lancashire | British | Director | 60401500002 | |||||
KENNEDY, Brian George | Geschäftsführer | Swettenham Hall Swettenham CW12 2JZ Congleton Cheshire | England | British | Company Director | 4067600009 | ||||
KENNEDY, Jonathon Steven | Geschäftsführer | Enterprise Works Salthill Road BB7 1PE Clitheroe Lancashire | England | British | Company Director | 178618610001 | ||||
KENNEDY, Jordan Robert | Geschäftsführer | Enterprise Works Salthill Road BB7 1PE Clitheroe Lancashire | England | British | Asset Manager | 172748380001 | ||||
KENNEDY, Patrick Brian | Geschäftsführer | Enterprise Works Salthill Road BB7 1PE Clitheroe Lancashire | England | British | Director | 178608980001 | ||||
KIRK, Adrian Christopher | Geschäftsführer | Enterprise Works Salthill Road BB7 1PE Clitheroe Lancashire | England | British | Finance Director | 93313700001 | ||||
LANCASTER, John Edward | Geschäftsführer | Throstle Nest Farm Edisford Road BB7 2LN Clitheroe Lancashire | United Kingdom | British | Director | 5686840001 | ||||
LANCASTER, Rosemary | Geschäftsführer | Throstle Nest Farm Edisford Road BB7 2LN Clitheroe Lancashire | United Kingdom | British | Director | 5686830001 | ||||
LEES, Stuart | Geschäftsführer | Springfield Macclesfield Road SK9 7BW Alderley Edge Cheshire | England | British | Company Director | 70032700001 | ||||
MOORE, David Alan | Geschäftsführer | Barn 1 Chadswell Hall Chipping Road BB7 3LT Chaigley Nr Clitheroe Lancashire | British | Director | 33832050003 | |||||
MURRAY, Vanda | Geschäftsführer | 12 Betchworth Way SK10 2PA Tytherington Macclesfield Cheshire | England | British | Director | 47527140003 | ||||
RICHARDSON, Christopher | Geschäftsführer | 9 Gleneagles Drive Brockhall Village, Old Langho BB6 8BF Blackburn Lancashire | British | Director | 118281410001 | |||||
ROBINSON, Ian | Geschäftsführer | Plantation House Chipping Road Chaigley BB7 3LX Clitheroe Lancashire | British | Director | 48812210002 | |||||
ROTHWELL, Alan George | Geschäftsführer | Foxpond 26 Field Lane Appleton WA4 5JR Warrington Cheshire | British | Director | 81871470002 | |||||
SCOTT, Richard John | Geschäftsführer | Mill Road SL7 1QB Marlow Fulshaw Court Buckinghamshire | England | British | Director | 139713290001 | ||||
SELLERS, Rodney Horrocks | Geschäftsführer | Stonecroft 3 Lostock Junction Lane Lostock BL6 4JR Bolton Lancashire | England | English | Director | 53752390002 | ||||
STOCK, Bryan | Geschäftsführer | The Coach House 10 Shepley Road B45 8JW Barnt Green Worcestershire | United Kingdom | British | Company Director | 73942950002 | ||||
THOMSON, Iain | Geschäftsführer | Cross Lane SK9 2DB Wilmslow 1 Glen Cottage Cheshire | United Kingdom | British | Director | 130316490001 | ||||
WALLIS, Daren Johnathan | Geschäftsführer | Castleford Drive Prestbury SK10 4BG Macclesfield 11 Cheshire | United Kingdom | British | Director | 128094920001 | ||||
DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester | 900001540001 |
Hat ULTRAFRAME LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 16. Jan. 2012 Geliefert am 25. Jan. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 14. Nov. 2006 Geliefert am 24. Nov. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 14. Juli 2006 Geliefert am 28. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or the parent to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge | Erstellt am 06. Dez. 2005 Geliefert am 12. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All f/h and l/h property first fixed charge all present and future f/h or l/h property and any rights under any licence or other agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement between the chargor, ever 1508 limited, ever 1509 limited and the facility agent | Erstellt am 25. Juni 2001 Geliefert am 10. Juli 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of the chargor to any secured party under each finance document to which the chargor is a party | |
Kurze Angaben The chargor as security charged all of its assets by way of first floating charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat ULTRAFRAME LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0