Keith James Anthony BROWNER - Seite 2
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | Keith |
Zweites Vornamen | James Anthony |
Nachname | BROWNER |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 3 |
Inaktiv | 2 |
Zurückgetreten | 63 |
Gesamt | 68 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELYSIUM HEALTHCARE (GREGORY HOUSE) LIMITED | 01. Mai 2019 | 31. Mai 2023 | Aktiv | Chief Financial Officer | Geschäftsführer | Imperial Place Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British |
STANLEY HOUSE LIMITED | 01. Mai 2019 | 31. Mai 2023 | Aktiv | Chief Financial Officer | Geschäftsführer | Imperial Place Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British |
LONDON CARE PARTNERSHIP (SUPPORTED LIVING) LIMITED | 01. Mai 2019 | 31. Mai 2023 | Aktiv | Chief Financial Officer | Geschäftsführer | Imperial Place Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British |
ELYSIUM HEALTHCARE NO. 3 LIMITED | 01. Mai 2019 | 31. Mai 2023 | Aktiv | Chief Financial Officer | Geschäftsführer | Imperial Place Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British |
ELYSIUM HEALTHCARE HOLDINGS 3 LIMITED | 01. Mai 2019 | 31. Mai 2023 | Aktiv | Chief Financial Officer | Geschäftsführer | Imperial Place Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British |
LIGHTHOUSE HEALTHCARE GROUP LIMITED | 01. Mai 2019 | 31. Mai 2023 | Aktiv | Chief Financial Officer | Geschäftsführer | Imperial Place Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British |
FOCUS ON CARE RECRUITMENT LIMITED | 01. Mai 2019 | 31. Mai 2023 | Aktiv | Chief Financial Officer | Geschäftsführer | Imperial Place Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British |
ELYSIUM HEALTHCARE PROPERTY 1 LIMITED | 01. Mai 2019 | 31. Mai 2023 | Aktiv | Chief Financial Officer | Geschäftsführer | Imperial Place Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British |
ELYSIUM HEALTHCARE PROPERTY 5 LIMITED | 01. Mai 2019 | 31. Mai 2023 | Aktiv | Chief Financial Officer | Geschäftsführer | Imperial Place Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British |
DARLINGTON NEUROLOGICAL CARE CENTRE LTD | 01. Mai 2019 | 31. Mai 2023 | Aktiv | Chief Financial Officer | Geschäftsführer | Imperial Place Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British |
ELYSIUM HEALTHCARE PROPERTY 6 LIMITED | 01. Mai 2019 | 31. Mai 2023 | Aktiv | Chief Financial Officer | Geschäftsführer | Imperial Place Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British |
ELYSIUM HEALTHCARE NO. 2 LIMITED | 01. Mai 2019 | 31. Mai 2023 | Aktiv | Chief Financial Officer | Geschäftsführer | Imperial Place Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British |
ELYSIUM HEALTHCARE LC LIMITED | 01. Mai 2019 | 31. Mai 2023 | Aktiv | Chief Financial Officer | Geschäftsführer | Imperial Place Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British |
CELTIC RESOURCE MANAGEMENT LIMITED | 01. Mai 2019 | 31. Mai 2023 | Aktiv | Chief Financial Officer | Geschäftsführer | Imperial Place Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British |
ELYSIUM HEALTHCARE PROPERTY 7 LIMITED | 01. Mai 2019 | 31. Mai 2023 | Aktiv | Chief Financial Officer | Geschäftsführer | Imperial Place Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British |
ELYSIUM HEALTHCARE (ST MARY'S) LIMITED | 01. Mai 2019 | 31. Mai 2023 | Aktiv | Chief Financial Officer | Geschäftsführer | Imperial Place Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British |
ELYSIUM HEALTHCARE (ANN HOUSE) LIMITED | 01. Mai 2019 | 31. Mai 2023 | Aktiv | Chief Financial Officer | Geschäftsführer | Imperial Place Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British |
ELYSIUM HEALTHCARE (PHOENIX) LIMITED | 01. Mai 2019 | 31. Mai 2023 | Aktiv | Chief Financial Officer | Geschäftsführer | Imperial Place Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British |
ELYSIUM NEUROLOGICAL SERVICES (BADBY) LIMITED | 01. Mai 2019 | 31. Mai 2023 | Aktiv | Chief Financial Officer | Geschäftsführer | Imperial Place Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British |
ELYSIUM HEALTHCARE (LIGHTHOUSE) LIMITED | 01. Mai 2019 | 31. Mai 2023 | Aktiv | Chief Financial Officer | Geschäftsführer | Imperial Place Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British |
VALOUR HOLDCO LIMITED | 29. Nov. 2017 | 26. Sept. 2018 | Liquidation | Finance Director | Geschäftsführer | Eurogate Business Park TN24 8XW Ashford Unit 2 Kent United Kingdom | England | British |
FRIARS 662 LIMITED | 29. Nov. 2017 | 26. Sept. 2018 | Aktiv | Finance Director | Geschäftsführer | Eurogate Business Park TN24 8XW Ashford Unit 2 Kent United Kingdom | England | British |
NURSE PLUS AND CARER PLUS (UK) LIMITED | 29. Nov. 2017 | 26. Sept. 2018 | Aktiv | Finance Director | Geschäftsführer | Eurogate Business Park TN24 8XW Ashford Unit 2 Kent United Kingdom | England | British |
VALOUR MIDCO I LIMITED | 29. Nov. 2017 | 26. Sept. 2018 | Liquidation | Finance Director | Geschäftsführer | Eurogate Business Park TN24 8XW Ashford Unit 2 Kent United Kingdom | England | British |
VALOUR MIDCO II LIMITED | 29. Nov. 2017 | 26. Sept. 2018 | Liquidation | Finance Director | Geschäftsführer | Eurogate Business Park TN24 8XW Ashford Unit 2 Kent United Kingdom | England | British |
MALLING HEALTH LIMITED | 06. Feb. 2015 | 01. Juni 2015 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | 70 Churchill Square ME19 4YU Kings Hill Suite 14 Kent | England | British |
MALLING HEALTH (UK) LIMITED | 06. Feb. 2015 | 01. Juni 2015 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | 70 Churchill Square ME19 4YU Kings Hill Suite 14 Kent | England | British |
MALLING HEALTH PRACTICE SUPPORT LIMITED | 06. Feb. 2015 | 01. Juni 2015 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 70 Churchill Square Kings Hill ME19 4YU West Malling Suite 14 Kent England | England | British |
ECCLES MIDCO II LIMITED | 15. Jan. 2015 | 01. Juni 2015 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 14 New Wharf Road N1 9RT London Ground Floor United Kingdom | England | British |
ECCLES MIDCO LIMITED | 15. Jan. 2015 | 01. Juni 2015 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 14 New Wharf Road N1 9RT London Ground Floor England | England | British |
ECCLES BIDCO LIMITED | 15. Jan. 2015 | 01. Juni 2015 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 14 New Wharf Road N1 9RT London Ground Floor England | England | British |
ECCLES GROUP LIMITED | 15. Jan. 2015 | 01. Juni 2015 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 14 New Wharf Road N1 9RT London Ground Floor England | England | British |
ECCLES BIDCO II LIMITED | 15. Jan. 2015 | 01. Juni 2015 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 14 New Wharf Road N1 9RT London Ground Floor United Kingdom | England | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0