• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Nicholas John DUNCALF

    Natürliche Person

    TitelMr
    VornameNicholas
    Zweites VornamenJohn
    NachnameDUNCALF
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv0
    Inaktiv0
    Zurückgetreten29
    Gesamt29

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    NET-TEX TRADING LIMITED22. Dez. 201130. Sept. 2022AktivAccountantGeschäftsführer
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Hillcrest
    Staffordshire
    Uk
    BritishBritish
    RUMENCO LIMITED08. Jan. 201030. Sept. 2022AktivAccountantGeschäftsführer
    Stretton House, Derby Road
    Stretton
    DE13 0DW Burton On Trent
    Staffordshire
    BritishBritish
    SJC 125 LIMITED08. Jan. 201030. Sept. 2022AktivAccountantGeschäftsführer
    Stretton House
    Derby Road
    DE13 0DW Burton On Trent
    Staffordshire
    BritishBritish
    SJC 126 LIMITED08. Jan. 201030. Sept. 2022AktivAccountantGeschäftsführer
    Stretton House
    Stretton
    DE13 0DW Burton On Trent
    Staffordshire
    BritishBritish
    AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES HEAT LIMITED06. Juni 200530. Sept. 2009AktivAccountantSekretär
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES HEAT LIMITED06. Juni 200530. Sept. 2009AktivAccountantGeschäftsführer
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    BritishBritish
    AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES LIMITED06. Juni 200530. Sept. 2009AktivAccountantSekretär
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES LIMITED06. Juni 200530. Sept. 2009AktivAccountantGeschäftsführer
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    BritishBritish
    AIMT UK LTD03. Nov. 200830. Sept. 2009AufgelöstAccountantSekretär
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    ACORN NISIL LIMITED06. Juni 200530. Sept. 2009AufgelöstAccountantSekretär
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    IONTEC LIMITED06. Juni 200530. Sept. 2009AufgelöstAccountantSekretär
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    ACORN I.V.D. LIMITED06. Juni 200530. Sept. 2009AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    BritishBritish
    RIVAVIEW LIMITED06. Juni 200530. Sept. 2009AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    BritishBritish
    NISIL HOLDINGS LIMITED06. Juni 200530. Sept. 2009AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    BritishBritish
    RIVAVIEW LIMITED06. Juni 200530. Sept. 2009AufgelöstAccountantSekretär
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    NISIL HOLDINGS LIMITED06. Juni 200530. Sept. 2009AufgelöstAccountantSekretär
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    ACORN NISIL LIMITED06. Juni 200530. Sept. 2009AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    BritishBritish
    IONTEC LIMITED06. Juni 200530. Sept. 2009AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    BritishBritish
    ACORN I.V.D. LIMITED06. Juni 200530. Sept. 2009AufgelöstAccountantSekretär
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    WISEFARE LIMITED06. Juni 200530. Sept. 2009AufgelöstAccountantSekretär
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    WISEFARE LIMITED06. Juni 200530. Sept. 2009AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    BritishBritish
    SENIOR HEAT TREATMENT LIMITED06. Juni 200530. Sept. 2009AufgelöstAccountantSekretär
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    SENIOR HEAT TREATMENT LIMITED06. Juni 200530. Sept. 2009AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    BritishBritish
    NITRIDING SERVICES LIMITED06. Juni 200530. Sept. 2009AufgelöstAccountantSekretär
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    NITRIDING SERVICES LIMITED06. Juni 200530. Sept. 2009AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    BritishBritish
    NITRIDING SERVICES (HOLDINGS) LIMITED06. Juni 200530. Sept. 2009AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    BritishBritish
    NITRIDING SERVICES (HOLDINGS) LIMITED06. Juni 200530. Sept. 2009AufgelöstAccountantSekretär
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    JP&S UNLIMITED30. Mai 1997AktivSekretär
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    JP&S UNLIMITED30. Mai 1997AktivDirectorGeschäftsführer
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    BritishBritish

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0