NITRIDING SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | NITRIDING SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02406009 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NITRIDING SERVICES LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich NITRIDING SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 39-43 Bilton Way Luton LU1 1UU Bedfordshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von NITRIDING SERVICES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| THERMO CHEMICAL TREATMENTS LIMITED | 07. Nov. 1989 | 07. Nov. 1989 |
| INGLEBY (429) LIMITED | 19. Juli 1989 | 19. Juli 1989 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NITRIDING SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für NITRIDING SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Jan. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Miss Denise Osborn als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicholas Duncalf als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicholas Duncalf als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Dell als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2004 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2003 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von NITRIDING SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSBORN, Denise | Sekretär | 39-43 Bilton Way Luton LU1 1UU Bedfordshire | 146124880001 | |||||||
| JAEGER, Oliver | Geschäftsführer | Mettmann Germany | Germany | German | 138189510001 | |||||
| ASHTON, David John | Sekretär | Oak Cottage 27 Church Road, Lilleshall TF10 9HE Newport Salop | British | 24459630003 | ||||||
| DUNCALF, Nicholas John | Sekretär | 5 Sandon Avenue Westlands ST5 3QB Newcastle Under Lyme Staffordshire | British | 148208420001 | ||||||
| KNIGHTS, John Ivan | Sekretär | The Haven 4 Berberry Drive MK45 5ER Flitton Bedfordshire | British | 126545670001 | ||||||
| POLLAK, David Arthur | Sekretär | 40 The Gardens WD17 3DW Watford Hertfordshire | British | 64234590001 | ||||||
| ASHTON, David John | Geschäftsführer | Oak Cottage 27 Church Road, Lilleshall TF10 9HE Newport Salop | England | British | 24459630003 | |||||
| BACON, Nicholas Andrew William | Geschäftsführer | Shaftesbury House Clover Hill Old Warwick Road, Lapworth B94 6JY Solihull West Midlands | United Kingdom | British | 159081540001 | |||||
| BAUMANN, Christopher John | Geschäftsführer | 31 Old Slade Lane SL0 9DY Richings Park Buckinghamshire | United Kingdom | British | 102220130001 | |||||
| BUSTER, Richard Geoffrey | Geschäftsführer | 58 Mount Road Tettenhall Wood WV6 8HQ Wolverhampton West Midlands | England | British | 4325580001 | |||||
| DELL, Stephen John | Geschäftsführer | 55 Bucklow Gardens WA13 9RN Lymm Cheshire | British | 124021740001 | ||||||
| DUNCALF, Nicholas John | Geschäftsführer | 5 Sandon Avenue Westlands ST5 3QB Newcastle Under Lyme Staffordshire | British | British | 148208420001 | |||||
| EALES, Darryl Charles | Geschäftsführer | 7 Sycamore Drive Hollywood B47 5QX Birmingham West Midlands | United Kingdom | British | 2886080001 | |||||
| HEAP, William John | Geschäftsführer | Alameda Keepers Lane Codsall WV8 2DP Wolverhampton West Midlands | British | 24459640001 | ||||||
| KNIGHTS, John Ivan | Geschäftsführer | The Haven 4 Berberry Drive MK45 5ER Flitton Bedfordshire | British | 126545670001 | ||||||
| LEEK, Peter William | Geschäftsführer | Tintagel 119 Broad Lane WV3 9BP Wolverhampton West Midlands | British | 10939100001 | ||||||
| LEEKE, Graham Maurice | Geschäftsführer | The Grove Tachbrook Mallory CV33 9QE Leamington Spa Warwickshire | British | 29510450001 | ||||||
| ROBINSON, Kevin | Geschäftsführer | 34 Winster Avenue Dorridge B93 8ST Solihull West Midlands | British | 61267640001 | ||||||
| SHARP, Keith | Geschäftsführer | Harewood House 4 Spa Crescent TF5 0DH Admaston Shropshire | England | British | 77395770001 | |||||
| STAINES, Anthony Martin, Doctor | Geschäftsführer | 10 Carmichael Close WS14 9YW Lichfield Staffordshire | British | 57218330001 |
Hat NITRIDING SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 24. Feb. 1999 Geliefert am 27. Feb. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of rental deposit | Erstellt am 06. Nov. 1997 Geliefert am 08. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £40,000 together with interest thereon due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The deposit of £40,000. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 26. Sept. 1995 Geliefert am 17. Okt. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 15 february 1994 or under the chattel mortgage | |
Kurze Angaben Nitrex gas nitriding system with serial no.be-5078 including various constituant parts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 17. Jan. 1991 Geliefert am 30. Jan. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Factory and land at hortonwood 40 telford shropshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 06. Dez. 1990 Geliefert am 12. Dez. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The items as set out on the attached schedule (see form 395 for full details) the mortgage contains a covenant not to sell, transfer demise, let on hire or otherwise part with possession of the goods comprised in the mortgage charge, pledge lien or other encumbrance to arise in said goods. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 06. Dez. 1990 Geliefert am 12. Dez. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben F/H land and buildings comprising three acres on thereabouts at hortonwood, telford shropshire. The legal charge contains a covenant by the company not to sell encumber or otherwise deal with the equity of redemption in the property without the previous consent in writing of the chargee. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 22. Nov. 1990 Geliefert am 29. Nov. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage the f/h property known as factory and land at hortonwood 40, telford shropshire goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. März 1990 Geliefert am 04. Apr. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 78400 all monies due or to become due from the company to the chargees under the terms of the chargee. | |
Kurze Angaben See form 395 document M539 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 19. März 1990 Geliefert am 27. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All rights benefits, title and interest in and to a contract dated 19/3/90 and an agreement dated 19/3/90 in the works to be carried out at hortonwood 40 telford shropshire the company's rights, title and interest (if any) in hortonwood 40 telford shropshire described in an agreement dated 19/3/90. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 19. März 1990 Geliefert am 23. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 19. März 1990 Geliefert am 23. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0