• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Stephen George MABBOTT - Seite 101

    Natürliche Person

    TitelMr
    VornameStephen
    Zweites VornamenGeorge
    NachnameMABBOTT
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv0
    Inaktiv23
    Zurückgetreten9252
    Gesamt9275

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    RS DIESEL SERVICES NORTHERN LTD.23. Feb. 201123. Feb. 2011AufgelöstCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    A & D ELLON LTD.23. Feb. 201123. Feb. 2011AufgelöstCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    HYBRID SIGNS LTD.23. Feb. 201123. Feb. 2011AufgelöstCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    CITYKIRK LIMITED08. Dez. 201023. Feb. 2011AufgelöstCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    SWAN TRANSLATIONS LTD.22. Feb. 201122. Feb. 2011AktivCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    JENKINS DIY LIMITED22. Feb. 201122. Feb. 2011AktivCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    BLAIRS WINDOWS LTD.22. Feb. 201122. Feb. 2011AktivCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    KMV CREATIVE LIMITED22. Feb. 201122. Feb. 2011AktivCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    NORTHERN PETROCHEMICAL SERVICES LTD.22. Feb. 201122. Feb. 2011AktivCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    DIANA KEMP LTD22. Feb. 201122. Feb. 2011AufgelöstCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    SOPHOCEAN LTD.22. Feb. 201122. Feb. 2011AufgelöstCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    PEDIMENTA BUSINESS SERVICES LTD.22. Feb. 201122. Feb. 2011AufgelöstCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    FALKIRK PAT TESTING LTD.22. Feb. 201122. Feb. 2011AufgelöstCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    MCCAIG RENEWABLES LIMITED22. Feb. 201122. Feb. 2011AufgelöstCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    MARNOCH FORMWORK LTD22. Feb. 201122. Feb. 2011AufgelöstCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    DEBT SERVICES SCOTLAND LTD.22. Feb. 201122. Feb. 2011AufgelöstCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    ADAM PROJECT MANAGEMENT LTD.22. Feb. 201122. Feb. 2011AufgelöstCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    PTS DOMESTIC LTD.22. Feb. 201122. Feb. 2011AufgelöstCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    HIGHBAND LIMITED22. Feb. 201122. Feb. 2011AufgelöstCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    TWEEDIE & MARSHALL LTD.22. Feb. 201122. Feb. 2011AufgelöstCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    TEVIOTDALE TRADE FRAMES LIMITED21. Feb. 201121. Feb. 2011AufgelöstCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    GRAEME WILSON LTD.21. Feb. 201121. Feb. 2011AufgelöstCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    CHRISTOPHER GROVES CONSULTANCY LTD.21. Feb. 201121. Feb. 2011AufgelöstCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    MARK R BLACK LTD.21. Feb. 201121. Feb. 2011AufgelöstCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    KENNETH BALD JOINERY SERVICES LIMITED21. Feb. 201121. Feb. 2011AufgelöstCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    THE BLACKBIRD EDINBURGH LTD.18. Feb. 201118. Feb. 2011AktivCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    BASRAI RESTAURANT LIMITED18. Feb. 201118. Feb. 2011AktivCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    YOUR EXPERT GROUP HOLDINGS LTD18. Feb. 201118. Feb. 2011AktivCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    DEAN FORMAN JOINERY LIMITED18. Feb. 201118. Feb. 2011AufgelöstCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    KAINED (HOLDINGS) LTD.18. Feb. 201118. Feb. 2011AufgelöstCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    ANDRIESCU MEDICAL SERVICES LIMITED18. Feb. 201118. Feb. 2011AufgelöstCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    ANJN LTD.18. Feb. 201118. Feb. 2011AufgelöstCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    JW WITCHHILL LIMITED17. Feb. 201117. Feb. 2011AktivCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    IMAGES FACE AND BODY STUDIO LTD.17. Feb. 201117. Feb. 2011AktivCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    HIGHER GROUND COMMUNITY SERVICES LIMITED17. Feb. 201117. Feb. 2011AktivCompany Registration AgentGeschäftsführer
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0