Mark Bernard FRANCKEL
Natürliche Person
| Titel | Mr |
|---|---|
| Vorname | Mark |
| Zweites Vornamen | Bernard |
| Nachname | FRANCKEL |
| Geburtsdatum | |
| Ist Unternehmensleiter | Nein |
| Ernennungen | |
| Aktiv | 6 |
| Inaktiv | 11 |
| Zurückgetreten | 39 |
| Gesamt | 56 |
Ernennungen
| Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAKES INTERNATIONAL UK LTD | 14. Juli 2025 | Aktiv | Geschäftsführer | Redwither Tower Redwither Business Park LL13 9XT Wrexham Unit 2g Wales | England | British | ||
| THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS INTERMEDIATE LIMITED | 10. Nov. 2020 | Verwalter bestellt | Geschäftsführer | Lakeside Drive WA1 1RW Warrington Lakeview 600 England | England | British | ||
| THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS GROUP LIMITED | 08. Okt. 2020 | Aktiv | Geschäftsführer | Lakeside Drive WA1 1RW Warrington Lakeview 600 England | England | British | ||
| THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS UK LIMITED | 08. Okt. 2020 | Liquidation | Geschäftsführer | The Chancery 58 Spring Gardens M2 1EW Manchester Kroll Advisory Ltd | England | British | ||
| ARLINGTON INDUSTRIES GROUP LTD | 01. Okt. 2015 | Liquidation | Geschäftsführer | The Chancery 58 Spring Gardens M2 1EW Manchester C/O Kroll Advisory Ltd | England | British | ||
| ARLINGTON WHEELS LIMITED | 25. Juni 2015 | Aufgelöst | Geschäftsführer | Manchester International Office Centre Styal Road M22 5WB Manchester Suite 15b England | England | British | ||
| INVESTMENT HOLDCO 123 LIMITED | 20. Dez. 2014 | Aufgelöst | Geschäftsführer | South Rings Business Park Bamber Bridge PR5 6DA Preston 20 Roundhouse Court | England | British | ||
| AIM DESIGN CO. LIMITED | 07. Nov. 2014 | Aufgelöst | Geschäftsführer | 20 Roundhouse Court South Rings Business Park PR5 6DA Bamber Bridge Leonard Curtis Preston | England | British | ||
| AES REALISATIONS (COVENTRY) LIMITED | 22. Aug. 2014 | Aufgelöst | Geschäftsführer | The Chancery 58 Spring Gardens M2 1EW Manchester C/O Duff And Phelps | England | British | ||
| AIM ENGINEERING LIMITED | 22. Aug. 2014 | Aufgelöst | Geschäftsführer | South Rings Business Park Bamber Bridge PR5 6DA Preston 20 Roundhouse Court Lancashire | England | British | ||
| ARLINGTON AEROSPACE LIMITED | 22. Aug. 2014 | Aufgelöst | Geschäftsführer | 20 Roundhouse Court Bamber Bridge PR5 6DA Preston C/O Leonard Curtis | England | British | ||
| ARLINGTON MANAGEMENT SERVICES LTD | 22. Aug. 2014 | Aufgelöst | Geschäftsführer | The Chancery 58 Spring Gardens M2 1EW Manchester C/O Duff And Phelps | England | British | ||
| ARLINGTON AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED | 22. Aug. 2014 | Aufgelöst | Geschäftsführer | 58 Spring Gardens M2 1EW Manchester C/O Duff And Phelps The Chancery | England | British | ||
| FG CAPITAL PARTNERS LLP | 12. Dez. 2013 | Aufgelöst | Bestelltes Mitglied der LLP | Wood Lane PR7 5PA Heskin Heskin Hall Farm Preston | England | |||
| TRIMITE POWDER LIMITED | 04. Aug. 2009 | Aufgelöst | Geschäftsführer | Alexandra Road Grappenhall WA4 2EL Warrington 8 Cheshire | United Kingdom | British | ||
| STRETFORD OUTSOURCE SOLUTIONS LIMITED | 17. Juli 2009 | Aufgelöst | Geschäftsführer | Alexandra Road Grappenhall WA4 2EL Warrington 8 Cheshire | United Kingdom | British | ||
| ADVANCED BUSINESS STRATEGIES LIMITED | 24. Nov. 2006 | Aktiv | Geschäftsführer | Park Street FY8 5LU Lytham St. Annes 19 England | England | British | ||
| THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED | 07. Okt. 2020 | 13. Okt. 2025 | Aktiv | Geschäftsführer | Lakeside Drive WA1 1RW Warrington Lakeview 600 England | England | British | |
| N054 LIMITED | 03. Juni 2016 | 28. Nov. 2019 | Aufgelöst | Geschäftsführer | Ebenezer Street CH42 1NH Birkenhead 3a And 3b England | England | British | |
| AMPCO 106 LIMITED | 03. Juni 2016 | 28. Nov. 2019 | Aufgelöst | Geschäftsführer | Ebenezer Street CH24 1NH Birkenhead 3a And 3b England | England | British | |
| HUGHES ARMSTRONG INDUSTRIES LIMITED | 22. Sept. 2014 | 15. Mai 2018 | Aktiv | Geschäftsführer | Warrington Road Birchwood WA3 6AE Warrington Suite 423 Chadwick House Cheshire England | England | British | |
| SPEAR & JACKSON GROUP LIMITED | 17. Sept. 2012 | 31. Jan. 2014 | Aktiv | Geschäftsführer | Atlas Way Atlas North S4 7QQ Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | |
| SPEAR & JACKSON UK LIMITED | 09. Jan. 2012 | 31. Jan. 2014 | Aktiv | Geschäftsführer | C/O James Neill Holdings Limited Atlas Way Atlas North S4 7QQ Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | |
| NEILL TOOLS LIMITED | 09. Jan. 2012 | 31. Jan. 2014 | Aktiv | Geschäftsführer | C/O James Neill Holdings Limited Atlas Way Atlas North S4 7QQ Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | |
| JAMES NEILL HOLDINGS LIMITED | 09. Jan. 2012 | 31. Jan. 2014 | Aktiv | Geschäftsführer | Atlas Way Atlas North S4 7QQ Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | |
| BOWERS GROUP LIMITED | 09. Jan. 2012 | 31. Jan. 2014 | Aktiv | Geschäftsführer | C/O James Neill Holdings Ltd Atlas Way Atlas North S4 7QQ Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | |
| SPEAR & JACKSON LIMITED | 09. Jan. 2012 | 31. Jan. 2014 | Aktiv | Geschäftsführer | Atlas Way Atlas North S4 7QQ Sheffield C/O James Neill Holdings Limited South Yorkshire | United Kingdom | British | |
| BOWERS METROLOGY LIMITED | 09. Jan. 2012 | 31. Jan. 2014 | Aktiv | Geschäftsführer | C/O James Neill Holdings Ltd Atlas Way Atlas North S4 7QQ Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | |
| ECLIPSE MAGNETICS LIMITED | 09. Jan. 2012 | 31. Jan. 2014 | Aktiv | Geschäftsführer | C/O James Neill Holdings Limited Atlas Way Atlas North S4 7QQ Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | |
| BOWERS METROLOGY (UK) LIMITED | 09. Jan. 2012 | 31. Jan. 2014 | Aktiv | Geschäftsführer | C/0 James Neill Holdings Ltd Atlas Way Atlas North S4 7QQ Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | |
| EDGETEK LIMITED | 24. Nov. 2006 | 10. Apr. 2012 | Aufgelöst | Geschäftsführer | Alexandra Road Grappenhall WA4 2EL Warrington 8 Cheshire | United Kingdom | British | |
| LUDGATE 402 LIMITED | 10. Juli 2006 | 10. Apr. 2012 | Aufgelöst | Geschäftsführer | Alexandra Road Grappenhall WA4 2EL Warrington 8 Cheshire | United Kingdom | British | |
| ARLINGTON AEROSPACE LIMITED | 01. Aug. 2011 | 04. Apr. 2012 | Aufgelöst | Geschäftsführer | Arundel Road UB8 2SD Uxbridge Trimite House Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | |
| GLIXTONE LTD | 18. Mai 2011 | 04. Apr. 2012 | Aktiv | Geschäftsführer | Eagle Road Moons Moat North Industrial Estate B98 9HF Redditch 2e Worcestershire England | United Kingdom | British | |
| TRIMITE LIMITED | 20. März 2009 | 03. Jan. 2012 | Aktiv | Geschäftsführer | Alexandra Road Grappenhall WA4 2EL Warrington 8 Cheshire | United Kingdom | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0