AMPCO 106 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | AMPCO 106 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 09050978 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von AMPCO 106 LIMITED?
- Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich AMPCO 106 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 4 Bank Court Weldon Road LE11 5RF Loughborough England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AMPCO 106 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für AMPCO 106 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Beendigung der Bestellung von Gavin John Bewley als Geschäftsführer am 22. Juni 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Colin Rodney Keal als Geschäftsführer am 22. Juni 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Mai 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2021 | 6 Seiten | AA | ||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Mai 2021 bis 31. März 2021 | 1 Seiten | AA01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Mai 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2020 | 6 Seiten | AA | ||
Eintragung der Belastung 090509780005, erstellt am 22. Feb. 2021 | 25 Seiten | MR01 | ||
Change of details for Ampco 144 Limited as a person with significant control on 22. Jan. 2020 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Mai 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2019 | 6 Seiten | AA | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 3a and 3B Ebenezer Street Birkenhead CH24 1NH England zum 4 Bank Court Weldon Road Loughborough LE11 5RF am 22. Jan. 2020 | 1 Seiten | AD01 | ||
Ernennung von Mr Miles Tudor als Direktor am 28. Nov. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Mark Bernard Franckel als Geschäftsführer am 28. Nov. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Colin Rodney Keal als Direktor am 28. Nov. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Gavin John Bewley als Direktor am 28. Nov. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Cessation of Arlington Aerospace Limited as a person with significant control on 28. Nov. 2019 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Notification of Ampco 144 Limited as a person with significant control on 28. Nov. 2019 | 2 Seiten | PSC02 | ||
Eintragung der Belastung 090509780004, erstellt am 28. Nov. 2019 | 31 Seiten | MR01 | ||
Eintragung der Belastung 090509780003, erstellt am 28. Nov. 2019 | 24 Seiten | MR01 | ||
legacy | 6 Seiten | RP04CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Simon George Greenhalgh als Geschäftsführer am 14. Juli 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Geänderte Konten eines Mikrounternehmens erstellt bis 31. Mai 2018 | 2 Seiten | AAMD | ||
Wer sind die Geschäftsführer von AMPCO 106 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUDOR, Miles Alistair | Geschäftsführer | Bank Court Weldon Road LE11 5RF Loughborough 4 England | United Kingdom | British | 264598040001 | |||||
| BEWLEY, Gavin John | Geschäftsführer | Bank Court Weldon Road LE11 5RF Loughborough 4 England | England | British | 264597640001 | |||||
| BEWLEY, Gavin John | Geschäftsführer | NG1 5DU Nottingham 7 The Ropewalk | England | British | 67048390002 | |||||
| FRANCKEL, Mark Bernard | Geschäftsführer | Ebenezer Street CH24 1NH Birkenhead 3a And 3b England | England | British | 137556900004 | |||||
| GREENHALGH, Simon George | Geschäftsführer | Ebenezer Street CH24 1NH Birkenhead 3a And 3b England | England | British | 82888850001 | |||||
| KEAL, Colin Rodney | Geschäftsführer | Bank Court Weldon Road LE11 5RF Loughborough 4 England | England | British | 212201550001 | |||||
| KEAL, Colin Rodney | Geschäftsführer | NG1 5DU Nottingham 7 The Ropewalk England | England | British | 107266830003 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei AMPCO 106 LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampco 144 Limited | 28. Nov. 2019 | Weldon Road LE11 5RF Loughborough 4 Bank Court Leicestershire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Arlington Aerospace Limited | 06. Apr. 2016 | Southmoor Industrial Estate, Southmoor Road M23 9XD Manchester Southmoor Industrial Estate England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat AMPCO 106 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 22. Feb. 2021 Geliefert am 22. Feb. 2021 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung By way of first legal mortgage, all land (as defined below) belonging to the company at the date of the debenture including without limitation that described in part 1 of schedule 2 to the debenture (a copy of which schedule is attached to this form MR01 ).. in the debenture “land” means all estates and other interests in freehold, leasehold or other immovable property (wherever situated) or in which the company has an interest and:-. (I) all buildings and fixtures (including trade fixtures but not including tenant’s fixtures) and fixed plant and machinery at any time thereon;. (Ii) all easements, rights and agreements in respect of such property;. (Iii) all proceeds of sale of such property; and. (Iv) the benefit of all covenants given in respect of such property. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 28. Nov. 2019 Geliefert am 17. Dez. 2019 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung The freehold properties registered to north west precision limited known as 3A and 3B ebenezer street, birkenhead, CH42 1NH and registered with title numbers MS334420 and MS327808. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 28. Nov. 2019 Geliefert am 06. Dez. 2019 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 10. Mai 2017 Geliefert am 11. Mai 2017 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 03. Juni 2016 Geliefert am 08. Juni 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Each security obligor charges and agrees to charge all of its present and future right, title and interest in and to the following assets which are at any time owned by it, or in which it from time to time has an interest:. (A) by way of first legal mortgage the specified real property;. (B) by way of first fixed charge:. (I) all real property and all interests in real property not charged by clause 5.1(a);. (Ii) all licences to enter upon or use land and the benefit of all other agreements relating to land; and. (Iii) the proceeds of sale of all real property other than specified real property;. (C) by way of first fixed charge all intellectual property (if any) specified in part 4 of schedule 3 (details of security assets); and. (D) by way of first fixed charge all intellectual property (if any) not charged by clause 5.1(q).. "Specified real property" means the estates and interests in freehold, leasehold and other immovable property (if any) specified in part 1 of schedule 3 (details of security assets), together with:. (A) all buildings and fixtures (including trade fixtures) and fixed p&m at any time thereon;. (B) all easements, rights and agreements in respect thereof;. (C) the benefit of all covenants given in respect thereof; and. (D) any other real property which centric may designate as "specified real property".. All defined terms are as defined in the composite guarantee and debenture. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0