• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Simon Christoffer STEDMAN - Seite 2

    Natürliche Person

    TitelMr
    VornameSimon
    Zweites VornamenChristoffer
    NachnameSTEDMAN
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv0
    Inaktiv5
    Zurückgetreten113
    Gesamt118

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    AITCH INVESTMENT PROPERTIES LIMITED24. Feb. 201515. Nov. 2017AktivAccountantGeschäftsführer
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    RIDLEY VILLAS (LONDON) LIMITED24. Feb. 201515. Nov. 2017AktivAccountantGeschäftsführer
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    URBAN RECRUITMENT LIMITED24. Feb. 201515. Nov. 2017AktivAccountantGeschäftsführer
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    CHILDER STREET HOLDINGS LIMITED24. Feb. 201515. Nov. 2017AktivAccountantGeschäftsführer
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    COASTALVIEW LIMITED24. Feb. 201515. Nov. 2017AktivAccountantGeschäftsführer
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    NORTHUMBERLAND PARK HOLDINGS LIMITED24. Feb. 201515. Nov. 2017AktivAccountantGeschäftsführer
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    RIDLEY VILLAS LIMITED24. Feb. 201515. Nov. 2017AktivAccountantGeschäftsführer
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    AITCH ESTATES LIMITED24. Feb. 201515. Nov. 2017AktivAccountantGeschäftsführer
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    AITCH CONSTRUCTION LIMITED24. Feb. 201515. Nov. 2017AktivAccountantGeschäftsführer
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    URBAN RECRUITMENT GROUP LIMITED12. Feb. 201515. Nov. 2017AktivAccountantGeschäftsführer
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    MEDICSPRO HEALTHCARE LIMITED12. Feb. 201515. Nov. 2017AktivAccountantGeschäftsführer
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    MEDICSPRO LTD12. Feb. 201515. Nov. 2017AktivAccountantGeschäftsführer
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    URBAN TRUSTEES LIMITED12. Feb. 201515. Nov. 2017AktivAccountantGeschäftsführer
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    1-2 HEPSCOTT ROAD LIMITED05. Feb. 201515. Nov. 2017AktivAccountantGeschäftsführer
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    THE SMITH PROPERTY PARTNERSHIP LIMITED04. Feb. 201515. Nov. 2017AktivAccountantGeschäftsführer
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    ROTHBURY ROAD LIMITED04. Nov. 201415. Nov. 2017AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    176-179 Shoreditch High Street
    E1 6HU London
    The Old Post Office Suite 14
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    32/34 EAGLE WHARF ROAD LIMITED04. Sept. 201415. Nov. 2017AktivAccountantGeschäftsführer
    Glengall Road
    IG8 0DS Woodford Green
    136
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    BIRKHILL TURBINES LIMITED25. Sept. 201715. Nov. 2017AufgelöstGroup Finance DirectorGeschäftsführer
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor Kirkdale House Kirkdale Road
    England
    United KingdomBritish
    STERLING RETIREMENT LIVING LIMITED07. Jan. 201615. Nov. 2017AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    SGA LEGAL TRUSTEES LIMITED24. Feb. 201515. Nov. 2017AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    KALSERN LIMITED24. Feb. 201515. Nov. 2017AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    K SMITH CONSULTANCY LIMITED24. Feb. 201515. Nov. 2017AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    ST JOHNS ROAD PROPERTIES LIMITED24. Feb. 201515. Nov. 2017AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    FPS DESIGNS LIMITED24. Feb. 201515. Nov. 2017AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    CHATHAM PLACE LIMITED24. Feb. 201515. Nov. 2017AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    LONDON LANE (HOC) LTD16. Juni 201715. Nov. 2017LiquidationDirectorGeschäftsführer
    IG8 0DS Woodford Green
    136 Glengall Road
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    SQ BOX LIMITED02. Dez. 201602. Dez. 2016AktivDirectorGeschäftsführer
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    BROOKSIDE CRESCENT MANAGEMENT LIMITED04. Sept. 201528. Juli 2016AktivDirectorGeschäftsführer
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    SMITH FAMILY TRUST CORPORATION LIMITED19. Aug. 201508. Feb. 2016AktivAccountantGeschäftsführer
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    BLENHEIM RETIREMENT LIVING LIMITED07. Jan. 201607. Jan. 2016AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    STRATFORD (HIGH STREET) LIMITED24. Feb. 201530. Apr. 2015AktivAccountantGeschäftsführer
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    KIRKDALE ROAD LIMITED16. Apr. 201516. Apr. 2015AktivDirectorGeschäftsführer
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    STAMFORD WORKS LIMITED28. März 200720. Juni 2008AktivAccountantGeschäftsführer
    136 Glengall Road
    IG8 0DS Woodford Green
    Essex
    United KingdomBritish
    BALISTON LIMITED15. Jan. 200720. Juni 2008AktivAccountantGeschäftsführer
    136 Glengall Road
    IG8 0DS Woodford Green
    Essex
    United KingdomBritish
    HOLDALE PROPERTIES LIMITED17. Okt. 200620. Juni 2008AktivAccountantGeschäftsführer
    136 Glengall Road
    IG8 0DS Woodford Green
    Essex
    United KingdomBritish

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0