Ewan John HENDERSON - Seite 2
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | Ewan |
Zweites Vornamen | John |
Nachname | HENDERSON |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 33 |
Inaktiv | 13 |
Zurückgetreten | 26 |
Gesamt | 72 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELLSHILL LARK (NUMBER 9) LIMITED | 22. Mai 2008 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | The Glenfiddich Distillery Dufftown Banffshire | United Kingdom | British | |
BELLSHILL LARK (NUMBER 7) LIMITED | 22. Mai 2008 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | The Glenfiddich Distillery Dufftown Banffshire | United Kingdom | British | |
BELLSHILL LARK (NUMBER 19) LIMITED | 22. Mai 2008 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | The Glenfiddich Distillery Dufftown Banffshire Ab55 | United Kingdom | British | |
BELLSHILL LARK (NUMBER 6) LIMITED | 22. Mai 2008 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | The Glenfiddich Distillery Dufftown Banffshire | United Kingdom | British | |
WILLIAM GRANT & SONS NETHERLANDS B.V. | 24. Jan. 2005 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | Flat 3/5, 15 Clarendon Street G20 7QP Glasgow | British | ||
GEORGE MORTON LIMITED | 11. Okt. 2002 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | Strathclyde Business Park Phoenix Crescent ML4 3AN Bellshill Strathclyde | United Kingdom | British | |
BELLSHILL LARK (NUMBER 21) LIMITED | 11. Okt. 2002 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | The Old Court House 7 Parkshot TW9 2RF Richmond William Grant & Sons England | United Kingdom | British | |
THE HENDRICK'S GIN DISTILLERY LIMITED | 11. Okt. 2002 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | Grangestone Industrial Estate KA26 9PT Girvan Girvan Distillery Strathclyde | United Kingdom | British | |
BELLSHILL LARK (NUMBER 10) LIMITED | 02. Sept. 2002 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | Phoenix Crescent Strathclyde Business Park ML4 3AN Bellshill | United Kingdom | British | |
WILLIAM GRANT & SONS CANADA LIMITED | 19. Aug. 2002 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | The Glenfiddich Distillery Dufftown AB55 4DH Banffshire | United Kingdom | British | |
BELLSHILL LARK (NUMBER 13) LIMITED | 19. Aug. 2002 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | The Glenfiddich Distillery Dufftown AB55 4DH Banffshire | United Kingdom | British | |
WILLIAM GRANT & SONS HOLDINGS LIMITED | 26. Okt. 2023 | 05. Feb. 2025 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | 7 Parkshot TW9 2RF Richmond The Old Court House United Kingdom | United Kingdom | British |
CHASTITY LIMITED | 03. Nov. 2022 | 30. Juni 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Phoenix Crescent Strathclyde Business Park ML4 3AN Bellshill Strathclyde Business Park Scotland | United Kingdom | British |
WILLIAM GRANT & SONS UK LIMITED | 01. Juni 2019 | 18. Okt. 2021 | Aktiv | Group Tax And Company Secretary | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park Bartley Way RG27 9XA Hook Form 1 Hampshire | United Kingdom | British |
SISKIN CAPITAL (JERSEY) LIMITED | 09. Dez. 2015 | 23. Nov. 2020 | Umwandlung / Auflösung | Chartered Accountant | Geschäftsführer | Strathclyde Business Park ML4 3AN Bellshill Phoenix Crescent Lanarkshire United Kingdom | United Kingdom | British |
OSPREY CAPITAL (JERSEY) LIMITED | 09. Dez. 2015 | 29. Okt. 2020 | Umwandlung / Auflösung | Chartered Accountant | Geschäftsführer | Strathclyde Business Park ML4 3AN Bellshill Phoenix Crescent Lanarkshire United Kingdom | United Kingdom | British |
CAPERCAILLIE CAPITAL (JERSEY) LIMITED | 09. Dez. 2015 | 23. Juli 2020 | Aktiv | Chartered Accountant | Geschäftsführer | Strathclyde Business Park ML4 3AN Bellshill Phoenix Crescent Lanarkshire United Kingdom | United Kingdom | British |
BRAMBLING CAPITAL (JERSEY) LIMITED | 09. Dez. 2015 | 16. März 2020 | Umwandlung / Auflösung | Chartered Accountant | Geschäftsführer | Strathclyde Business Park ML4 3AN Bellshill Phoenix Crescent Lanarkshire United Kingdom | United Kingdom | British |
SISKIN HOLDINGS LIMITED | 07. Mai 2019 | 09. Okt. 2019 | Liquidation | Chartered Accountant | Geschäftsführer | Dufftown AB55 4DH Keith The Glenfiddich Distillery United Kingdom | United Kingdom | British |
WILLIAM GRANT & SONS DUFFTOWN LIMITED | 07. Mai 2019 | 13. Aug. 2019 | Aktiv | Chartered Accountant | Geschäftsführer | AB55 4DH Dufftown, Keith The Glenfiddich Distillery United Kingdom | United Kingdom | British |
OSPREY HOLDINGS LIMITED | 07. Mai 2019 | 06. Aug. 2019 | Liquidation | Chartered Accountant | Geschäftsführer | AB55 4DH Dufftown, Keith The Glenfiddich Distillery United Kingdom | United Kingdom | British |
CAPERCAILLIE HOLDINGS LIMITED | 07. Mai 2019 | 31. Juli 2019 | Aktiv | Chartered Accountant | Geschäftsführer | 20 Primrose Street EC2A 2EW London Level 13 Broadgate Tower United Kingdom | United Kingdom | British |
BRAMBLING HOLDINGS LIMITED | 07. Mai 2019 | 11. Juli 2019 | Aktiv | Chartered Accountant | Geschäftsführer | 20 Primrose Street EC2A 2EW London Level 13 Broadgate Tower United Kingdom | United Kingdom | British |
QUALITY SPIRITS INTERNATIONAL LIMITED | 11. Dez. 2018 | 31. Mai 2019 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Independence House 84 Lower Mortlake Road TW9 2HS Richmond Surrey | United Kingdom | British |
WILLIAM GRANT & SONS BRANDS LIMITED | 11. Dez. 2018 | 31. Mai 2019 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Lower Mortlake Road TW9 2HS Richmond Independence House 84 Surrey | United Kingdom | British |
WILLIAM GRANT & SONS DISTILLERS LIMITED | 11. Dez. 2018 | 31. Mai 2019 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Dufftown AB55 4DH Keith The Glenfiddich Distillery Scotland | United Kingdom | British |
WILLIAM GRANT & SONS UK LIMITED | 12. Jan. 2017 | 31. Mai 2019 | Aktiv | Group Tax And Company Secretary | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park Bartley Way RG27 9XA Hook Form 1 Hampshire | United Kingdom | British |
WILLIAM GRANT & SONS BRANDS LIMITED | 28. Mai 2014 | 02. Okt. 2017 | Aktiv | Chartered Accountant | Geschäftsführer | Lower Mortlake Road TW9 2HS Richmond Independence House 84 Surrey United Kingdom | United Kingdom | British |
MACROBERT ARTS CENTRE LIMITED | 20. Dez. 2011 | 16. Sept. 2014 | Aktiv | Chartered Accountant | Geschäftsführer | University Of Stirling FK9 4LA Stirling Macroberts Arts Centre | United Kingdom | British |
THE INNIS & GUNN BREWING COMPANY LIMITED | 03. Apr. 2007 | 17. Jan. 2008 | Aktiv | Chartered Accountant | Geschäftsführer | 3 Broster Meadows The Redheugh Estate KA25 7JG Kilbirnie North Ayrshire | United Kingdom | British |
OLIVE HOLDINGS LIMITED | 14. Apr. 2005 | 06. Dez. 2005 | Aktiv | Chartered Accountant | Geschäftsführer | Flat 3/5, 15 Clarendon Street G20 7QP Glasgow | British | |
BAMBOO HOLDINGS LIMITED | 14. Apr. 2005 | 16. Sept. 2005 | Aktiv | Chartered Accountant | Geschäftsführer | Flat 3/5, 15 Clarendon Street G20 7QP Glasgow | British | |
SANDALWOOD HOLDINGS LIMITED | 14. Apr. 2005 | 16. Sept. 2005 | Aufgelöst | Chartered Accountant | Geschäftsführer | Flat 3/5, 15 Clarendon Street G20 7QP Glasgow | British | |
WILLIAM GRANT & SONS LIMITED | 18. Mai 2005 | 26. Mai 2005 | Aktiv | Chartered Accountant | Geschäftsführer | Flat 3/5, 15 Clarendon Street G20 7QP Glasgow | British | |
WILLIAM GRANT & SONS GROUP LIMITED | 14. Apr. 2005 | 26. Mai 2005 | Aktiv | Chartered Accountant | Geschäftsführer | Flat 3/5, 15 Clarendon Street G20 7QP Glasgow | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0