• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Alan Henry FOY - Seite 2

    Natürliche Person

    TitelMr
    VornameAlan
    Zweites VornamenHenry
    NachnameFOY
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv2
    Inaktiv5
    Zurückgetreten55
    Gesamt62

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    SMS INSTALLATIONS (MIDLANDS) LIMITED28. Nov. 201628. Feb. 2022AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    48 St. Vincent Street
    G2 5TS Glasgow
    Second Floor
    Scotland
    ScotlandBritish
    TROJAN UTILITIES LIMITED13. Okt. 201628. Feb. 2022AktivDirectorGeschäftsführer
    Copse Walk
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8XH Cardiff
    Prennau House
    ScotlandBritish
    QTON SOLUTIONS LIMITED18. März 201628. Feb. 2022AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    48 St. Vincent Street
    G2 5TS Glasgow
    Second Floor
    Scotland
    ScotlandBritish
    CH4 GAS UTILITY AND MAINTENANCE SERVICES LIMITED18. März 201628. Feb. 2022AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    48 St. Vincent Street
    G2 5TS Glasgow
    Second Floor
    Scotland
    ScotlandBritish
    SAVANO LIMITED18. März 201628. Feb. 2022AufgelöstCompany DirectorGeschäftsführer
    48 St. Vincent Street
    G2 5TS Glasgow
    Second Floor
    Scotland
    ScotlandBritish
    METERING 1 LIMITED16. März 201628. Feb. 2022AufgelöstCompany DirectorGeschäftsführer
    St. Vincent Street
    Second Floor
    G2 5TS Glasgow
    48
    Scotland
    ScotlandBritish
    METERING 2 LIMITED16. März 201628. Feb. 2022AufgelöstCompany DirectorGeschäftsführer
    48 St. Vincent Street
    G2 5TS Glasgow
    Second Floor
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    UK GAS CONNECTION LIMITED29. Juni 201528. Feb. 2022AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    St. Vincent Street
    G2 5TS Glasgow
    Second Floor, 48
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    UK DATA MANAGEMENT LIMITED29. Juni 201528. Feb. 2022AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    St. Vincent Street
    G2 5TS Glasgow
    Second Floor, 48
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    UK METER ASSETS LIMITED29. Juni 201528. Feb. 2022AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    St Vincent Street
    G2 5TS Glasgow
    Second Floor 48
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    UTILITY PARTNERSHIP LIMITED29. Juni 201528. Feb. 2022AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    St. Vincent Street
    G2 5TS Glasgow
    Second Floor 48
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    SMS ENERGY SERVICES LIMITED12. Apr. 201428. Feb. 2022AktivNoneGeschäftsführer
    48 St Vincent Street
    G2 5TS Glasgow
    Second Floor
    Scotland
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    THE UK METER EXCHANGE LIMITED26. Mai 201128. Feb. 2022AufgelöstCompany DirectorGeschäftsführer
    St Vincent Street
    G2 5TS Glasgow
    Second Floor 48
    ScotlandBritish
    UK WATER CONNECTION LIMITED26. Mai 201128. Feb. 2022AufgelöstCompany DirectorGeschäftsführer
    St. Vincent Street
    G2 5TS Glasgow
    Second Floor 48
    Scotland
    ScotlandBritish
    UK SMART METERING GROUP LIMITED26. Mai 201128. Feb. 2022AufgelöstCompany DirectorGeschäftsführer
    St. Vincent Street
    G2 5TS Glasgow
    Second Floor 48
    Scotland
    ScotlandBritish
    SMART METER SYSTEMS LIMITED26. Mai 201128. Feb. 2022AufgelöstCompany DirectorGeschäftsführer
    St Vincent Street
    G2 5TS Glasgow
    Second Floor 48
    Scotland
    ScotlandBritish
    UK ELECTRICITY CONNECTION LIMITED26. Mai 201128. Feb. 2022AufgelöstCompany DirectorGeschäftsführer
    St. Vincent Street
    G2 5TS Glasgow
    Second Floor 48
    Scotland
    ScotlandBritish
    ECO PROJECT MANAGEMENT LIMITED26. Mai 201128. Feb. 2022AufgelöstCompany DirectorGeschäftsführer
    St. Vincent Street
    G2 5TS Glasgow
    Second Floor 48
    Scotland
    ScotlandBritish
    SMS DATA MANAGEMENT LIMITED23. Sept. 201028. Feb. 2022AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    St Vincent Street
    G2 5TS Glasgow
    Second Floor 48
    Scotland
    ScotlandBritish
    UKMA (AF) LIMITED20. Jan. 201028. Feb. 2022AktivCommercial DirectorGeschäftsführer
    Cardiff Gate Business Park
    Pontprennau
    CF23 8XH Cardiff
    Prennau House Copse Walk
    Wales
    ScotlandBritish
    SMS IP LIMITED08. Jan. 201028. Feb. 2022AufgelöstCommercial DirectorGeschäftsführer
    St. Vincent Street
    G2 5TS Glasgow
    48
    Scotland
    ScotlandBritish
    SMART METERING SYSTEMS LIMITED24. Dez. 200928. Feb. 2022AktivNoneGeschäftsführer
    St. Vincent Street
    G2 5TS Glasgow
    Second Floor 48
    Scotland
    ScotlandBritish
    SMS METER ASSETS LIMITED11. Apr. 200728. Feb. 2022AktivDirectorGeschäftsführer
    St Vincent Street
    G2 5TS Glasgow
    Second Floor 48
    Scotland
    ScotlandBritish
    SMS ENERGY CONNECTIONS LIMITED28. Feb. 200528. Feb. 2022AktivOperations DirectorGeschäftsführer
    St. Vincent Street
    G2 5TS Glasgow
    Second Floor 48
    Scotland
    ScotlandBritish
    CRAIL METERS LIMITED26. Sept. 201922. Apr. 2020AktivDirectorGeschäftsführer
    Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    21
    ScotlandBritish
    SMS METER ASSETS LIMITED11. Apr. 200717. März 2017AktivSekretär
    St Vincent Street
    G2 5TS Glasgow
    Second Floor 48
    Scotland
    British
    SMS ENERGY CONNECTIONS LIMITED28. Feb. 200517. März 2017AktivOperations DirectorSekretär
    St. Vincent Street
    G2 5TS Glasgow
    Second Floor 48
    Scotland
    British

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0