EVERSECRETARY LIMITED - Seite 3
Unternehmensleiter
Name | EVERSECRETARY LIMITED |
---|---|
Ist Unternehmensleiter | Ja |
Ernennungen | |
Aktiv | 8 |
Inaktiv | 203 |
Zurückgetreten | 1404 |
Gesamt | 1615 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Rolle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
BROADSOFT UK OPERATING COMPANY LTD | 07. Aug. 2018 | 01. Feb. 2021 | Aktiv | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
BROADSOFT UK HOLDING COMPANY LTD | 07. Aug. 2018 | 01. Feb. 2021 | Aktiv | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
ASCENDANTFX CAPITAL UK, LIMITED | 10. Juli 2018 | 01. Feb. 2021 | Aktiv | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
ERICO EUROPA (G.B.) LIMITED | 05. Juli 2018 | Aufgelöst | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
PENTAIR UK HOLDINGS LIMITED | 11. Juni 2018 | 07. Okt. 2019 | Aktiv | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
RX BAR UK LIMITED | 07. Apr. 2018 | 31. Dez. 2020 | Aufgelöst | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
FDR PENSION SCHEME TRUSTEE LIMITED | 27. Feb. 2018 | 01. Feb. 2021 | Aktiv | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
PENTAIR INTERNATIONAL (UK) LTD | 26. Jan. 2018 | 07. Okt. 2019 | Aktiv | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House Lancashire United Kingdom |
SHAYLOR GROUP LIMITED | 08. Jan. 2018 | 07. Nov. 2022 | Liquidation | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
SHAYLOR MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 08. Jan. 2018 | Aufgelöst | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
SHAYLOR HOLDINGS LIMITED | 08. Jan. 2018 | 07. Nov. 2022 | Liquidation | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
GLOBAL REACH TECHNOLOGY EMEA LIMITED | 08. Dez. 2017 | 08. Jan. 2018 | Aktiv | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
OPTIMA ENCLOSURES LIMITED | 01. Dez. 2017 | 01. Feb. 2021 | Aufgelöst | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
PENTAIR UK GROUP LIMITED | 01. Dez. 2017 | 07. Okt. 2019 | Aufgelöst | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
RVA ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED | 20. Nov. 2017 | 07. Feb. 2019 | Aktiv | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
RVA CONSULTING ENGINEERS LIMITED | 20. Nov. 2017 | 07. Feb. 2019 | Aktiv | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
RVA GROUP LIMITED | 20. Nov. 2017 | 07. Feb. 2019 | Aktiv | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
EVOLVE SERVICING LIMITED | 01. Nov. 2017 | 17. Dez. 2021 | Aktiv | Sekretär | New Bailey 6 Stanley Street M3 5GS Salford 2 Greater Manchester United Kingdom |
NVENT UK HOLDINGS LIMITED | 23. Okt. 2017 | 01. Feb. 2021 | Aktiv | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
ASTON LARK (TRUSTEES) LIMITED | 23. Okt. 2017 | 01. Feb. 2021 | Aktiv | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
ONX UK LIMITED | 02. Okt. 2017 | 01. Feb. 2021 | Aufgelöst | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
PENTAIR TUBING LIMITED | 01. Mai 2017 | 07. Okt. 2019 | Liquidation | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
GOODYEAR DUNLOP TYRES UK (PENSION TRUSTEES) LTD. | 24. März 2017 | 01. Feb. 2021 | Aktiv | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
SUDMO (UK) LIMITED | 01. März 2017 | 07. Okt. 2019 | Aufgelöst | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
SCHROFF UK LIMITED | 01. März 2017 | Aufgelöst | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
EDWARD BARBER (U.K.) LIMITED | 01. März 2017 | Aufgelöst | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
CHEMELEX (UK) LIMITED | 01. März 2017 | 01. Feb. 2021 | Aktiv | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
GOYEN CONTROLS CO UK LIMITED | 01. März 2017 | Aufgelöst | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
RAYCHEM HTS LIMITED | 01. März 2017 | Aufgelöst | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
EDWARD BARBER & COMPANY LIMITED | 01. März 2017 | Aufgelöst | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
PENTAIR ENVIRONMENTAL SYSTEMS LIMITED | 01. März 2017 | 07. Okt. 2019 | Aufgelöst | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
MASTER PLAN TRUSTEES LTD | 01. Feb. 2017 | 01. Feb. 2021 | Aktiv | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
SLJH LIMITED | 16. Dez. 2016 | 01. März 2019 | Aktiv | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House England |
MAYFIELD PARTNERSHIP (GENERAL PARTNER) LIMITED | 14. Dez. 2016 | 02. März 2017 | Aktiv | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
FMC TECHNOLOGIES GLOBAL BUSINESS SERVICES LTD | 05. Dez. 2016 | 07. Okt. 2019 | Aufgelöst | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0