Steven Craig WILLINGHAM
Natürliche Person
| Titel | Mr |
|---|---|
| Vorname | Steven |
| Zweites Vornamen | Craig |
| Nachname | WILLINGHAM |
| Geburtsdatum | |
| Ist Unternehmensleiter | Nein |
| Ernennungen | |
| Aktiv | 0 |
| Inaktiv | 0 |
| Zurückgetreten | 33 |
| Gesamt | 33 |
Ernennungen
| Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK PROPERTY EUROPE LIMITED | 30. Juli 2010 | 01. Juli 2014 | Aufgelöst | Geschäftsführer | Floor 6 St. Andrew Street EC4A 3AE London 5th United Kingdom | United Kingdom | British | |
| LANDS IMPROVEMENT COMPANY | 20. Feb. 2013 | 30. Juni 2014 | Aktiv | Geschäftsführer | Throgmorton Avenue EC2N 2DL London 12 United Kingdom | United Kingdom | British | |
| EMPIRE LIH LIMITED | 28. Juni 2011 | 30. Juni 2014 | Aktiv | Geschäftsführer | Sloane Avenue SW3 3XB London 60 England | United Kingdom | British | |
| LANDS IMPROVEMENT COMPANY | 28. Juni 2011 | 22. Sept. 2011 | Aktiv | Geschäftsführer | Sloane Avenue SW3 3XB London 60 United Kingdom | United Kingdom | British | |
| LANDS IMPROVEMENT HOLDINGS LIMITED | 28. Juni 2011 | 16. Aug. 2011 | Aktiv | Geschäftsführer | Sloane Avenue SW3 3XB London 60 United Kingdom | United Kingdom | British | |
| NMC1 LIMITED | 30. März 1999 | 10. Sept. 2003 | Aufgelöst | Geschäftsführer | 1 Pine Copse Close Duston NN5 6NF Northampton | United Kingdom | British | |
| NATIONWIDE BES FUND MANAGERS LIMITED | 27. Juli 1994 | 10. Sept. 2003 | Aufgelöst | Geschäftsführer | 1 Pine Copse Close Duston NN5 6NF Northampton | United Kingdom | British | |
| LE MARCHANT HEIGHTS RESIDENTS LIMITED | 17. Feb. 1998 | Aktiv | Geschäftsführer | 53 Rochelle Way Duston NN5 6YJ Northampton Northamptonshire | British | |||
| NATIONWIDE RENTED HOUSING LIMITED | 09. März 1995 | 10. März 1997 | Aufgelöst | Geschäftsführer | 53 Rochelle Way Duston NN5 6YJ Northampton Northamptonshire | British | ||
| BUCKINGHAM ASSURED PROPERTIES LIMITED | 30. Juli 1996 | 09. Dez. 1996 | Aktiv | Geschäftsführer | 53 Rochelle Way Duston NN5 6YJ Northampton Northamptonshire | British | ||
| THE KENTISH ASSURED PROPERTIES LIMITED | 30. Juli 1996 | 09. Dez. 1996 | Aufgelöst | Geschäftsführer | 53 Rochelle Way Duston NN5 6YJ Northampton Northamptonshire | British | ||
| ASHWORTH ASSURED TENANCIES LIMITED | 30. Juli 1996 | 09. Dez. 1996 | Aufgelöst | Geschäftsführer | 53 Rochelle Way Duston NN5 6YJ Northampton Northamptonshire | British | ||
| WYCOMBE HOMES LIMITED | 30. Juli 1996 | 09. Dez. 1996 | Aufgelöst | Geschäftsführer | 53 Rochelle Way Duston NN5 6YJ Northampton Northamptonshire | British | ||
| HAMPTON HILL HOMES LIMITED | 30. Juli 1996 | 09. Dez. 1996 | Aufgelöst | Geschäftsführer | 53 Rochelle Way Duston NN5 6YJ Northampton Northamptonshire | British | ||
| FIRST RENTED HOUSING GROUP LIMITED | 22. Aug. 1995 | 09. Dez. 1996 | Aktiv | Geschäftsführer | 53 Rochelle Way Duston NN5 6YJ Northampton Northamptonshire | British | ||
| BRISTOL INVESTMENT PROPERTIES LIMITED | 22. Aug. 1995 | 18. Sept. 1996 | Aktiv | Geschäftsführer | 53 Rochelle Way Duston NN5 6YJ Northampton Northamptonshire | British | ||
| PORT DINORWIC YACHT HARBOUR RESIDENTIAL ESTATE LIMITED | 20. Apr. 1996 | 07. Sept. 1996 | Aktiv | Geschäftsführer | 53 Rochelle Way Duston NN5 6YJ Northampton Northamptonshire | British | ||
| NUMBERPRESS LIMITED | 20. Apr. 1996 | 07. Sept. 1996 | Aktiv | Geschäftsführer | 53 Rochelle Way Duston NN5 6YJ Northampton Northamptonshire | British | ||
| NENE VALLEY TENANCIES LIMITED | 10. Sept. 1994 | 24. Mai 1995 | Aufgelöst | Sekretär | 53 Rochelle Way Duston NN5 6YJ Northampton Northamptonshire | British | ||
| NENE VALLEY TENANCIES LIMITED | 10. Sept. 1994 | 24. Mai 1995 | Aufgelöst | Geschäftsführer | 53 Rochelle Way Duston NN5 6YJ Northampton Northamptonshire | British | ||
| PRIORSLEIGH MANAGEMENT LIMITED | 05. Dez. 1994 | 24. Apr. 1995 | Aktiv | Geschäftsführer | 53 Rochelle Way Duston NN5 6YJ Northampton Northamptonshire | British | ||
| PRESBURY TENANCIES LIMITED | 20. Juli 1994 | 24. Apr. 1995 | Aufgelöst | Geschäftsführer | 53 Rochelle Way Duston NN5 6YJ Northampton Northamptonshire | British | ||
| SOLENT TENANCIES LIMITED | 25. Aug. 1994 | 19. Apr. 1995 | Aufgelöst | Geschäftsführer | 53 Rochelle Way Duston NN5 6YJ Northampton Northamptonshire | British | ||
| SOLENT TENANCIES LIMITED | 25. Aug. 1994 | 19. Apr. 1995 | Aufgelöst | Sekretär | 53 Rochelle Way Duston NN5 6YJ Northampton Northamptonshire | British | ||
| SEVERN HOUSE PROPERTIES LTD. | 13. Sept. 1994 | 29. März 1995 | Aufgelöst | Geschäftsführer | 53 Rochelle Way Duston NN5 6YJ Northampton Northamptonshire | British | ||
| THAMES VALLEY TENANCIES LIMITED | 10. Aug. 1994 | 10. März 1995 | Aufgelöst | Geschäftsführer | 53 Rochelle Way Duston NN5 6YJ Northampton Northamptonshire | British | ||
| DERMOUTH TENANCIES LTD | 05. Aug. 1994 | 10. März 1995 | Aufgelöst | Geschäftsführer | 53 Rochelle Way Duston NN5 6YJ Northampton Northamptonshire | British | ||
| MELVILLE ASSURED TENANCIES LIMITED | 14. Juli 1994 | 10. März 1995 | Aufgelöst | Geschäftsführer | 53 Rochelle Way Duston NN5 6YJ Northampton Northamptonshire | British | ||
| AYLESBURY HOMES LIMITED | 12. Juli 1994 | 10. März 1995 | Aufgelöst | Geschäftsführer | 53 Rochelle Way Duston NN5 6YJ Northampton Northamptonshire | British | ||
| THAMES VALLEY TENANCIES LIMITED | 10. Aug. 1994 | 25. Jan. 1995 | Aufgelöst | Sekretär | 53 Rochelle Way Duston NN5 6YJ Northampton Northamptonshire | British | ||
| DERMOUTH TENANCIES LTD | 05. Aug. 1994 | 25. Jan. 1995 | Aufgelöst | Sekretär | 53 Rochelle Way Duston NN5 6YJ Northampton Northamptonshire | British | ||
| AYLESBURY HOMES LIMITED | 12. Juli 1994 | 25. Jan. 1995 | Aufgelöst | Sekretär | 53 Rochelle Way Duston NN5 6YJ Northampton Northamptonshire | British | ||
| MELVILLE ASSURED TENANCIES LIMITED | 14. Juli 1994 | 23. Jan. 1995 | Aufgelöst | Sekretär | 53 Rochelle Way Duston NN5 6YJ Northampton Northamptonshire | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0