THE KENTISH ASSURED PROPERTIES LIMITED

THE KENTISH ASSURED PROPERTIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTHE KENTISH ASSURED PROPERTIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02335720
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von THE KENTISH ASSURED PROPERTIES LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich THE KENTISH ASSURED PROPERTIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Global House
    1 Ashley Avenue
    KT18 5FL Epsom
    Surrey
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THE KENTISH ASSURED PROPERTIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für THE KENTISH ASSURED PROPERTIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2018

    11 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr John Charles Bentlif South am 01. Juni 2018

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr John Charles Bentlif South am 01. Juni 2018

    1 SeitenCH03

    Erfüllung der Belastung 15 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 14 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2017

    10 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Nov. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift Global House 1 Ashley Avenue Epsom Surrey KT18 5FL verlegt

    1 SeitenAD04

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Valley View, Glebe Estate Glebe Estate Studland Swanage BH19 3AS England zum Knighton House Ferry Road Studland Swanage BH19 3AQ geändert

    1 SeitenAD02

    Bestätigungserklärung erstellt am 17. Jan. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Valley View, Glebe Estate Glebe Estate Studland Swanage BH19 3AS verlegt

    1 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Valley View, Glebe Estate Glebe Estate Studland Swanage BH19 3AS geändert

    1 SeitenAD02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Valley View Glebe Estate Studland Dorset BH19 3AS zum Global House 1 Ashley Avenue Epsom Surrey KT18 5FL am 22. Sept. 2016

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2016

    9 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital11. Feb. 2016

    Kapitalaufstellung am 11. Feb. 2016

    • Kapital: GBP 850,022
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2015

    9 SeitenAA

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    4 SeitenMA

    Beschlüsse

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Gesellschaftervereinbarung

    RES01
    capital

    Beschlüsse

    Co need not hold an annual general meeting 06/03/2015
    RES13

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital18. Jan. 2015

    Kapitalaufstellung am 18. Jan. 2015

    • Kapital: GBP 850,022
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2014

    9 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. Feb. 2014

    Kapitalaufstellung am 12. Feb. 2014

    • Kapital: GBP 850,022
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2013

    9 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von THE KENTISH ASSURED PROPERTIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SOUTH, John Charles Bentlif
    Ferry Road
    Studland
    BH19 3AQ Swanage
    Knighton House
    England
    Sekretär
    Ferry Road
    Studland
    BH19 3AQ Swanage
    Knighton House
    England
    British21451100002
    BURGESS, Richard John
    54 Manor Road
    SM2 7AG Cheam
    Surrey
    Geschäftsführer
    54 Manor Road
    SM2 7AG Cheam
    Surrey
    United Kingdom ( England ) (Gb-Eng)British35427700001
    SOUTH, John Charles Bentlif
    Ferry Road
    Studland
    BH19 3AQ Swanage
    Knighton House
    England
    Geschäftsführer
    Ferry Road
    Studland
    BH19 3AQ Swanage
    Knighton House
    England
    EnglandBritish21451100005
    FAITH, John Stephen
    The Granary
    Titchbourne Farm
    SP5 2JX Redlynch
    Wiltshire
    Sekretär
    The Granary
    Titchbourne Farm
    SP5 2JX Redlynch
    Wiltshire
    British60500080001
    FATH, Wendy Butler
    Flat 4 Claremont Hall
    Highdale Road
    BS21 7LW Clevedon
    Avon
    Sekretär
    Flat 4 Claremont Hall
    Highdale Road
    BS21 7LW Clevedon
    Avon
    British41883380001
    NOWELL, Stephen Gerrard
    Belmont Abson Road
    Pucklechurch
    BS16 9SD Bristol
    Sekretär
    Belmont Abson Road
    Pucklechurch
    BS16 9SD Bristol
    British55554710001
    TREVELYAN, Michael Charles Edward
    12 Church Lane
    Backwell
    BS19 3PQ Bristol
    Avon
    Sekretär
    12 Church Lane
    Backwell
    BS19 3PQ Bristol
    Avon
    British2706360001
    ZANT BOER, Ian
    Garden Cottage
    Little Court
    NN12 8HE Farthingstone
    Northamptonshire
    Sekretär
    Garden Cottage
    Little Court
    NN12 8HE Farthingstone
    Northamptonshire
    British80009300004
    COOK, Graham Ronald
    Barclosh
    DG5 4PL Dalbeattie
    Kirkcudbrightshire
    Geschäftsführer
    Barclosh
    DG5 4PL Dalbeattie
    Kirkcudbrightshire
    United KingdomBritish1233160001
    CORNISH, John Frederick Dadds
    Rosemont Church Road
    Leigh Woods
    BS8 3PG Bristol
    Avon
    Geschäftsführer
    Rosemont Church Road
    Leigh Woods
    BS8 3PG Bristol
    Avon
    British19019770001
    FAITH, John Stephen
    The Granary
    Titchbourne Farm
    SP5 2JX Redlynch
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    The Granary
    Titchbourne Farm
    SP5 2JX Redlynch
    Wiltshire
    British60500080001
    HORSTED, James
    Deshure
    11a Ryecroft Way Stopsley
    LU2 7TU Luton
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    Deshure
    11a Ryecroft Way Stopsley
    LU2 7TU Luton
    Bedfordshire
    British34994810002
    MANSFIELD, Linda Marjorie
    11 Hopkins Close
    Milton Keynes Village
    MK10 9AS Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    11 Hopkins Close
    Milton Keynes Village
    MK10 9AS Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British42338210001
    NEAVES, Barry James
    40 Barrington Road
    NN10 0NJ Rushden
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    40 Barrington Road
    NN10 0NJ Rushden
    Northamptonshire
    British44749950001
    SUMPTON, Elaine Mary
    1 Malcolm Drive
    NN5 5NN Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    1 Malcolm Drive
    NN5 5NN Northampton
    Northamptonshire
    British42468750001
    TREVELYAN, Michael Charles Edward
    12 Church Lane
    Backwell
    BS19 3PQ Bristol
    Avon
    Geschäftsführer
    12 Church Lane
    Backwell
    BS19 3PQ Bristol
    Avon
    British2706360001
    TYNAN, Anthony Patrick
    Keswick House Orchard Drive
    Weavering
    ME14 5JG Maidstone
    Kent
    Geschäftsführer
    Keswick House Orchard Drive
    Weavering
    ME14 5JG Maidstone
    Kent
    EnglandBritish4220230001
    TYNAN, Barry Thomas
    Two Oaks Faversham Road
    Charing
    TN27 0NS Ashford
    Kent
    Geschäftsführer
    Two Oaks Faversham Road
    Charing
    TN27 0NS Ashford
    Kent
    United KingdomBritish3115490001
    WILLINGHAM, Steven Craig
    53 Rochelle Way
    Duston
    NN5 6YJ Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    53 Rochelle Way
    Duston
    NN5 6YJ Northampton
    Northamptonshire
    British63092720002
    WOOD, David James
    13 Vermuyden Way
    Fen Drayton
    CB4 5TA Cambridge
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    13 Vermuyden Way
    Fen Drayton
    CB4 5TA Cambridge
    Cambridgeshire
    British19531650001
    ZANT BOER, Ian
    Garden Cottage
    Little Court
    NN12 8HE Farthingstone
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Garden Cottage
    Little Court
    NN12 8HE Farthingstone
    Northamptonshire
    EnglandBritish80009300004

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei THE KENTISH ASSURED PROPERTIES LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    First Rented Housing Group Limited
    Ashley Avenue
    KT18 5FL Epsom
    Global House
    England
    06. Apr. 2016
    Ashley Avenue
    KT18 5FL Epsom
    Global House
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageEnglish
    RegistrierungsortCardiff
    Registrierungsnummer02307652
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat THE KENTISH ASSURED PROPERTIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A standard security which was presented for registration in scotland on 21ST february 2003 and
    Erstellt am 14. Feb. 2003
    Geliefert am 26. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    36 (1F2) william street edinburgh.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 26. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juni 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 14. Feb. 2003
    Geliefert am 21. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 21. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juni 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Feb. 2003
    Geliefert am 18. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold 41 crownfields grove green maidstone K670623 and the old mill salem road johnstown carmarthen CYM53889. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 18. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 06. März 1998
    Geliefert am 14. März 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from everdon limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22 and 23 hill house farm salisbury terrace norton stockton-on-tees t/nos CE116143 CE116144 CE116145 CE116146 for further details of title numbers see form 395. together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 14. März 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 09. Dez. 1996
    Geliefert am 18. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    2,4 & 6 meadowdown grove green maidstone kent, 4 & 11 haywain close maidstone, 7,25,39,41 & 45 crownfields grove green maidstone. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 18. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party charge
    Erstellt am 09. Dez. 1996
    Geliefert am 17. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from everdon limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 4 meadowdown grove green maidstone kent t/n K670630 and together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time on that property and the goodwill of any business carried on on that property together with the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 17. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 21. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party charge
    Erstellt am 09. Dez. 1996
    Geliefert am 17. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from everdon limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 11 haywain close grove green maidstone kent t/n K680286 and together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time on that property and the goodwill of any business carried on on that property together with the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 17. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party charge
    Erstellt am 09. Dez. 1996
    Geliefert am 17. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from everdon limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 6 meadowdown grove green maidstone kent t/n K677013 and together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time on that property and the goodwill of any business carried on on that property together with the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 17. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party charge
    Erstellt am 09. Dez. 1996
    Geliefert am 17. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from everdon limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 25 crownfields grove green maidstone kent t/n K670625 and together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time on that property and the goodwill of any business carried on on that property together with the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 17. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party charge
    Erstellt am 09. Dez. 1996
    Geliefert am 17. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from everdon limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 7 crownfields grove green maidstone kent t/n K670626 and together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time on that property and the goodwill of any business carried on on that property together with the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 17. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party charge
    Erstellt am 09. Dez. 1996
    Geliefert am 17. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from everdon limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 39 crownfields grove green maidstone kent t/n K670627 and together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time on that property and the goodwill of any business carried on on that property together with the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 17. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party charge
    Erstellt am 09. Dez. 1996
    Geliefert am 17. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from everdon limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 45 crownfields grove green maidstone kent t/no.K670631 together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery goodwill of any business together with the benefit of any licences.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 17. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party charge
    Erstellt am 09. Dez. 1996
    Geliefert am 17. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from everdon limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 41 crownfields grove green maidstone kent t/no.K670623 together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery goodwill of any business together with the benefit of any licences.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 17. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party charge
    Erstellt am 09. Dez. 1996
    Geliefert am 17. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from everdon limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    2 meadoedown grove green maidstone kent t/no.K670629 together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery goodwill of any business together with the benefit of any licences.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 17. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party charge
    Erstellt am 09. Dez. 1996
    Geliefert am 17. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from everdon limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 4 haywain close grove geen maidstone kent t/no.K670632 and together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery goodwill of any business together with the benefit of any licences.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 17. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Sept. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 21. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat THE KENTISH ASSURED PROPERTIES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    30. Sept. 1994Erklärung der Zahlungsfähigkeit geleistet am
    30. Sept. 1994Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0