Martin Gerard MULLIN
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | Martin |
Zweites Vornamen | Gerard |
Nachname | MULLIN |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 2 |
Inaktiv | 9 |
Zurückgetreten | 16 |
Gesamt | 27 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COOPER INDUSTRIES UK SUBCO LIMITED | 03. Juli 2020 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Tancred Close CV31 3RZ Leamington Spa 6 Jephson Court Warwickshire England | England | British | |
THE LAKE DISTRICT CALVERT TRUST | 26. Nov. 2016 | Aktiv | Senior Vice President And General Manager | Geschäftsführer | Almond Close LE11 2DG Loughborough 2 Almond Close England | England | British | |
ELLIS PATENTS HOLDINGS LIMITED | 14. Jan. 2016 | Aktiv | Senior Vp & Gm | Geschäftsführer | High Street Rillington YO17 8LA Malton Ellis Patents Holdings Ltd North Yorkshire | England | British | |
REDAPT ENGINEERING CO. LIMITED | 10. Juni 2015 | Aufgelöst | Vice President & Gm | Geschäftsführer | Tancred Close CV31 3RZ Leamington Spa Jephson Court Warwickshire England | England | British | |
MOUNT ENGINEERING LIMITED | 10. Juni 2015 | Aufgelöst | Vice President & Gm | Geschäftsführer | Tancred Close CV31 3RZ Leamington Spa Jephson Court Warwickshire England | England | British | |
BROOMCO (1644) LIMITED | 08. Juni 2015 | Aufgelöst | Vice President & Gm | Geschäftsführer | Tancred Close CV31 3RZ Leamington Spa Jephson Court Warwickshire England | England | British | |
MOUNT (YORK) LIMITED | 28. Mai 2015 | Aufgelöst | Vice President & Gm | Geschäftsführer | Tancred Close Queensway CV31 3RZ Leamington Spa Jephson Court Warwickshire England | England | British | |
CROMPTON LIGHTING INTERNATIONAL LIMITED | 01. Aug. 2011 | Aufgelöst | Business Executive | Geschäftsführer | c/o Cooper Lighting And Safety Limited Wheatley Hall Road DN2 4NB Doncaster South Yorkshire | England | British | |
CROMPTON LIGHTING HOLDINGS LIMITED | 01. Aug. 2011 | Aufgelöst | Business Executive | Geschäftsführer | c/o Cooper Lighting And Safety Limited Wheatley Hall Road DN2 4NB Doncaster South Yorkshire | England | British | |
SCANTRONIC LIMITED | 28. Juli 2011 | Aufgelöst | Business Executive | Geschäftsführer | c/o Cooper Lighting And Safety Limited Wheatley Hall Road DN2 4NB Doncaster South Yorkshire | England | British | |
MENVIER SECURITY LIMITED | 28. Juli 2011 | Aufgelöst | Business Exective | Geschäftsführer | c/o Cooper Lighting And Safety Limited Wheatley Hall Road DN2 4NB Doncaster South Yorkshire | England | British | |
EATON SAFETY LIMITED | 03. Juli 2020 | 18. Dez. 2020 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Jephson Court Tancred Close Queeensway CV31 3RZ Royal Leamingtonton Spa Warwickshire | England | British |
EATON ELECTRICAL PRODUCTS LIMITED | 03. Juli 2020 | 18. Dez. 2020 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Jephson Court Tancred Close Queensway CV31 3RZ Royal Leamington Spa Warwickshire | England | British |
EATON HOLDING (UK) II LIMITED | 03. Juli 2020 | 18. Dez. 2020 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Jephson Court Tancred Close Queensway CV31 3RZ Royal Leamington Spa Warwickshire | England | British |
EATON INDUSTRIES (ENGLAND) LIMITED | 08. Juni 2015 | 18. Dez. 2020 | Aktiv | Vice President & Gm | Geschäftsführer | Tancred Close Queensway CV31 3RZ Royal Leamington Spa Jephson Court Warwickshire | England | British |
EATON ELECTRIC LIMITED | 10. Okt. 2013 | 18. Dez. 2020 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Southampton Road Titchfield 554 PO14 4QA Fareham Abbey Park England | England | British |
EATON ELECTRICAL SYSTEMS LIMITED | 01. Feb. 2010 | 18. Dez. 2020 | Aktiv | Business Executive | Geschäftsführer | c/o Cooper Lighting And Safety Limited Wheatley Hall Road DN2 4NB Doncaster South Yorkshire | England | British |
MENVIER OVERSEAS HOLDINGS LIMITED | 03. Juli 2020 | 18. Dez. 2020 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Jephson Court Tancred Close Queensway CV31 3RZ Royal Leamington Spa Warwickshire | England | British |
SCANTRONIC HOLDINGS LIMITED | 03. Juli 2020 | 18. Dez. 2020 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Jephson Court Tancred Close Queensway CV31 3RZ Royal Leamington Spa Warwickshire | England | British |
EATON LIMITED | 10. Okt. 2013 | 29. Sept. 2020 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Southampton Road Titchfield 554 PO14 4QA Fareham Abbey Park England | England | British |
BLESSING INTERNATIONAL B.V. | 15. Juni 2014 | 30. Juni 2015 | Umwandlung / Auflösung | Vice President & Gm | Geschäftsführer | Jephson Court Tancred Close CV31 3RZ Royal Leamington Spa Eaton Safety Limited Warwickshire United Kingdom | England | British |
EATON HOLDING (UK) II LIMITED | 22. März 2014 | 22. Juni 2015 | Aktiv | Business Executive | Geschäftsführer | Wheatley Hall Road DN2 4NB Doncaster C/O Cooper Lighting And Safety Limited South Yorkshire United Kingdom | England | British |
SCANTRONIC HOLDINGS LIMITED | 01. Aug. 2011 | 10. Juni 2015 | Aufgelöst | Business Executive | Geschäftsführer | c/o Cooper Lighting And Safety Limited Wheatley Hall Road DN2 4NB Doncaster South Yorkshire | England | British |
EATON SAFETY LIMITED | 22. März 2014 | 28. Mai 2015 | Aktiv | Vice President & Gm | Geschäftsführer | Tancred Close CV31 3RZ Leamington Spa Jephson Court Warwickshire England | England | British |
COOPER (UK) GROUP LIMITED | 22. März 2014 | 28. Mai 2015 | Aufgelöst | Business Executive | Geschäftsführer | Tancred Close CV31 3RZ Leamington Spa Jephson Court Warwickshire England | England | British |
COOPER SECURITY LIMITED | 01. Aug. 2011 | 28. Mai 2015 | Aufgelöst | Vice President & Gm | Geschäftsführer | Tancred Close CV31 3RZ Leamington Spa Jephson Court Warwickshire England | England | British |
SCANTRONIC INTERNATIONAL LIMITED | 28. Juli 2011 | 28. Mai 2015 | Aufgelöst | Vice President & Gm | Geschäftsführer | Tancred Close CV31 3RZ Leamington Spa Jephson Court Warwickshire England | England | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0