COOPER SECURITY LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | COOPER SECURITY LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01396471 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von COOPER SECURITY LIMITED?
- Herstellung von Kommunikationseinrichtungen, außer Telegraphen- und Telefonapparaten und -geräten (26309) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich COOPER SECURITY LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Jephson Court Tancred Close Queensway CV31 3RZ Royal Leamington Spa Warwickshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von COOPER SECURITY LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SCANTRONIC LIMITED | 31. Dez. 1979 | 31. Dez. 1979 |
| BROOKEXPRESS LIMITED | 27. Okt. 1978 | 27. Okt. 1978 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von COOPER SECURITY LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für COOPER SECURITY LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Widerruf des Antrags auf Löschung der Gesellschaft | 1 Seiten | DS02 | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Juli 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 23 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Juli 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Cessation of Scantronic Holdings Limited as a person with significant control on 28. Juli 2016 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Notification of Eaton Electrical Products Limited as a person with significant control on 30. Juni 2016 | 1 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Andrew Jackson als Direktor am 08. Mai 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Anthony Walsh als Geschäftsführer am 08. Mai 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 24 Seiten | AA | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 100 New Bridge Street London EC4V 6JA zum Jephson Court Tancred Close Leamington Spa CV31 3RZ geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Juli 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 04. Aug. 2016
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Abogado Nominees Limited als Sekretär am 10. Feb. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr. Richard Howes als Direktor am 28. Mai 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr. Anthony Walsh als Direktor am 28. Mai 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Martin Gerard Mullin als Geschäftsführer am 28. Mai 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von COOPER SECURITY LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOWES, Richard Paul | Geschäftsführer | Tancred Close CV31 3RZ Leamington Spa Jephson Court Warwickshire England | United Kingdom | British | 198769780001 | |||||||||
| JACKSON, Andrew | Geschäftsführer | Jephson Court Tancred Close Queensway CV31 3RZ Royal Leamington Spa Warwickshire | England | British | 199276600001 | |||||||||
| DIAS, Raymond | Sekretär | 1 Castlereagh House Lady Aylesford Avenu HA7 4FP Stanmore Middlesex | British | 102027890001 | ||||||||||
| DICKS, Karen Dawn | Sekretär | 39 Orchard Way Churchdown GL3 2AP Gloucester Gloucestershire | British | 42695110001 | ||||||||||
| HELZ, Terrance Valentine | Sekretär | 11 China Rose Court The Woodlands Texas 77381 Usa | American | 61652840001 | ||||||||||
| HERBERT, Karen Elizabeth | Sekretär | 10 Aylesbury Court 77479 Sugarland Texas America | British | 37383450001 | ||||||||||
| JAMES, Gavin Keith | Sekretär | Gable House Church End CV23 8SN Priors Hardwick Warwickshire | British | 44173560002 | ||||||||||
| JARRETT, Marilyn Frances | Sekretär | 47 Warkworth Close OX16 1BD Banbury Oxfordshire | British | 64181020001 | ||||||||||
| JENKINS, Hywel Probert | Sekretär | 9 Ross Court Cleveland Road Ealing W13 8ED London | British | 98800060001 | ||||||||||
| ABOGADO NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 100 New Bridge Street EC4V 6JA London |
| 900021150001 | ||||||||||
| ALLEN, Anthony Thaddeus | Geschäftsführer | Hillside Llansoy NP15 1DF Usk Gwent | Wales | British | 64198880001 | |||||||||
| BEYEN, Kris Maria August | Geschäftsführer | Tancred Close Queensway CV31 3RZ Royal Leamington Spa Jephson Court Warwickshire | United Kingdom | Belgian | 157565820001 | |||||||||
| BROOKES, Christopher | Geschäftsführer | Woodacres Nightingales Lane HP8 4SG Chalfont St Giles Buckinghamshire | British | 16102860001 | ||||||||||
| BROWN, David Edward | Geschäftsführer | 35 Hatchet Lane Stonely PE19 5EG St Neots Cambridgeshire | United Kingdom | British | 16178630001 | |||||||||
| CLEMENTSON, Mark Chris | Geschäftsführer | 2 Elliotts Orchard CV35 8ED Barford Warwickshire | Us | 83533510001 | ||||||||||
| DAVIDSON, Gregory Paul | Geschäftsführer | 3 The Swallow Wellington Heath HR8 1NA Ledbury Herefordshire | British | 43114160003 | ||||||||||
| DIAS, Raymond | Geschäftsführer | 1 Castlereagh House Lady Aylesford Avenu HA7 4FP Stanmore Middlesex | United Kingdom | British | 102027890001 | |||||||||
| DICKS, Karen Dawn | Geschäftsführer | 39 Orchard Way Churchdown GL3 2AP Gloucester Gloucestershire | British | 42695110001 | ||||||||||
| FLETCHER, Michael Alistair | Geschäftsführer | 81 Thames Avenue SN25 3NS Swindon Wiltshire | British | 70180240001 | ||||||||||
| FLETCHER, Roger Barrett | Geschäftsführer | The Knowle North Newington OX15 6AN Banbury Oxfordshire | British | 16260890002 | ||||||||||
| FRASER, Michael Ashley | Geschäftsführer | Middle Barn Front Street Chedzoy TA7 8RE Bridgwater Somerset | British | 6677020001 | ||||||||||
| GASCOIGNE, Alan John | Geschäftsführer | 1 Silver Birches Lincoln Hill HR9 7UX Ross On Wye Herefordshire | English | 43087980002 | ||||||||||
| GAWRONSKI, Grant Lawrence | Geschäftsführer | 19 Hunters Crossing Court The Woodlands Texas 77381 Usa | Usa | American | 115387690001 | |||||||||
| HAACK, Axel Gottfried Gunther | Geschäftsführer | 9 Haute Corniche 67210 Obernai France | German | 120071580001 | ||||||||||
| HURST, Barrie | Geschäftsführer | Norwood Chapel Lane Bodicote OX15 4DB Banbury Oxfordshire | England | British | 16260900001 | |||||||||
| JAMES, Gavin Keith | Geschäftsführer | Gable House Church End CV23 8SN Priors Hardwick Warwickshire | British | 44173560002 | ||||||||||
| JENKINS, Hywel Probert | Geschäftsführer | 9 Ross Court Cleveland Road Ealing W13 8ED London | British | 98800060001 | ||||||||||
| KNEIS, Thomas David | Geschäftsführer | 5 Cranborne Close Belmont HR2 7SY Hereford | American | 53129310002 | ||||||||||
| KNOX, Kenneth George | Geschäftsführer | 13 Guinea Court Chineham RG24 8XJ Basingstoke Hampshire | British | 14940570001 | ||||||||||
| LOWREY, David Henry Tyson | Geschäftsführer | The Granary Hazel Farm Barn HR8 2HT Ledbury | United Kingdom | British | 122583430001 | |||||||||
| LUNN, David William | Geschäftsführer | New House GL16 7PD English Bicknor Gloucestershire | England | British | 121935710001 | |||||||||
| MULLIN, Martin Gerard | Geschäftsführer | Tancred Close CV31 3RZ Leamington Spa Jephson Court Warwickshire England | England | British | 150271550001 | |||||||||
| REES, James Warren | Geschäftsführer | Birchley House Birchley Road Battledown GL52 6NY Cheltenham Gloucestershire | British | 59758530001 | ||||||||||
| RIPLEY, David Arthur | Geschäftsführer | 4 Lyme Park Chinley SK23 6AG High Peak Derbyshire | England | British | 83533780001 | |||||||||
| SCRIMSHAW, James Eric | Geschäftsführer | Dove House Temple Grafton B49 6NT Alcester Warwickshire | British | 60793220002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei COOPER SECURITY LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scantronic Holdings Limited | 28. Juli 2016 | Tancred Close CV31 3RZ Leamington Spa Jephson Court England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Eaton Electrical Products Limited | 30. Juni 2016 | Tancred Close CV31 3RZ Leamington Spa 6 Jephson Court England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat COOPER SECURITY LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee and debenture | Erstellt am 06. Okt. 1994 Geliefert am 14. Okt. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. Okt. 1993 Geliefert am 21. Okt. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. Feb. 1988 Geliefert am 24. Feb. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 06. Juli 1980 Geliefert am 16. Juli 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital. Together with all fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0