Brendan George Harvey BATT - Seite 2
Natürliche Person
| Titel | Mr |
|---|---|
| Vorname | Brendan |
| Zweites Vornamen | George Harvey |
| Nachname | BATT |
| Geburtsdatum | |
| Ist Unternehmensleiter | Nein |
| Ernennungen | |
| Aktiv | 8 |
| Inaktiv | 21 |
| Zurückgetreten | 100 |
| Gesamt | 129 |
Ernennungen
| Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WENMAN CARPENTRY LTD | 06. Feb. 2017 | 14. Jan. 2020 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Lees Lane PO12 3UL Gosport A24 The Sanderson Centre England | United Kingdom | British |
| GAS & HEATING SERVICES LTD | 06. Feb. 2017 | 05. Dez. 2019 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Lees Lane PO12 3UL Gosport A24 The Sanderson Centre England | United Kingdom | British |
| WILLIAMS USED CARS LTD | 08. Juni 2012 | 05. Sept. 2019 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | c/o Britannia Accountancy & Tax Services Ltd & A69 The Sanderson Centre Lees Lane PO12 3UL Gosport A66 Hampshire England | United Kingdom | British |
| OLDFIELD AIR CONDITIONING LTD | 06. Feb. 2017 | 24. Juli 2019 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Lees Lane PO12 3UL Gosport A24 The Sanderson Centre England | United Kingdom | British |
| KP CARPETS & FLOORING LTD | 21. Nov. 2016 | 24. Juli 2019 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Lees Lane PO12 3UL Gosport A24, The Sanderson Centre England | United Kingdom | British |
| RRMW LTD | 05. Mai 2016 | 24. Okt. 2018 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | c/o Britannia Accountancy & Tax Services Ltd The Sanderson Centre Lees Lane PO12 3UL Gosport A66 & A69, Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British |
| ERNEST SMITH LTD | 06. Feb. 2017 | 11. Okt. 2018 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | c/o Britannia Accountancy & Tax Services Ltd The Sanderson Centre, Lees Lane PO12 3UL Gosport A66 & A69, United Kingdom | United Kingdom | British |
| YNEZ LTD | 06. Feb. 2017 | 06. Juni 2018 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | c/o Britannia Accountancy & Tax Services Ltd The Sanderson Centre, Lees Lane PO12 3UL Gosport A66 & A69, United Kingdom | United Kingdom | British |
| AMBER NETWORKS LTD | 23. Juni 2017 | 01. Apr. 2018 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | Lees Lane PO12 3UL Gosport A24, The Sanderson Centre England | United Kingdom | British |
| ALLFIX PROPERTY SOLUTIONS LTD | 08. Juni 2017 | 21. März 2018 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | c/o Britannia Accountancy & Tax Services Ltd The Sanderson Centre Lees Lane PO12 3UL Gosport A66 & A69 Hampshire | United Kingdom | British |
| KEVIN PERRY LTD | 06. Feb. 2017 | 07. März 2018 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | c/o Britannia Accountancy & Tax Services Ltd The Sanderson Centre, Lees Lane PO12 3UL Gosport A66 & A69, United Kingdom | United Kingdom | British |
| 1ST CHOICE RUBBISH CLEARANCE LTD | 19. Apr. 2016 | 05. Mai 2017 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | c/o Britannia Accountancy & Tax Services Ltd The Sanderson Centre Lees Lane PO12 3UL Gosport A66 & A69, Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British |
| KK DUCTWORK LTD | 20. Apr. 2017 | 21. Apr. 2017 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | The Sanderson Centre, Lees Lane PO12 3UL Gosport A66 Hampshire England | United Kingdom | British |
| DCM CARPENTRY LTD | 20. Apr. 2017 | 20. Apr. 2017 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | The Sanderson Centre, Lees Lane PO12 3UL Gosport A66 Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British |
| D C HOME IMPROVEMENTS LTD | 06. Feb. 2017 | 01. Apr. 2017 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | c/o Britannia Accountancy & Tax Services Ltd The Sanderson Centre, Lees Lane PO12 3UL Gosport A66 & A69, United Kingdom | United Kingdom | British |
| TESLA ELECTRICAL LTD | 06. Feb. 2017 | 01. Apr. 2017 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | c/o Britannia Accountancy & Tax Services Ltd The Sanderson Centre, Lees Lane PO12 3UL Gosport A66 & A69, United Kingdom | United Kingdom | British |
| LANDSCAPING (SOUTHERN) LTD | 06. Feb. 2017 | 01. Apr. 2017 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | c/o Britannia Accountancy & Tax Services Ltd The Sanderson Centre, Lees Lane PO12 3UL Gosport A66 & A69, United Kingdom | United Kingdom | British |
| TWO UTILITIES LTD | 05. Dez. 2016 | 10. Dez. 2016 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | c/o Csg Consultancy Ltd The Sanderson Centre, Lees Lane PO12 3UL Gosport Unit A66 The Sanderson Centre United Kingdom | United Kingdom | British |
| ALLFIX PROPERTY SOLUTIONS LTD | 05. Nov. 2014 | 19. Aug. 2016 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Westfield Road PO12 3RU Gosport 28 Hampshire England | United Kingdom | British |
| JB ELECTRIC CONTRACTORS LTD | 12. Juni 2014 | 14. Juli 2016 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | c/o Britannia Accountancy & Tax Services Ltd The Sanderson Centre Lees Lane PO12 3UL Gosport A66 & A69, Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British |
| BEAUTY WITHIN LTD | 11. Juni 2013 | 12. Juni 2016 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | c/o Britannia Accountancy & Tax Services Ltd & A69 The Sanderson Centre Lees Lane PO12 3UL Gosport A66 Hampshire England | United Kingdom | British |
| A&A PROPERTY MAINTENANCE (HANTS) LTD | 04. Sept. 2015 | 01. Apr. 2016 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | c/o Britannia Accountancy & Tax Services Ltd & A69 The Sanderson Centre Lees Lane PO12 3UL Gosport A66 Hampshire | United Kingdom | British |
| JACOBS HOUSE LTD | 13. Apr. 2015 | 15. März 2016 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | c/o Britannia Accountancy & Tax Services Ltd The Sanderson Centre Lees Lane PO12 3UL Gosport A66 & A69, Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British |
| PMG CONTRACT CONSULTANCY LTD | 17. Sept. 2015 | 01. März 2016 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | c/o Britannia Accountancy & Tax Services Ltd & A69 The Sanderson Centre Lees Lane PO12 3UL Gosport A66 Hampshire | United Kingdom | British |
| VIC GLOBAL LTD | 25. Sept. 2015 | 29. Jan. 2016 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | c/o Britannia Accountancy & Tax Services Ltd The Sanderson Centre Lees Lane PO12 3UL Gosport A66 & A69, Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British |
| FELTFIX ROOFING LTD | 21. Jan. 2016 | 22. Jan. 2016 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | c/o Britannia Accountancy & Tax Services Ltd The Sanderson Centre Lees Lane PO12 3UL Gosport A66 & A69, Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British |
| CARTER & SONS ELECTRICAL LTD | 25. Sept. 2015 | 22. Nov. 2015 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | c/o Britannia Accountancy & Tax Services Ltd The Sanderson Centre Lees Lane PO12 3UL Gosport A66 & A69, Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British |
| THE PHOENIX CLUB LTD | 31. Dez. 2013 | 21. Nov. 2015 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | c/o Britannia Accountancy & Tax Services Ltd The Sanderson Centre Lees Lane PO12 3UL Gosport A66 & A69 Hampshire England | United Kingdom | British |
| UK BLINDS & SHUTTERS LTD | 19. Okt. 2012 | 20. Okt. 2015 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | c/o Britannia Accountancy & Tax Services Ltd & A69 The Sanderson Centre Lees Lane PO12 3UL Gosport A66 Hampshire England | United Kingdom | British |
| WISE WORDS PUBLICATIONS LTD | 28. Jan. 2015 | 11. März 2015 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | c/o Britannia Accountancy & Tax Services Ltd The Sanderson Centre Lees Lane PO12 3UL Gosport A66 & A69, Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British |
| VIC GLOBAL LTD | 28. Jan. 2015 | 02. Feb. 2015 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | c/o Britannia Accountancy & Tax Services Ltd The Sanderson Centre Lees Lane PO12 3UL Gosport A66 & A69, Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British |
| NEIN TAILS LTD | 21. Mai 2014 | 28. Mai 2014 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | c/o Britannia Accountancy & Tax Services Ltd The Sanderson Centre Lees Lane PO12 3UL Gosport A66 & A69 Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British |
| BLUE TIN PRODUCE LTD | 11. Apr. 2014 | 12. Apr. 2014 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | c/o Britannia Accountancy & Tax Services Ltd The Sanderson Centre Lees Lane PO12 3UL Gosport A66 & A69 Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British |
| JEFF BODLE PLUMBING SERVICES LTD | 28. März 2012 | 05. März 2014 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | c/o Britannia Accountancy & Tax Services Ltd & A69 The Sanderson Centre Lees Lane PO12 3UL Gosport A66 Hampshire England | United Kingdom | British |
| TOWNSON CONSULTING (FAREHAM) LTD | 22. Juni 2012 | 05. Feb. 2014 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | c/o Britannia Accountancy & Tax Services Ltd & A69 The Sanderson Centre Lees Lane PO12 3UL Gosport A66 Hampshire England | United Kingdom | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0