• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Ian Kendall CATTERMOLE

    Natürliche Person

    TitelMr
    VornameIan
    Zweites VornamenKendall
    NachnameCATTERMOLE
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv0
    Inaktiv8
    Zurückgetreten77
    Gesamt85

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    LIFE HEALTHCARE INVESTMENTS PLC02. Feb. 2017AufgelöstCompany SecretaryGeschäftsführer
    Warwick Technology Park
    CV34 6DA Warwick
    Iceni Centre
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    ALLIANCE FRIEND SWAPCO LIMITED17. Mai 2012AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    Iceni Centre
    Warwick Technology Park
    CV34 6DA Warwick
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    RADIOLOGY MANAGEMENT SERVICES LIMITED17. Mai 2012AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    Iceni Centre
    Warwick Technology Park
    CV34 6DA Warwick
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    ALLIANCE MEDICAL POLAND LIMITED17. Mai 2012AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    Iceni Centre
    Warwick Technology Park
    CV34 6DA Warwick
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    ALLIANCE MEDICAL LEASING LIMITED17. Mai 2012AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    Iceni Centre
    Warwick Technology Park
    CV34 6DA Warwick
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    OLD AMGL INTERESTS LIMITED20. Juni 2011AufgelöstCompany SecretaryGeschäftsführer
    c/o Alliance Medical Group Limited
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Iceni Centre
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish
    ALLIANCE MEDICAL FINANCE CO. LIMITED25. Jan. 2011AufgelöstCompany SecretaryGeschäftsführer
    Iceni Centre
    Warwick Technology Park
    CV34 6DA Warwick
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    ALLIANCE MEDICAL ACQUISITIONCO (OLD) LIMITED25. Jan. 2011AufgelöstCompany SecretaryGeschäftsführer
    Iceni Centre
    Warwickshire Technology Park
    CV34 6DA Warwick
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    ALLIANCE MEDICAL LEASING LIMITED30. Mai 201401. Sept. 2018AktivDirectorGeschäftsführer
    c/o Alliance Medical
    Warwick Technology Park
    Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Iceni Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    ALLIANCE MEDICAL HOLDINGS LIMITED17. Mai 201201. Sept. 2018AktivDirectorGeschäftsführer
    Iceni Centre
    Warwickshire Technology Park
    CV34 6DA Warwick
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    ALLIANCE MEDICAL GROUP LIMITED05. Okt. 201101. Sept. 2018AktivCompany SecretaryGeschäftsführer
    Warwick Technology Park
    CV34 6DA Warwick
    Iceni Centre
    United KingdomBritish
    ALLIANCE MEDICAL RADIOPHARMACY LIMITED03. Mai 201103. Okt. 2013AktivChartered SecretaryGeschäftsführer
    Warwick Technical Park
    CV34 6DA Warwick
    Iceni Centre
    United KingdomBritish
    CLERMONT HOTEL MANAGEMENT LIMITED03. Dez. 200727. Juni 2008AktivChartered SecretaryGeschäftsführer
    Swallow Cottage
    Main Road North
    HP4 1QZ Dagnall
    Herts
    United KingdomBritish
    CLEARFLIGHT LIMITED01. Nov. 200627. Juni 2008AktivSekretär
    Swallow Cottage
    Main Road North
    HP4 1QZ Dagnall
    Herts
    British
    THE CLERMONT CLUB LIMITED24. Okt. 200627. Juni 2008AktivSekretär
    Swallow Cottage
    Main Road North
    HP4 1QZ Dagnall
    Herts
    British
    CLERMONT LEISURE (UK) LIMITED12. Sept. 200627. Juni 2008AktivSekretär
    Swallow Cottage
    Main Road North
    HP4 1QZ Dagnall
    Herts
    British
    BLOOMSBURY HOTEL (LONDON) LIMITED09. Dez. 200427. Juni 2008AktivChartered SecretarySekretär
    Swallow Cottage
    Main Road North
    HP4 1QZ Dagnall
    Herts
    British
    PICCADILLY HOTEL (LONDON) LIMITED08. Dez. 200427. Juni 2008AktivChartered SecretarySekretär
    Swallow Cottage
    Main Road North
    HP4 1QZ Dagnall
    Herts
    British
    THISTLE EDINBURGH TENANT LTD08. Dez. 200427. Juni 2008AktivSekretär
    Swallow Cottage
    Main Road North
    HP4 1QZ Dagnall
    Herts
    British
    BARBICAN HOTEL (LONDON) LIMITED08. Dez. 200427. Juni 2008AktivChartered SecretarySekretär
    Swallow Cottage
    Main Road North
    HP4 1QZ Dagnall
    Herts
    British
    HYDE PARK HOTEL (LONDON) LIMITED08. Dez. 200427. Juni 2008AktivSekretär
    Swallow Cottage
    Main Road North
    HP4 1QZ Dagnall
    Herts
    British
    THE CUMBERLAND HOTEL (LONDON) LIMITED04. Aug. 200427. Juni 2008AktivChartered SecretarySekretär
    Swallow Cottage
    Main Road North
    HP4 1QZ Dagnall
    Herts
    British
    CLERMONT HOTEL HOLDINGS LIMITED01. Sept. 200327. Juni 2008AktivChartered SecretaryGeschäftsführer
    Swallow Cottage
    Main Road North
    HP4 1QZ Dagnall
    Herts
    United KingdomBritish
    CLERMONT HOTEL HOLDINGS LIMITED01. Sept. 200327. Juni 2008AktivChartered SecretarySekretär
    Swallow Cottage
    Main Road North
    HP4 1QZ Dagnall
    Herts
    British
    HEATHROW HOTEL (LONDON) LIMITED10. Feb. 200327. Juni 2008AktivChartered SecretarySekretär
    Swallow Cottage
    Main Road North
    HP4 1QZ Dagnall
    Herts
    British
    TRAFALGAR HOTEL (LONDON) LIMITED10. Feb. 200327. Juni 2008AktivChartered SecretarySekretär
    Swallow Cottage
    Main Road North
    HP4 1QZ Dagnall
    Herts
    British
    THE CHARING CROSS HOTEL LIMITED10. Feb. 200327. Juni 2008AktivChartered SecretarySekretär
    Swallow Cottage
    Main Road North
    HP4 1QZ Dagnall
    Herts
    British
    THE ROYAL HORSEGUARDS HOTEL LIMITED10. Feb. 200327. Juni 2008AktivChartered SecretarySekretär
    Swallow Cottage
    Main Road North
    HP4 1QZ Dagnall
    Herts
    British
    MARBLE ARCH HOTEL (LONDON) LIMITED10. Feb. 200327. Juni 2008AktivChartered SecretarySekretär
    Swallow Cottage
    Main Road North
    HP4 1QZ Dagnall
    Herts
    British
    CLERMONT HOTEL HR LIMITED10. Feb. 200327. Juni 2008AktivChartered SecretaryGeschäftsführer
    Swallow Cottage
    Main Road North
    HP4 1QZ Dagnall
    Herts
    United KingdomBritish
    CLERMONT HOTEL HR LIMITED10. Feb. 200327. Juni 2008AktivChartered SecretarySekretär
    Swallow Cottage
    Main Road North
    HP4 1QZ Dagnall
    Herts
    British
    CLERMONT HOTEL MANAGEMENT LIMITED10. Feb. 200327. Juni 2008AktivChartered SecretarySekretär
    Swallow Cottage
    Main Road North
    HP4 1QZ Dagnall
    Herts
    British
    THE TOWER HOTEL (LONDON) LIMITED10. Feb. 200327. Juni 2008AktivChartered SecretarySekretär
    Swallow Cottage
    Main Road North
    HP4 1QZ Dagnall
    Herts
    British
    KENSINGTON GARDENS HOTEL (LONDON) LIMITED10. Feb. 200327. Juni 2008AktivChartered SecretarySekretär
    Swallow Cottage
    Main Road North
    HP4 1QZ Dagnall
    Herts
    British
    THE GROSVENOR HOTEL VICTORIA LIMITED10. Feb. 200327. Juni 2008AktivChartered SecretarySekretär
    Swallow Cottage
    Main Road North
    HP4 1QZ Dagnall
    Herts
    British

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0