ALLIANCE MEDICAL ACQUISITIONCO (OLD) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ALLIANCE MEDICAL ACQUISITIONCO (OLD) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04113267 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ALLIANCE MEDICAL ACQUISITIONCO (OLD) LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich ALLIANCE MEDICAL ACQUISITIONCO (OLD) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Iceni Centre Warwickshire Technology Park CV34 6DA Warwick Warwickshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ALLIANCE MEDICAL ACQUISITIONCO (OLD) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ALLIANCE MEDICAL ACQUISITION CO. LIMITED | 17. Jan. 2001 | 17. Jan. 2001 |
| DE FACTO 889 LIMITED | 23. Nov. 2000 | 23. Nov. 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ALLIANCE MEDICAL ACQUISITIONCO (OLD) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ALLIANCE MEDICAL ACQUISITIONCO (OLD) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 03. Okt. 2012
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul John Greensmith als Geschäftsführer am 17. Mai 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 15 Seiten | MG01 | ||||||||||
Ernennung von Ian Kendall Cattermole als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Ian Kendall Cattermole als Sekretär | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mairead Mckenna als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Howard Alexander David Marsh als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alan Pilgrim als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Paul John Greensmith als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Charles Ralph als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Charles Philip Ralph am 01. Okt. 2009 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Alan John Templer Pilgrim am 01. Okt. 2009 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ALLIANCE MEDICAL ACQUISITIONCO (OLD) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATTERMOLE, Ian Kendall | Sekretär | Iceni Centre Warwickshire Technology Park CV34 6DA Warwick Warwickshire | British | 155238000001 | ||||||
| CATTERMOLE, Ian Kendall | Geschäftsführer | Iceni Centre Warwickshire Technology Park CV34 6DA Warwick Warwickshire | United Kingdom | British | 82666030004 | |||||
| MARSH, Howard Alexander David | Geschäftsführer | Warwick Technology Park CV34 6DA Warwick Iceni Centre Warwickshire | United Kingdom | British | 111938620001 | |||||
| JARMAN, Peter Raymond | Sekretär | The Stables 3 Fieldgate Lawn Fieldgate Lane CV8 1RR Kenilworth Warwickshire | British | 71547190002 | ||||||
| MCKENNA, Mairead Maria | Sekretär | Iceni Centre Warwickshire Technology Park CV34 6DA Warwick Warwickshire | Irish | 115376340001 | ||||||
| TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 10 Snow Hill EC1A 2AL London | 900006100001 | |||||||
| BEAUMONT, John Julius | Geschäftsführer | Feldon House Gilletts Lane Upper Brailes OX15 5AU Banbury Oxfordshire | British | 56597970001 | ||||||
| CURWELL, Terence | Geschäftsführer | Rosewood House 15 Meadow Road Great Gransden SG19 3BD Sandy Bedfordshire | British | 66510260001 | ||||||
| GREENSMITH, Paul John | Geschäftsführer | Iceni Centre Warwickshire Technology Park CV34 6DA Warwick Warwickshire | England | British | 150227000001 | |||||
| JARMAN, Peter Raymond | Geschäftsführer | The Stables 3 Fieldgate Lawn Fieldgate Lane CV8 1RR Kenilworth Warwickshire | British | 71547190002 | ||||||
| PILGRIM, Alan John Templer | Geschäftsführer | Iceni Centre Warwickshire Technology Park CV34 6DA Warwick Warwickshire | England | British | 11755290002 | |||||
| RALPH, Charles Philip | Geschäftsführer | Iceni Centre Warwickshire Technology Park CV34 6DA Warwick Warwickshire | United Kingdom | British | 157549090001 | |||||
| WALEY-COHEN, Robert Bernard | Geschäftsführer | 18 Gilston Road SW10 9SR London | England | United Kingdom | 28444950001 | |||||
| TRAVERS SMITH LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 10 Snow Hill EC1A 2AL London | 900006090001 | |||||||
| TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 10 Snow Hill EC1A 2AL London | 900006100001 |
Hat ALLIANCE MEDICAL ACQUISITIONCO (OLD) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 16. Feb. 2011 Geliefert am 02. März 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any member of the group and by each debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Feb. 2008 Geliefert am 26. Feb. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor or grantor of security to the security trustee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. Juli 2005 Geliefert am 30. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any member of the group to the chargee and/or the other finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The property and all other property, all licences to enter upon or use land, all computers vehicles office equipment and other equipment, the benefit of contracts, all charged securities, the security accounts, all monies standing to the credit on any and all accounts, all intellectual property and by way of floating charge all assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 06. Mai 2003 Geliefert am 21. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 22. Jan. 2001 Geliefert am 05. Feb. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities covenanted and/or guaranteed to be paid or discharged by the charging companies (as defined) to the beneficiaries (as defined) under the terms of the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0