Dyfrig Morgan JAMES
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | Dyfrig |
Zweites Vornamen | Morgan |
Nachname | JAMES |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 1 |
Inaktiv | 2 |
Zurückgetreten | 45 |
Gesamt | 48 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D M JAMES SERVICES LTD | 14. Feb. 2014 | Aufgelöst | Non Exec Director | Geschäftsführer | Ty Cwm SA45 9PU Cei Newydd . Cymru | Wales | British | |
EMP AWARDING BODY LIMITED | 07. Juni 2005 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 10 Kimpton Road Blackmore End AL4 8LD Wheathampstead Hertfordshire | United Kingdom | British | |
LAFARGE UK PENSION TRUSTEES LIMITED | 30. Sept. 2003 | Aktiv | Regional President Northern & Central Europe | Geschäftsführer | The Cotterells HP1 1FW Hemel Hempstead Kd Tower, Suite 10 England | United Kingdom | British | |
GRS (ROADSTONE) LIMITED | 28. Jan. 2014 | 03. Nov. 2022 | Aktiv | Company Director And Consultant | Geschäftsführer | Gustard Wood Wheathampstead AL4 8RP St. Albans York Cottage, 12-13 Hertfordshire England | United Kingdom | British |
ADDAX INTERNATIONAL LIMITED | 21. Okt. 2014 | 08. Feb. 2020 | Aufgelöst | Non-Executive Director | Geschäftsführer | Winslow Road Little Horwood MK17 0PD Milton Keynes Unit 4c England | United Kingdom | British |
LAFARGE BUILDING MATERIALS LIMITED | 01. Jan. 2015 | 31. Dez. 2015 | Aktiv | President - Uk - Cement, Aggregates & Concrete And | Geschäftsführer | London Road RH4 1TH Dorking Park Lodge Surrey United Kingdom | United Kingdom | British |
LAFARGE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 12. Juni 2012 | 31. Dez. 2015 | Aktiv | President | Geschäftsführer | London Road RH4 1TH Dorking Park Lodge Surrey United Kingdom | United Kingdom | British |
TARMAC HOLDINGS LIMITED | 07. Jan. 2013 | 31. Juli 2015 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Bickenhill Lane B37 7BQ Solihull Portland House Birmingham United Kingdom | United Kingdom | British |
INSTITUTE OF QUARRYING(THE) | 08. Juni 2004 | 16. Mai 2014 | Aktiv | Managing Director | Geschäftsführer | 10 Kimpton Road Blackmore End AL4 8LD Wheathampstead Hertfordshire | United Kingdom | British |
MINERAL PRODUCTS ASSOCIATION LIMITED | 04. Mai 2000 | 01. Sept. 2013 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | 10 Kimpton Road Blackmore End AL4 8LD Wheathampstead Hertfordshire | United Kingdom | British |
TARMAC CEMENT LIMITED | 15. Sept. 2011 | 07. Jan. 2013 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Portland House Bickenhill Lane B37 7BQ Birmingham Lafarge Cement Uk Company Secretarial Department United Kingdom | United Kingdom | British |
REDLAND PROPERTIES LIMITED | 04. Apr. 2003 | 07. Jan. 2013 | Aktiv | Regional President Northern & Central Europe | Geschäftsführer | Granite House Granite Way, Syston LE7 1PL Leicester Company Secretariat Department Leicestershire United Kingdom | United Kingdom | British |
REDLAND PROPERTY HOLDINGS LIMITED | 04. Apr. 2003 | 07. Jan. 2013 | Aktiv | Regional President Northern & Central Europe | Geschäftsführer | Granite House Granite Way, Syston LE7 1PL Leicester Company Secretariat Department Leicestershire United Kingdom | United Kingdom | British |
TARMAC READYMIX LIMITED | 12. Dez. 1994 | 07. Jan. 2013 | Aktiv | Regional President Northern & Central Europe | Geschäftsführer | Granite House Granite Way, Syston LE7 1PL Leicester Company Secretariat Department Leicestershire United Kingdom | United Kingdom | British |
TARMAC AGGREGATES LIMITED | 12. Dez. 1994 | 07. Jan. 2013 | Aktiv | Regional President Northern & Central Europe | Geschäftsführer | Granite House Granite Way, Syston LE7 1PL Leicester Company Secretariat Department Leicestershire United Kingdom | British | |
REDLAND LIMITED | 04. Apr. 2003 | 25. Feb. 2009 | Aktiv | Regional President Northern & Central Europe | Geschäftsführer | 10 Kimpton Road Blackmore End AL4 8LD Wheathampstead Hertfordshire | United Kingdom | British |
LAFARGE BUILDING MATERIALS LIMITED | 04. Apr. 2003 | 25. Feb. 2009 | Aktiv | Regional President Northern & Central Europe | Geschäftsführer | 10 Kimpton Road Blackmore End AL4 8LD Wheathampstead Hertfordshire | United Kingdom | British |
LAFARGE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 04. Apr. 2003 | 25. Feb. 2009 | Aktiv | Regional President Northern & Central Europe | Geschäftsführer | 10 Kimpton Road Blackmore End AL4 8LD Wheathampstead Hertfordshire | United Kingdom | British |
TARMAC (UK) SERVICES LIMITED | 04. Apr. 2003 | 25. Feb. 2009 | Aufgelöst | Regional President Northern & Central Europe | Geschäftsführer | 10 Kimpton Road Blackmore End AL4 8LD Wheathampstead Hertfordshire | United Kingdom | British |
LAFARGE MINERALS LIMITED | 04. Apr. 2003 | 25. Feb. 2009 | Aufgelöst | Regional President Northern & Central Europe | Geschäftsführer | 10 Kimpton Road Blackmore End AL4 8LD Wheathampstead Hertfordshire | United Kingdom | British |
J. & R. HOWIE LIMITED | 24. Nov. 2003 | 24. Jan. 2008 | Aufgelöst | Managing Director | Geschäftsführer | 10 Kimpton Road Blackmore End AL4 8LD Wheathampstead Hertfordshire | United Kingdom | British |
LAFARGE REDLAND READYMIX LIMITED | 01. Mai 2003 | 16. Jan. 2008 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 10 Kimpton Road Blackmore End AL4 8LD Wheathampstead Hertfordshire | United Kingdom | British |
CEMEX READYMIX EAST ANGLIA LIMITED | 15. März 1996 | 16. Jan. 2008 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | 10 Kimpton Road Blackmore End AL4 8LD Wheathampstead Hertfordshire | United Kingdom | British |
HERTFORDSHIRE ROAD MAINTENANCE LIMITED | 01. März 2007 | 16. Jan. 2008 | Aufgelöst | Managing Director | Geschäftsführer | 10 Kimpton Road Blackmore End AL4 8LD Wheathampstead Hertfordshire | United Kingdom | British |
R.W. AGGREGATES LIMITED | 04. Apr. 1996 | 16. Jan. 2008 | Aufgelöst | Managing Director | Geschäftsführer | 10 Kimpton Road Blackmore End AL4 8LD Wheathampstead Hertfordshire | United Kingdom | British |
HARLOW ASPHALT LIMITED | 10. Juli 2002 | 16. Jan. 2008 | Liquidation | Managing Director | Geschäftsführer | 10 Kimpton Road Blackmore End AL4 8LD Wheathampstead Hertfordshire | United Kingdom | British |
NORTHWOOD(FAREHAM)LIMITED | 05. Dez. 1997 | 30. Nov. 2007 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 10 Kimpton Road Blackmore End AL4 8LD Wheathampstead Hertfordshire | United Kingdom | British |
PREMIER READY MIX CONCRETE LIMITED | 31. Jan. 2003 | 18. Feb. 2005 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 10 Kimpton Road Blackmore End AL4 8LD Wheathampstead Hertfordshire | United Kingdom | British |
ETON AGGREGATES LIMITED | 14. Feb. 1995 | 11. Jan. 2005 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 10 Kimpton Road Blackmore End AL4 8LD Wheathampstead Hertfordshire | United Kingdom | British |
CHAFFORD RESIDUAL PROPERTIES LIMITED | 31. Jan. 2003 | 11. Nov. 2004 | Aktiv | Managing Director | Geschäftsführer | 10 Kimpton Road Blackmore End AL4 8LD Wheathampstead Hertfordshire | United Kingdom | British |
BRETT FAIRLOP LIMITED | 23. Juli 1997 | 01. Juli 2003 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 10 Kimpton Road Blackmore End AL4 8LD Wheathampstead Hertfordshire | United Kingdom | British |
ISLAND BARN AGGREGATES LIMITED | 01. Sept. 1995 | 06. Mai 2003 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 10 Kimpton Road Blackmore End AL4 8LD Wheathampstead Hertfordshire | United Kingdom | British |
BLUEWATER CONCRETE LIMITED | 18. März 1996 | 04. Apr. 2003 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 10 Kimpton Road Blackmore End AL4 8LD Wheathampstead Hertfordshire | United Kingdom | British |
R.H. ROADSTONE LIMITED | 01. Feb. 1995 | 02. Apr. 2003 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 10 Kimpton Road Blackmore End AL4 8LD Wheathampstead Hertfordshire | United Kingdom | British |
HEPPLEWHITE QUARRIES & PLANT HIRE LIMITED | 20. Sept. 2000 | 02. Apr. 2003 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 10 Kimpton Road Blackmore End AL4 8LD Wheathampstead Hertfordshire | United Kingdom | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0