HEPPLEWHITE QUARRIES & PLANT HIRE LIMITED
Überblick
Unternehmensname | HEPPLEWHITE QUARRIES & PLANT HIRE LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00763141 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HEPPLEWHITE QUARRIES & PLANT HIRE LIMITED?
- Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus Beton, Gips und Zement (23690) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich HEPPLEWHITE QUARRIES & PLANT HIRE LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Portland House Bickenhill Lane Solihull B37 7BQ Birmingham |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HEPPLEWHITE QUARRIES & PLANT HIRE LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HEPPLEWHITE QUARRIES & PLANT HIRE LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 7 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 6 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Michael John Choules am 21. Nov. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Jan. 2019 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 12 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 1 Seiten | CC04 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 26. Nov. 2018
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Francis William Cottrell als Geschäftsführer am 25. Juli 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Martin Kenneth Riley als Geschäftsführer am 25. Juli 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Michael John Choules als Direktor am 25. Juli 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Cessation of Tarmac Toplite Limited as a person with significant control on 31. Mai 2018 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Notification of Tarmac Trading Limited as a person with significant control on 31. Mai 2018 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Jan. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HEPPLEWHITE QUARRIES & PLANT HIRE LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARMAC SECRETARIES (UK) LIMITED | Sekretär | Bickenhill Lane Solihull B37 7BQ Birmingham Portland House United Kingdom |
| 9859690020 | ||||||||||
CHOULES, Michael John | Geschäftsführer | Bickenhill Lane Solihull B37 7BQ Birmingham Portland House | United Kingdom | British | Company Director | 178681090004 | ||||||||
TARMAC DIRECTORS (UK) LIMITED | Geschäftsführer | Bickenhill Lane Solihull B37 7BQ Birmingham Portland House United Kingdom |
| 148616660037 | ||||||||||
BOYD, Robert Ian Walter | Sekretär | 7 Beechways Whitesmocks DH1 4LG Durham City | British | 578930002 | ||||||||||
LARKIN, John Albert | Sekretär | 3 Old Mill Drive Upper Newbold S41 9SA Chesterfield Derbyshire | British | 10373830002 | ||||||||||
LINDSAY, John Kerr | Sekretär | 3 Chillingham Drive DH2 3TJ Chester Le Street County Durham | British | Chief Accountant | 58863510001 | |||||||||
BAXTER, David | Geschäftsführer | Apartment 1 38 Cleveden Drive G12 0RY Glasgow | British | Director | 65152700006 | |||||||||
BOLSOVER, George William | Geschäftsführer | The Lenches WR10 3AZ Eckington Worcestershire | England | British | Director | 146900710001 | ||||||||
BOWN, Barry | Geschäftsführer | 7 Southshield Drive North Leverton DN22 0AZ Retford Nottinghamshire | British | Director | 41587830002 | |||||||||
BOYD, Robert Ian Walter | Geschäftsführer | Willow Green Slingsby Walk HG2 8LL Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | Accountant | 110165820001 | ||||||||
CLIFFE, George Frank | Geschäftsführer | Amberstone House Hill Road Ashover S45 06X Chesterfield Derbyshire | British | Director | 12013740001 | |||||||||
COTTRELL, Paul Francis William | Geschäftsführer | Bickenhill Lane Solihull B37 7BQ Birmingham Portland House United Kingdom | United Kingdom | British | Head Of Finance (Aggregates & Asphalt) | 177529800001 | ||||||||
COX, Philip Martin, Mr. | Geschäftsführer | Granite House Granite Way LE7 1PL Syston Company Secretariat Department Leicestershire | England | English | Area Business Manager | 126374290001 | ||||||||
FINDLATER, Robert Ian | Geschäftsführer | 5 Victoria Road CO3 3NT Colchester Essex | British | Chartered Surveyor | 63816370001 | |||||||||
GAFFNEY, Thomas Anthony | Geschäftsführer | 39 Tintern Road SK8 7QF Cheadle Hulme Cheshire | British | General Manager | 92789690001 | |||||||||
GAFFNEY, Thomas Anthony | Geschäftsführer | 39 Tintern Road SK8 7QF Cheadle Hulme Cheshire | British | General Manager | 92789690001 | |||||||||
GILLATT, Peter John | Geschäftsführer | Gables Farm Main Street, Long Whatton LE12 5DF Loughborough Leicestershire | England | British | Director | 64813260001 | ||||||||
GILLATT, Peter John | Geschäftsführer | Gables Farm Main Street, Long Whatton LE12 5DF Loughborough Leicestershire | England | British | Company Director | 64813260001 | ||||||||
GREENHALGH, Graham Samuel | Geschäftsführer | 10 Stewart Drive Clarkston G76 7EZ Glasgow | British | Director | 142959250001 | |||||||||
GRIMASON, Deborah | Geschäftsführer | Bickenhill Lane B37 7BQ Solihuill Portland House West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | Solicitor | 120668330001 | ||||||||
HOWARTH, Brian Jeffrey | Geschäftsführer | 1 Pinewood Norton YO17 9JT Malton North Yorkshire | British | Director | 69073320001 | |||||||||
JAMES, Dyfrig Morgan | Geschäftsführer | 10 Kimpton Road Blackmore End AL4 8LD Wheathampstead Hertfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 46026620001 | ||||||||
LAST, Terence Robert | Geschäftsführer | Church Street Groton CO10 5EH Sudbury Groton Farm Suffolk United Kingdom | England | British | Company Director | 140570450001 | ||||||||
LINDSAY, John Kerr | Geschäftsführer | 3 Chillingham Drive DH2 3TJ Chester Le Street County Durham | Ireland | British | Accountant | 58863510001 | ||||||||
MULRONEY, Bradley | Geschäftsführer | The Hopelands 8 Quarry Hill Lane WS14 9HW Lichfield Staffordshire | British | Director | 79827800001 | |||||||||
PHILLIPS, Simon David | Geschäftsführer | Widehaugh House Corbridge Road NE46 1UW Hexham Northumberland | United Kingdom | British | Director | 88725350001 | ||||||||
RIGAUX, Emmanuel Marie Germain | Geschäftsführer | Granite Way Syston LE7 1PL Leicester Company Secretariat Department, Granite House Leicestershire | United Kingdom | French | Managing Director - Aggregates | 153970750001 | ||||||||
RILEY, Kenneth Alfred | Geschäftsführer | 52 Woodlands Park Drive Parkland NE21 5PQ Blaydon Tyne & Wear | United Kingdom | British | Director | 13411400001 | ||||||||
RILEY, Martin Kenneth | Geschäftsführer | Bickenhill Lane Solihull B37 7BQ Birmingham Portland House United Kingdom | United Kingdom | British | Managing Director | 177528430001 | ||||||||
SMART, Andrew Peter Fernie | Geschäftsführer | Granite House Granite Way LE7 1PL Syston Company Secretariat Department Leicestershire United Kingdom | United Kingdom | British | Business Manager | 102968250001 | ||||||||
SMITH, Iain | Geschäftsführer | Millfields Road Ettingshall WV4 6JP Wolverhampton West Midlands | United Kingdom | British | Operations Director | 173228780001 | ||||||||
WHETSTONE, Robert Anthony Stewart | Geschäftsführer | Granite House Granite Way LE7 1PL Syston Company Secretariat Department Leciestershire | England | British | Aggregates Managing Director | 64041870002 | ||||||||
WYKES, Stuart John | Geschäftsführer | Granite House Granite Way LE7 1PL Syston Company Secretariat Department Leicestershire United Kingdom | England | British | Director | 151492270001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HEPPLEWHITE QUARRIES & PLANT HIRE LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarmac Trading Limited | 31. Mai 2018 | Bickenhill Lane Solihull B37 7BQ Birmingham Portland House United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Tarmac Toplite Limited | 06. Apr. 2016 | Bickenhill Lane Solihull B37 7BQ Birmingham Portland House England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Tarmac Aggregates Limited | 06. Apr. 2016 | Bickenhill Lane Solihull B37 7BQ Birmingham Portland House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat HEPPLEWHITE QUARRIES & PLANT HIRE LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Charge | Erstellt am 20. Jan. 1987 Geliefert am 09. Feb. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an invoice discounting agreement dated 20.1.87 | |
Kurze Angaben All book debts & other debts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 17. Dez. 1985 Geliefert am 20. Dez. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts goodwill & uncalled capital. (See doc M27 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 12. Sept. 1985 Geliefert am 18. Sept. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat HEPPLEWHITE QUARRIES & PLANT HIRE LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0