• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Stuart David GLASS - Seite 2

    Natürliche Person

    TitelMr
    VornameStuart
    Zweites VornamenDavid
    NachnameGLASS
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv4
    Inaktiv36
    Zurückgetreten55
    Gesamt95

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    SI CHALFONT PARK (LP) LIMITED31. Jan. 2008AufgelöstAccountantSekretär
    76/6 Park Avenue
    EH15 1JP Edinburgh
    Midlothian
    British
    SI HOTELS INVESTMENTS LIMITED31. Jan. 2008AufgelöstAccountantSekretär
    76/6 Park Avenue
    EH15 1JP Edinburgh
    Midlothian
    British
    SI SHEFFIELD (GP) LIMITED31. Jan. 2008AufgelöstAccountantSekretär
    76/6 Park Avenue
    EH15 1JP Edinburgh
    Midlothian
    British
    GLASGOW LEISURE INVESTMENTS (2) LIMITED13. Juli 2007AufgelöstSekretär
    76/6 Park Avenue
    EH15 1JP Edinburgh
    Midlothian
    British
    GLASGOW LEISURE INVESTMENTS (1) LIMITED13. Juli 2007AufgelöstSekretär
    76/6 Park Avenue
    EH15 1JP Edinburgh
    Midlothian
    British
    CONSENSUS CAPITAL HOLDINGS LIMITED18. Sept. 201329. Sept. 2015AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Charlotte Square
    EH2 4HQ Edinburgh
    45
    Scotland
    ScotlandBritish
    CONSENSUS CAPITAL GROUP LIMITED08. Juli 201229. Sept. 2015AktivAccountantGeschäftsführer
    Charlotte Square
    EH2 4HQ Edinburgh
    45
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    VILLETTE & CO LIMITED31. Okt. 201314. Aug. 2015AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Ashgrove
    EH21 7LT Musselburgh
    6a
    Scotland
    ScotlandBritish
    27&29 PALMERSTON PLACE LTD01. Okt. 201323. Sept. 2014AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Charlotte Square
    EH2 4HQ Edinburgh
    45
    Scotland
    ScotlandBritish
    ACCESS ENERGY LTD18. Sept. 201323. Sept. 2014AufgelöstFinance DirectorGeschäftsführer
    Park Avenue
    EH15 1JP Edinburgh
    76/6
    Scotland
    ScotlandBritish
    CC BROMLEY LTD28. Juli 201410. Sept. 2014AktivAccountantGeschäftsführer
    Park Avenue
    EH15 1JP Edinburgh
    76/6
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    CC YORK PLACE LTD11. Juni 201410. Sept. 2014AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Charlotte Square
    EH2 4HQ Edinburgh
    45
    ScotlandBritish
    FIREWATER GLASGOW LTD05. März 201409. Sept. 2014AufgelöstFinance DirectorGeschäftsführer
    Charlotte Square
    EH2 4HQ Edinburgh
    45
    ScotlandBritish
    10 CHESTER STREET LIMITED21. Feb. 201409. Sept. 2014AufgelöstFinance DirectorGeschäftsführer
    Charlotte Square
    EH2 4HQ Edinburgh
    45
    Scotland
    ScotlandBritish
    CONSENSUS CAPITAL PRIVATE EQUITY LTD18. Sept. 201302. Juni 2014AufgelöstFinance DirectorGeschäftsführer
    Charlotte Square
    EH2 4HQ Edinburgh
    45
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    ENGENERA PLC31. Mai 201327. Feb. 2014AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Charlotte Square
    EH2 4HQ Edinburgh
    45
    Scotland
    ScotlandBritish
    ACCESS ENERGY LTD07. Jan. 201318. Sept. 2013AufgelöstFinance DirectorGeschäftsführer
    Charlotte Square
    EH2 4HQ Edinburgh
    45
    Scotland
    ScotlandBritish
    MACEMC LTD03. Dez. 201218. Sept. 2013AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Charlotte Square
    EH2 4HQ Edinburgh
    45
    Scotland
    ScotlandBritish
    CONSENSUS CAPITAL PRIVATE EQUITY LTD20. Juli 201118. Sept. 2013AufgelöstFinance DirectorGeschäftsführer
    Charlotte Square
    EH2 4HQ Edinburgh
    45
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    EVOLVE COUTURE LTD16. Juli 201201. Mai 2013AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Charlotte Square
    EH2 4HQ Edinburgh
    45
    Scotland
    ScotlandBritish
    CCPE RETAIL AGENTS LTD13. Juli 201201. Mai 2013AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Charlotte Square
    EH2 4HQ Edinburgh
    45
    Scotland
    ScotlandBritish
    CCPE - MEDIA LTD13. Juli 201201. Mai 2013AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Charlotte Square
    EH2 4HQ Edinburgh
    45
    Scotland
    ScotlandBritish
    HAMILTON CCPE LTD13. Juli 201209. Okt. 2012AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Charlotte Square
    EH2 4HQ Edinburgh
    45
    Scotland
    ScotlandBritish
    SI CITY WHARF LIMITED15. Jan. 201026. Juli 2012AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Park Avenue
    EH15 1JP Edinburgh
    76/6
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    SI LIVERPOOL (GP2) LIMITED15. Jan. 201026. Juli 2012AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Northwest Wing
    Bush House
    WC2B 4EZ Aldwych
    London
    ScotlandBritish
    SI LIVERPOOL (GP1) LIMITED15. Jan. 201026. Juli 2012AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Northwest Wing
    Bush House
    WC2B 4EZ Aldwych
    London
    ScotlandBritish
    SI HOTELS GLASGOW (GP2) LIMITED15. Jan. 201026. Juli 2012AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Park Avenue
    EH15 1JP Edinburgh
    76/6
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    SI HOTELS (GP1) LIMITED15. Jan. 201026. Juli 2012AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Park Avenue
    EH15 1JP Edinburgh
    76/6
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    SI HOTELS GLASGOW (GP1) LIMITED15. Jan. 201026. Juli 2012AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    41 Charlotte Square
    Edinburgh
    EH2 4HQ
    ScotlandBritish
    SI LIVERPOOL (LP) LIMITED15. Jan. 201026. Juli 2012AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Park Avenue
    EH15 1JP Edinburgh
    76/6
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    SI HOTELS (GP2) LIMITED15. Jan. 201026. Juli 2012AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Park Avenue
    EH15 1JP Edinburgh
    76/6
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    SI (LP) LIMITED10. Nov. 200926. Juli 2012AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Park Avenue
    EH15 1JP Edinburgh
    76/6
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    SI NO.7 (GP2) LIMITED10. Nov. 200926. Juli 2012AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Park Avenue
    EH15 1JP Edinburgh
    76/6
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    SI NO.7 (GP1) LIMITED10. Nov. 200926. Juli 2012AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Park Avenue
    EH15 1JP Edinburgh
    76/6
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    STRATEGIC INVESTMENT MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED09. Sept. 200926. Juli 2012AktivAccountantGeschäftsführer
    76/6 Park Avenue
    EH15 1JP Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0