Darryl John CORNEY - Seite 2
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | Darryl |
Zweites Vornamen | John |
Nachname | CORNEY |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 17 |
Zurückgetreten | 68 |
Gesamt | 85 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEPENDENT COMMUNITY HEATING LIMITED | 09. Nov. 2007 | 28. Juli 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Windmill Avenue Woolpit IP30 9UP Bury St. Edmunds Synergy House England | England | British |
OPEN FIBRE NETWORKS (WHOLESALE) LIMITED | 22. Sept. 2006 | 28. Juli 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Windmill Avenue Woolpit IP30 9UP Bury St. Edmunds Synergy House England | England | British |
INDEPENDENT WATER NETWORKS LIMITED | 22. Sept. 2006 | 28. Juli 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Windmill Avenue Woolpit IP30 9UP Bury St. Edmunds Synergy House England | England | British |
INDEPENDENT METERS LIMITED | 21. Juni 2006 | 28. Juli 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Windmill Avenue Woolpit IP30 9UP Bury St. Edmunds Synergy House England | England | British |
INEXUS CONNECTIONS LIMITED | 21. Juni 2006 | 28. Juli 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Windmill Avenue Woolpit IP30 9UP Bury St. Edmunds Synergy House England | England | British |
INDEPENDENT PIPELINES LIMITED | 21. Juni 2006 | 28. Juli 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Windmill Avenue Woolpit IP30 9UP Bury St. Edmunds Synergy House England | England | British |
INEXUS GROUP (HOLDINGS) LIMITED | 21. Juni 2006 | 28. Juli 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Windmill Avenue Woolpit IP30 9UP Bury St. Edmunds Synergy House England | England | British |
QUADRANT PIPELINES LIMITED | 21. Juni 2006 | 28. Juli 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Windmill Avenue Woolpit IP30 9UP Bury St. Edmunds Synergy House England | England | British |
INDEPENDENT POWER NETWORKS LIMITED | 21. Juni 2006 | 28. Juli 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Windmill Avenue Woolpit IP30 9UP Bury St. Edmunds Synergy House England | England | British |
EPLR HOLDINGS LTD | 18. Feb. 2020 | 28. Juli 2023 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Windmill Avenue Woolpit IP30 9UP Bury St. Edmunds Synergy House England | England | British |
EPL&R UTILITIES LIMITED | 18. Feb. 2020 | 28. Juli 2023 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Windmill Avenue Woolpit IP30 9UP Bury St. Edmunds Synergy House England | England | British |
SMART METER ASSETS 1 LTD | 03. Feb. 2016 | 12. Mai 2021 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Windmill Avenue Woolpit IP30 9UP Bury St. Edmunds Synergy House Suffolk England | England | British |
BUUK INFRASTRUCTURE LIMITED | 10. März 2014 | 26. Nov. 2019 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Windmill Avenue Woolpit IP30 9UP Bury St. Edmunds Synergy House England | England | British |
INDEPENDENT FIBRE RETAIL LIMITED | 28. Okt. 2013 | 18. Sept. 2019 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Grant Way TW7 5QD Isleworth Sky Central Middlesex | England | British |
EXOTERIC METERING LIMITED | 30. Juni 2008 | 01. März 2017 | Liquidation | Director | Geschäftsführer | c/o Company Secretary Woolpit Business Park, Windmill Avenue Woolpit IP30 9UP Bury St. Edmunds Energy House Suffolk England | England | British |
COMPUTERSHARE TRUSTEES LIMITED | 06. Jan. 2006 | 31. Jan. 2006 | Aktiv | Chief Finance Officer | Geschäftsführer | Highcroft Milton Clevedon BA4 6NS Shepton Mallet Somerset | England | British |
COMPUTERSHARE COMPANY NOMINEES LIMITED | 05. Okt. 2005 | 31. Jan. 2006 | Aktiv | Finance Executive | Geschäftsführer | Highcroft Milton Clevedon BA4 6NS Shepton Mallet Somerset | England | British |
FLAG COMMUNICATION LIMITED | 02. Sept. 2004 | 31. Jan. 2006 | Aktiv | Finance Executive | Sekretär | Highcroft Milton Clevedon BA4 6NS Shepton Mallet Somerset | British | |
COMPUTERSHARE TECHNOLOGY SERVICES (UK) LIMITED | 01. Okt. 2003 | 31. Jan. 2006 | Aktiv | Finance Executive | Geschäftsführer | Highcroft Milton Clevedon BA4 6NS Shepton Mallet Somerset | England | British |
COMPUTERSHARE INVESTMENTS (UK) (NO.3) LIMITED | 10. Sept. 2003 | 31. Jan. 2006 | Aktiv | Finance Executive | Sekretär | Highcroft Milton Clevedon BA4 6NS Shepton Mallet Somerset | British | |
COMPUTERSHARE INVESTMENTS (UK) (NO.3) LIMITED | 10. Sept. 2003 | 31. Jan. 2006 | Aktiv | Finance Director | Geschäftsführer | Highcroft Milton Clevedon BA4 6NS Shepton Mallet Somerset | England | British |
COMPUTERSHARE COMPANY NOMINEES LIMITED | 18. Sept. 2002 | 31. Jan. 2006 | Aktiv | Finance Executive | Sekretär | Highcroft Milton Clevedon BA4 6NS Shepton Mallet Somerset | British | |
COMPUTERSHARE SERVICES NOMINEES LIMITED | 18. Sept. 2002 | 31. Jan. 2006 | Aktiv | Finance Executive | Sekretär | Highcroft Milton Clevedon BA4 6NS Shepton Mallet Somerset | British | |
COMPUTERSHARE TECHNOLOGY SERVICES (UK) LIMITED | 18. Sept. 2002 | 31. Jan. 2006 | Aktiv | Finance Executive | Sekretär | Highcroft Milton Clevedon BA4 6NS Shepton Mallet Somerset | British | |
COMPUTERSHARE LIMITED | 18. Sept. 2002 | 31. Jan. 2006 | Aktiv | Finance Executive | Sekretär | Highcroft Milton Clevedon BA4 6NS Shepton Mallet Somerset | British | |
COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES PLC | 18. Sept. 2002 | 31. Jan. 2006 | Aktiv | Finance Executive | Sekretär | Highcroft Milton Clevedon BA4 6NS Shepton Mallet Somerset | British | |
COMPUTERSHARE LIMITED | 05. Sept. 2002 | 31. Jan. 2006 | Aktiv | Finance Executive | Geschäftsführer | Highcroft Milton Clevedon BA4 6NS Shepton Mallet Somerset | England | British |
COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES PLC | 05. Sept. 2002 | 31. Jan. 2006 | Aktiv | Finance Executive | Geschäftsführer | Highcroft Milton Clevedon BA4 6NS Shepton Mallet Somerset | England | British |
COMPUTERSHARE PEP NOMINEES LIMITED | 05. Okt. 2005 | 31. Jan. 2006 | Aufgelöst | Finance Executive | Geschäftsführer | Highcroft Milton Clevedon BA4 6NS Shepton Mallet Somerset | England | British |
CR EDIT 360 LTD | 02. Sept. 2004 | 31. Jan. 2006 | Aufgelöst | Finance Executive | Sekretär | Highcroft Milton Clevedon BA4 6NS Shepton Mallet Somerset | British | |
GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED | 28. Apr. 2004 | 31. Jan. 2006 | Aufgelöst | Finance Executive | Sekretär | Highcroft Milton Clevedon BA4 6NS Shepton Mallet Somerset | British | |
GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED | 28. Apr. 2004 | 31. Jan. 2006 | Aufgelöst | Finance Executive | Geschäftsführer | Highcroft Milton Clevedon BA4 6NS Shepton Mallet Somerset | England | British |
SOURCE ONE COMMUNICATIONS (UK) LIMITED | 28. Apr. 2004 | 31. Jan. 2006 | Aufgelöst | Finance Executive | Geschäftsführer | Highcroft Milton Clevedon BA4 6NS Shepton Mallet Somerset | England | British |
SHAREHOLDER INVESTMENTS RESEARCH LIMITED | 28. Apr. 2004 | 31. Jan. 2006 | Aufgelöst | Finance Executive | Sekretär | Highcroft Milton Clevedon BA4 6NS Shepton Mallet Somerset | British | |
SHAREHOLDER INVESTMENTS RESEARCH LIMITED | 28. Apr. 2004 | 31. Jan. 2006 | Aufgelöst | Finance Executive | Geschäftsführer | Highcroft Milton Clevedon BA4 6NS Shepton Mallet Somerset | England | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0