• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Ian Derek MARCHANT

    Natürliche Person

    TitelMr
    VornameIan
    Zweites VornamenDerek
    NachnameMARCHANT
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv1
    Inaktiv3
    Zurückgetreten39
    Gesamt43

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    DUNELM ENERGY LIMITED11. Nov. 2013AktivDirectorGeschäftsführer
    C/O Azets
    Quay 2
    EH3 9QG 139 Fountainbridge
    Dunelm Energy Limited,
    Edinburgh
    Scotland
    ScotlandBritish
    THE MAGGIE KESWICK JENCKS CANCER CARING CENTRES TRUST (EDINBURGH)30. Nov. 2006AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Inveralmond House
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Perthshire
    United KingdomBritish
    THE MAGGIE KESWICK JENCKS CANCER CARING CENTRES TRUST (OXFORD)30. Nov. 2006AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Inveralmond House
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Perthshire
    United KingdomBritish
    THE MAGGIE KESWICK JENCKS CANCER CARING CENTRES TRUST (LANARKSHIRE)30. Nov. 2006AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Inveralmond House
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Perthshire
    United KingdomBritish
    JOHN WOOD GROUP PLC19. Mai 200601. Sept. 2019AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    ScotlandBritish
    THE MAGGIE KESWICK JENCKS CANCER CARING CENTRES TRUST07. Sept. 200513. März 2018AktivAccountantGeschäftsführer
    Crewe Road South
    EH4 2XU Edinburgh
    Maggies Centres Western General Hospital
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE PLC14. Dez. 199830. Juni 2013AktivAccountantGeschäftsführer
    Inveralmond House
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Perthshire
    United KingdomBritish
    SSE SERVICES PLC01. Juni 199630. Juni 2013AktivAccountantGeschäftsführer
    Inveralmond House
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Perthshire
    United KingdomBritish
    NEOS NETWORKS LIMITED28. Sept. 200114. Okt. 2002AktivAccountantGeschäftsführer
    45 Craigcrook Road
    EH4 3PH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish
    SSE RETAIL LIMITED28. Sept. 200114. Okt. 2002AktivAccountantGeschäftsführer
    45 Craigcrook Road
    EH4 3PH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish
    SSE SEABANK INVESTMENTS LIMITED08. Okt. 199914. Okt. 2002AktivAccountantGeschäftsführer
    45 Craigcrook Road
    EH4 3PH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish
    SSE PRODUCTION SERVICES LIMITED08. Okt. 199914. Okt. 2002AktivAccountantGeschäftsführer
    45 Craigcrook Road
    EH4 3PH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish
    KEADBY GENERATION LIMITED08. Okt. 199914. Okt. 2002AktivAccountantGeschäftsführer
    45 Craigcrook Road
    EH4 3PH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish
    KEADBY DEVELOPMENTS LIMITED08. Okt. 199914. Okt. 2002AktivAccountantGeschäftsführer
    45 Craigcrook Road
    EH4 3PH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish
    SSE TRUSTEES LIMITED24. Apr. 199514. Okt. 2002AktivAccountantGeschäftsführer
    45 Craigcrook Road
    EH4 3PH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish
    SSE POWER LIMITED24. Juli 200214. Okt. 2002AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    45 Craigcrook Road
    EH4 3PH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish
    SWALEC GAS LIMITED07. Aug. 200014. Okt. 2002AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    45 Craigcrook Road
    EH4 3PH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish
    SSE FINANCE LIMITED03. März 200014. Okt. 2002AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    45 Craigcrook Road
    EH4 3PH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish
    KEADBY POWER LIMITED08. Okt. 199914. Okt. 2002AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    45 Craigcrook Road
    EH4 3PH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish
    SSE LEASING LIMITED08. Okt. 199914. Okt. 2002AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    45 Craigcrook Road
    EH4 3PH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish
    SSE ENERGY LIMITED08. Okt. 199914. Okt. 2002AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    45 Craigcrook Road
    EH4 3PH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish
    KEADBY CONSTRUCTION LIMITED08. Okt. 199914. Okt. 2002AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    45 Craigcrook Road
    EH4 3PH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish
    SSE INVESTMENTS LIMITED12. Apr. 199914. Okt. 2002AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    45 Craigcrook Road
    EH4 3PH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish
    SSECOSEC (2) LIMITED28. Mai 199614. Okt. 2002AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    45 Craigcrook Road
    EH4 3PH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish
    SOUTHERN ELECTRICITY LIMITED28. Mai 199614. Okt. 2002AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    45 Craigcrook Road
    EH4 3PH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish
    SCOTTISH HYDRO ELECTRIC POWER DISTRIBUTION PLC19. März 200101. Okt. 2002AktivAccountantGeschäftsführer
    45 Craigcrook Road
    EH4 3PH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish
    SOUTHERN ELECTRIC POWER DISTRIBUTION PLC19. März 200101. Okt. 2002AktivAccountantGeschäftsführer
    45 Craigcrook Road
    EH4 3PH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish
    SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC19. März 200101. Okt. 2002AktivAccountantGeschäftsführer
    45 Craigcrook Road
    EH4 3PH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish
    SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY POWER DISTRIBUTION LIMITED19. März 200101. Okt. 2002AktivAccountantGeschäftsführer
    45 Craigcrook Road
    EH4 3PH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish
    SSE CONTRACTING GROUP LIMITED02. Okt. 199701. Okt. 2002AktivAccountantGeschäftsführer
    45 Craigcrook Road
    EH4 3PH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish
    S + S LIMITED19. März 200101. Okt. 2002AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    45 Craigcrook Road
    EH4 3PH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish
    THERMAL TRANSFER (SCOTLAND) LIMITED02. Okt. 199701. Okt. 2002AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    45 Craigcrook Road
    EH4 3PH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish
    SSE ENERGY SUPPLY LIMITED07. Aug. 200028. Sept. 2001AktivAccountantGeschäftsführer
    45 Craigcrook Road
    EH4 3PH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish
    SSE GENERATION LIMITED25. Juli 199528. Sept. 2001AktivAccountantGeschäftsführer
    45 Craigcrook Road
    EH4 3PH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish
    INDIGO PIPELINES LIMITED28. Mai 199608. Okt. 1999AktivAccountantGeschäftsführer
    South Riding Shoppenhangers Road
    SL6 2PZ Maidenhead
    Berkshire
    British

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0