KEADBY POWER LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | KEADBY POWER LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02548042 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von KEADBY POWER LIMITED?
- Erzeugung von Elektrizität (35110) / Versorgung mit Elektrizität, Gas, Dampf und klimatisierten Luft
Wo befindet sich KEADBY POWER LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Keadby Power Station P O Box 89 Keadby DN17 3AZ Scunthorpe North Lincolnshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von KEADBY POWER LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| POPPYGROVE LIMITED | 12. Okt. 1990 | 12. Okt. 1990 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KEADBY POWER LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für KEADBY POWER LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für KEADBY POWER LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Ernennung von Sally Fairbairn als Sekretär am 01. Dez. 2014 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Lawrence John Vincent Donnelly als Sekretär am 01. Dez. 2014 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2013 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Brandon James Rennet als Geschäftsführer am 13. März 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Brandon James Rennet als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Antony Brydon als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2006 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von KEADBY POWER LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAIRBAIRN, Sally | Sekretär | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House Scotland | 193193030001 | |||||||
| SMITH, Paul Richard | Geschäftsführer | Grampian House 200 Dunkeld Road PH1 3GH Perth | United Kingdom | British | 62067440001 | |||||
| DONNELLY, Lawrence John Vincent | Sekretär | Inveralmond House 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth | British | 62794440002 | ||||||
| DONNELLY, Lawrence John Vincent | Sekretär | 31 Hillpark Way Blackhall EH4 7ST Edinburgh Midlothian | British | 62794440001 | ||||||
| DUFTY, Kevan | Sekretär | 29 The Green Hawk Green SK6 7HT Stockport Cheshire | British | 89069560001 | ||||||
| HASTINGS, David Gillespie | Sekretär | 25 The Meadows Messingham DN17 3UD Scunthorpe South Humberside | British | 47290770001 | ||||||
| NEWSOME, Michael John | Sekretär | 10 Athol Road Bramhall SK7 1BS Stockport Cheshire | British | 40874420001 | ||||||
| ADAMS, Christopher George | Geschäftsführer | 72 Westgate Hale WA15 9BB Altrincham Cheshire | England | British | 35062520001 | |||||
| ALEXANDER, Fraser Mcgregor | Geschäftsführer | Green Yetts Doune Road FK15 9HR Dunblane Perthshire | United Kingdom | British | 65278040002 | |||||
| BRYDON, Antony Gavin Dominic, Dr | Geschäftsführer | Inveralmond House 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth | Scotland | British | 84781430001 | |||||
| EASTABROOK, Barbara Kay | Geschäftsführer | 82 St Werburghs Road Chorlton Cum Hardy M21 0UL Manchester | British | 26027600001 | ||||||
| FAULKNER, Malcolm George | Geschäftsführer | 14 Sudbury Drive Lostock BL6 4PP Bolton Lancashire | United Kingdom | British | 35560560001 | |||||
| GOLDSWORTHY, Peter | Geschäftsführer | Quinque 5 Brookside Euxton PR7 6HR Chorley Lancashire | British | 6901020001 | ||||||
| GRAY, David Mclaren | Geschäftsführer | Dykeneuk Butterstone PH8 0HA Dunkeld Perthshire | Scotland | British | 140884530001 | |||||
| MARCHANT, Ian Derek | Geschäftsführer | 45 Craigcrook Road EH4 3PH Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 29951280003 | |||||
| MARTIN, James Henry | Geschäftsführer | Burn Brae House East Dron , Bridge Of Earn PH2 9HG Perth Perthshire | British | 49728730002 | ||||||
| READ, Arnold Wadkin, Dr | Geschäftsführer | 8 Gillespie Road EH13 0LL Edinburgh Lothian | British | 501810001 | ||||||
| RENNET, Brandon James | Geschäftsführer | Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House 200 Perthshire | United Kingdom | British | 135521350001 | |||||
| SIGSWORTH, David, Prof. | Geschäftsführer | 9 Station Road EH30 9HY South Queensferry West Lothian | United Kingdom | British | 4582280001 | |||||
| SIGSWORTH, David, Prof. | Geschäftsführer | 9 Station Road EH30 9HY South Queensferry West Lothian | United Kingdom | British | 4582280001 | |||||
| WILMAN, Graham | Geschäftsführer | 20 Sanderling Close Westhoughton BL5 2SP Bolton Lancashire | British | 42205700001 | ||||||
| YOUNG, Alan Moffat | Geschäftsführer | 46 Allan Road Killearn G63 9QE Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 5096340001 | |||||
| YOUNG, Arnold Roger Alexander | Geschäftsführer | Lossiehall Liff DD2 5NJ Dundee | British | 72341120001 |
Hat KEADBY POWER LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Second supplemental debenture | Erstellt am 17. Dez. 1992 Geliefert am 05. Jan. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due fromeach obligor under the terms of any of the finance documents. | |
Kurze Angaben See relevant form 395 for full details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Amending agreement | Erstellt am 17. Dez. 1992 Geliefert am 05. Jan. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of any of the finance documents | |
Kurze Angaben The following documents 1)the group agreements; 2) the novation agreements; and the parent company guarantee acknowledgement letters. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 09. Juni 1992 Geliefert am 12. Juni 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the the union bank of switzerland as agent and trustee for itself and certain other banks under the terms of this charge as defined. | |
Kurze Angaben By way of assignment, all of the present and future right, title and interest of the company in and to the significant agreements (including without limitation, all monies which at any time may be or become payable to the company pursuant thereto and the proceeds of all claims awards and judgements which may at any time be receivable or received by the company pursuant thereto (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Apr. 1992 Geliefert am 16. Apr. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company to union bank of switzerland under the terms of the facility agreement and/or any finance documents and this debenture. | |
Kurze Angaben By way of legal mortage all the property as specified in schedule 1 (attached to form 395) together with all buildings and fixtures thereon ,the proceeds of sale of all or any part thereof, and the benefit of any covenants for title given or entered into by any predecessor in title of the company and any moneys paid or payable in respect of such covenants. Please see form 395 for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Juli 1991 Geliefert am 26. Juli 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Site of the former keadby power station, keadby, humberside. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0