Kevin Robert HUDSON - Seite 3
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | Kevin |
Zweites Vornamen | Robert |
Nachname | HUDSON |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 71 |
Zurückgetreten | 25 |
Gesamt | 96 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIP HARRIS MEDICAL LIMITED | 29. März 2000 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Phoenix Healthcare Distribution Ltd, Rivington Road WA7 3DJ Whitehouse Industrial Estate Runcorn Cheshire | England | British | |
SPRINGBURN DISPENSARY LIMITED | 31. Juli 2020 | 31. Juli 2021 | Aktiv | Finance Director | Geschäftsführer | Rivington Road Whitehouse Industrial Estate WA7 3DJ Runcorn L Rowland & Co (Retail) Limited Cheshire England | England | British |
PRACTICE SERVICES UK LIMITED | 30. Nov. 2007 | 31. Juli 2021 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | c/o Phoenix Medical Supplies Limited Rivington Road Whitehouse Industrial Estate WA7 3DJ Runcorn Phoenix Cheshire England | England | British |
NUCARE LIMITED | 12. Nov. 2007 | 31. Juli 2021 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Rivington Road Preston Brook WA7 3DJ Runcorn Phoenix Cheshire | England | British |
NUMARK TRADING LIMITED | 31. Jan. 2006 | 31. Juli 2021 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Rivington Road Whitehouse Industrial Estate WA7 3DJ Runcorn Phoenix Medical Supplies Ltd Cheshire England | England | British |
G PHARMA LIMITED | 31. Jan. 2006 | 31. Juli 2021 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Rivington Road Whitehouse Industrial Estate WA7 3DJ Runcorn Cheshire | England | British |
NUMARK PHARMACISTS LIMITED | 30. Jan. 2006 | 31. Juli 2021 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Rivington Road Whitehouse Industrial Estate WA7 3DJ Runcorn Phoenix Medical Supplies Ltd Cheshire England | England | British |
NUMARK CHEMISTS LIMITED | 24. Jan. 2006 | 31. Juli 2021 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Rivington Road Whitehouse Industrial Estate WA7 3DJ Runcorn Phoenix Medical Supplies Ltd Cheshire England | England | British |
NUPHARM LIMITED | 13. Jan. 2006 | 31. Juli 2021 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Rivington Road Whitehouse Industrial Estate WA7 3DJ Runcorn Cheshire | England | British |
NUMARK LIMITED | 17. Okt. 2005 | 31. Juli 2021 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Rivington Road Whitehouse Industrial Estate WA7 3DJ Runcorn Phoenix Medical Supplies Ltd Cheshire England | England | British |
L.ROWLAND & COMPANY (RETAIL) LIMITED | 18. Okt. 2002 | 31. Juli 2021 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Rivington Road Whitehouse Industrial Estate WA7 3DJ Runcorn L Rowland & Co (Retail) Limited Cheshire England | England | British |
PHOENIX HEALTHCARE DISTRIBUTION LIMITED | 01. März 2000 | 31. Juli 2021 | Aktiv | Finance Director | Geschäftsführer | Rivington Road Whitehouse Industrial Estate WA7 3DJ Runcorn Cheshire | England | British |
PHOENIX MEDICAL SUPPLIES LIMITED | 01. März 2000 | 31. Juli 2021 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Rivington Road Whitehouse WA7 3DJ Runcorn Cheshire | England | British |
NUMARK DIGITAL LIMITED | 06. Apr. 2021 | 31. Juli 2021 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Whitehouse Industrial Estate WA7 3DJ Runcorn Rivington Road Cheshire England | England | British |
JENNER'S PHARMACY LIMITED | 01. Juni 2019 | 31. Juli 2021 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | c/o L Rowland Company Retail Limited Rivington Road Whitehouse Industrial Estate WA7 3DJ Runcorn Cheshire | England | British |
PAS HOLDING COMPANY LTD | 07. März 2019 | 31. Juli 2021 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Rivington Road Whitehouse Industrial Estate, Preston Brook WA7 3DJ Runcorn C/O Phoenix Cheshire United Kingdom | England | British |
WROSE HEALTH CENTRE P.D. LIMITED | 01. Feb. 2019 | 31. Juli 2021 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Rivington Road Whitehouse Industrial Estate WA7 3DJ Runcorn Rowlands Pharmacy Cheshire | England | British |
MISTRY PHARMACY LIMITED | 01. März 2011 | 31. Juli 2021 | Aufgelöst | Group Finance Director | Geschäftsführer | C/O Rowland & Co Retail Ltd Rivington Road Whitehouse WA7 3DJ Industrial Estate Preston Brook Runcorn Cheshire | England | British |
G.F. O'BRIEN HOLDINGS LIMITED | 01. März 2011 | 31. Juli 2021 | Aufgelöst | Group Finance Director | Geschäftsführer | Rivington Road Whitehouse Industrial Est WA7 3DJ Runcorn Cheshire | England | British |
J.A.HAINSTOCK LIMITED | 01. März 2011 | 31. Juli 2021 | Aufgelöst | Group Finance Director | Geschäftsführer | C/O Rowlands & Co Retail Ltd Rivington Road Whitehouse WA7 3DJ Industrial Estate Preston Brook Runcorn Cheshire | England | British |
G. F. O'BRIEN LIMITED | 01. März 2011 | 31. Juli 2021 | Aufgelöst | Group Finance Director | Geschäftsführer | L Rowland & Co (Retail) Limited Rivington Road WA7 3DJ Whitehouse, Runcorn Cheshire | England | British |
B.B.R. (SKELMERS DALE) LIMITED | 01. März 2011 | 31. Juli 2021 | Aufgelöst | Group Finance Director | Geschäftsführer | Rivington Road Whitehouse Industrial Estate WA7 3DJ Runcorn L Rowland & Co (Retail) Ltd Cheshire | England | British |
PHOENIX DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED | 09. Feb. 2009 | 31. Juli 2021 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Rivington Road Whitehouse Industrial Estate WA7 3DJ Runcorn Cheshire | England | British |
L.ROWLAND & COMPANY LIMITED | 25. Juni 2002 | 31. Juli 2021 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Phoenix Medical Supplies Limited Rivington Road Whitehouse WA7 3DJ Preston Brook Runcorn Cheshire | England | British |
QUANTUM PHARMACEUTICAL LIMITED | 06. Apr. 2005 | 31. Jan. 2009 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | 4 Dean Drive WA14 3NE Bowdon Cheshire | England | British |
P C T LOGISTICS LIMITED | 30. Nov. 2001 | 21. Sept. 2006 | Aufgelöst | Director | Sekretär | 4 Dean Drive WA14 3NE Bowdon Cheshire | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0