Mark Lewis GLATMAN - Seite 2
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | Mark |
Zweites Vornamen | Lewis |
Nachname | GLATMAN |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 18 |
Inaktiv | 26 |
Zurückgetreten | 45 |
Gesamt | 89 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHATHAM MARITIME G1 CONSTRUCTION LIMITED | 07. März 2005 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Well Hall Well DL8 2PX Bedale North Yorkshire | England | British | |
ABSTRACT LAND (BIRMINGHAM) LIMITED | 10. Nov. 2004 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Queens House 34 Wellington Street LS1 2DE Leeds West Yorkshire | England | British | |
LEGACY 2013 LIMITED | 11. Aug. 2000 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | c/o Begbies Traynor Deansgate M3 4LY Manchester 340 | England | British | |
ARTVEST LIMITED | 12. Juni 2000 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | King Street SW1Y 6RE London 10 Rose And Crown Yard England | England | British | |
ABSTRACT SELECT LIMITED | 04. Apr. 2000 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | King Street SW1Y 6RE London 10 Rose And Crown Yard England | England | British | |
ABSTRACT SECURITIES LIMITED | 14. März 2000 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | King Street SW1Y 6RE London 10 Rose And Crown Yard England | England | British | |
ABSTRACT INVESTMENTS LIMITED | Aktiv | Director & Solicitor | Geschäftsführer | King Street SW1Y 6RE London 10 Rose And Crown Yard England | England | British | ||
BRITLAW LIMITED | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Queens House 34,Wellington Street LS1 2DE Leeds | England | British | ||
AIMSHOT LIMITED | Aufgelöst | Solicitor/Company Director | Geschäftsführer | Queens House 34 Wellington Street LS1 2DE Leeds | England | British | ||
ROXHILL WARTH 3 LIMITED | 18. Feb. 2016 | 15. Feb. 2024 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Valley Drive Swift Valley Industrial Estate CV21 1TQ Rugby Lumonics House Warwickshire United Kingdom | England | British |
ROXHILL DEVELOPMENTS HOLDINGS LIMITED | 18. Feb. 2016 | 30. Mai 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Valley Drive Swift Valley Industrial Estate CV21 1TQ Rugby Lumonics House Warwickshire United Kingdom | England | British |
ROXHILL DEVELOPMENTS GROUP LIMITED | 26. Nov. 2010 | 21. Apr. 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | 34 Wellington Street LS1 2DE Leeds Queens House United Kingdom | England | British |
BRE-BMR CITP (CAMBRIDGE) LIMITED | 19. Apr. 2001 | 13. Aug. 2021 | Aktiv | Solicitor | Geschäftsführer | Mcclintock Building Granta Park, Great Abington CB21 6GP Cambridge C/O Biomed Realty, L.P. England | England | British |
ROXHILL (MAIDSTONE) LIMITED | 18. Feb. 2016 | 02. Sept. 2020 | Liquidation | Director | Geschäftsführer | Valley Drive Swift Valley Industrial Estate CV21 1TQ Rugby Lumonics House Warwickshire England | England | British |
TP112 LIMITED | 18. Nov. 2010 | 14. Juli 2020 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 34 Wellington Street LS1 2DE Leeds Queens House West Yorkshire United Kingdom | England | British |
SEGRO (JUNCTION 15) LIMITED | 18. Feb. 2016 | 09. März 2020 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Valley Drive Swift Valley CV21 1TQ Rugby Lumonics House Warwickshire | England | British |
SEGRO (COVENTRY M6 J2) LIMITED | 18. Feb. 2016 | 09. März 2020 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Valley Drive Swift Valley Industrial Estate CV21 1TQ Rugby Lumonics House Warwickshire England | England | British |
SEGRO (COVENTRY) LIMITED | 18. Feb. 2016 | 27. Jan. 2020 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Valley Drive Swift Valley CV21 1TQ Rugby Lumonics House Warwickshire | England | British |
FLORENCE BUILDING (BASINGSTOKE) LIMITED | 06. Apr. 2016 | 12. Dez. 2018 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Coleman Street EC2R 5AA London One England | England | British |
SEGRO (READING) LIMITED | 18. Feb. 2016 | 06. Sept. 2018 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Valley Drive Swift Valley CV21 1TQ Rugby Lumonics House Warwickshire | England | British |
SEGRO (RUSHDEN) LIMITED | 18. Feb. 2016 | 06. Sept. 2018 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Valley Drive Swift Valley Industrial Estate CV21 1TQ Rugby Lumonics House Warwickshire England | England | British |
ROXHILL (HOWBURY) LIMITED | 18. Feb. 2016 | 06. Sept. 2018 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Valley Drive Swift Valley Industrial Estate CV21 1TQ Rugby Lumonics House Warwickshire England | England | British |
ALBEMARLE CROYDON LLP | 02. Juli 2007 | 16. Jan. 2018 | Aufgelöst | Bestelltes Mitglied der LLP | Well Hall Well DL8 2PX Bedale | England | ||
VINCENT GLASGOW 2017 LIMITED | 23. Juni 2011 | 30. Okt. 2017 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 34 Wellington Street LS1 2DE Leeds Queens House West Yorkshire United Kingdom | England | British |
PHARMACY2U LIMITED | 02. Juni 2008 | 02. Juli 2016 | Aktiv | Director Solicitor | Geschäftsführer | Hawthorn Park, Coal Road LS14 1PQ Leeds 1 United Kingdom | England | British |
SEGRO (EMG) LIMITED | 18. Feb. 2016 | 01. Juni 2016 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Valley Drive Swift Valley CV21 1TQ Rugby Lumonics House Wawickshire | England | British |
CRAWLEY HOLDINGS LIMITED | 20. Feb. 2014 | 31. Juli 2015 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 34 Wellington Street LS1 2DE Leeds Queens House West Yorkshire United Kingdom | England | British |
OLD CORNWALL LIMITED | 04. Okt. 2012 | 03. Nov. 2014 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 34 Wellington Street LS1 2DE Leeds Queens House West Yorkshire United Kingdom | England | British |
UPPINGHAM SCHOOL | 01. Sept. 2012 | 21. Juni 2014 | Aktiv | Company Director Solictor | Geschäftsführer | High Street West LE15 9QD Uppingham Uppingham School Rutland | England | British |
EVANS REGENERATION INVESTMENTS LIMITED | 04. Juli 2007 | 01. Juli 2011 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 34 Wellington Street LS1 2DE Leeds Queens House Yorkshire | England | British |
CONTEMPORARY ART SOCIETY(THE) | 29. Juli 2009 | 20. Mai 2010 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 34 Wellington Street LS1 2DE Leeds Queens House West Yorkshire | England | British |
PRIMARY HEALTH INVESTMENT PROPERTIES (NO.4) LIMITED | 30. März 2001 | 17. Feb. 2010 | Aktiv | Director Solicitor | Geschäftsführer | Queens House 34 Wellington Street LS1 2DE Leeds West Yorkshire | England | British |
17-22 TREVOR SQUARE (MANAGEMENT) COMPANY LIMITED | 16. Aug. 2007 | 11. Sept. 2009 | Aktiv | Director Solicitor | Geschäftsführer | Well Hall Well DL8 2PX Bedale North Yorkshire | England | British |
ABSTRACT INVESTMENTS LIMITED | 08. Jan. 2008 | Aktiv | Sekretär | Well Hall Well DL8 2PX Bedale North Yorkshire | British | |||
INGLEBY (1648) LIMITED | 08. Feb. 2005 | 29. Dez. 2006 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Well Hall Well DL8 2PX Bedale North Yorkshire | England | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0