Justin William HERBERT - Seite 4
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | Justin |
Zweites Vornamen | William |
Nachname | HERBERT |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 2 |
Inaktiv | 6 |
Zurückgetreten | 151 |
Gesamt | 159 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBER WHARF MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 19. Mai 2010 | 22. Juli 2015 | Aktiv | Operations Director | Geschäftsführer | Chelford House CW9 9EY Northwich PO BOX 553 Cheshire United Kingdom | England | British |
RIVERSIDE PLACE (KNUTSFORD) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 05. Juni 2015 | 25. Juni 2015 | Aktiv | Operations Director | Geschäftsführer | Essex Road EN11 0DR Hoddesdon C/O Rmg House Hertfordshire | England | British |
STAITHS (PHASE 1) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 15. Sept. 2010 | 15. Mai 2015 | Aktiv | Operations Director | Geschäftsführer | Chelford House CW9 9EY Northwich PO BOX 553 Cheshire United Kingdom | England | British |
CHARTER PLACE (LICHFIELD) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 15. Sept. 2010 | 24. Apr. 2015 | Aktiv | Operations Director | Geschäftsführer | Chelford House CW9 9EY Northwich PO BOX 553 Cheshire United Kingdom | England | British |
LATHAM PARK (IRLAM) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 10. Juli 2012 | 31. März 2015 | Aktiv | Operations Director | Geschäftsführer | Gadbrook Park CW9 7LN Northwich Chelford House Cheshire United Kingdom | England | British |
CENTRAL GRANGE (KENTON) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 15. Sept. 2010 | 13. Nov. 2014 | Aktiv | Operations Directors | Geschäftsführer | Chelford House CW9 9EY Northwich PO BOX 553 Cheshire United Kingdom | England | British |
CANAL VIEW (FAILSWORTH) RESIDENTS ASSOCIATION LIMITED | 17. Apr. 2014 | 23. Okt. 2014 | Aktiv | Operations Director | Geschäftsführer | Rudheath Way Rudheath CW9 7LN Northwich Chelford House Cheshire England | England | British |
SCHOLARS GATE (S UPON A) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 15. Sept. 2010 | 18. Aug. 2014 | Aktiv | Operations Director | Geschäftsführer | Chelford House CW9 9EY Northwich PO BOX 553 Cheshire United Kingdom | England | British |
WATERFORD COURT MANAGEMENT COMPANY(FARNWORTH) LIMITED | 15. Sept. 2010 | 30. Apr. 2014 | Aktiv | Operations Director | Geschäftsführer | Chelford House CW9 9EY Northwich PO BOX 553 Cheshire United Kingdom | England | British |
FIELDFARES PROPERTY MANAGEMENT COMPANY (ARCLID) LIMITED | 03. Sept. 2013 | 15. Apr. 2014 | Aktiv | Operations Director | Geschäftsführer | Rmg House Essex Road EN11 1FB Hoddesdon PO BOX 351 Hertfordshire England | England | British |
SHERWOOD MEWS MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 19. Nov. 2010 | 03. März 2014 | Aktiv | Operations Director | Geschäftsführer | Chelford House CW9 9EY Northwich PO BOX 553 Cheshire United Kingdom | England | British |
ROSEMOOR (NO. 2) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 01. Aug. 2010 | 25. Feb. 2014 | Aktiv | Operations Director | Geschäftsführer | PO BOX 553 CW9 9EY Northwich Chelford House Cheshire United Kingdom | England | British |
THE PARK (NO. 2) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 19. Mai 2010 | 27. Jan. 2014 | Aufgelöst | Operations Director For A Property Management Co | Geschäftsführer | PO BOX 553 CW9 9EY Northwich Chelford House Cheshire | England | British |
BURTON COURT RESIDENTS ASSOCIATION LIMITED | 15. Sept. 2010 | 18. Dez. 2013 | Aktiv | Operations Director | Geschäftsführer | Essex Road EN11 0DR Hoddesdon Rmg Hertfordshire England | England | British |
WINKER GREEN MILLS MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 01. Aug. 2010 | 29. Okt. 2013 | Aktiv | Operations Director | Geschäftsführer | PO BOX 553 CW9 9EY Northwich Chelford House Cheshire United Kingdom | England | British |
QUAY PARK (PELAW) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 15. Sept. 2010 | 02. Okt. 2013 | Aktiv | Operations Director | Geschäftsführer | Chelford House CW9 9EY Northwich PO BOX 553 Cheshire United Kingdom | England | British |
RYELANDS COURT (LEOMINSTER) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 09. Nov. 2011 | 04. Sept. 2013 | Aktiv | Operations Director | Geschäftsführer | Gadbrook Park CW9 7LN Northwich Chelford House Cheshire England | England | British |
COOKHAM HOUSE (DUNSTON RIVERSIDE) MANAGEMENT LIMITED | 18. Feb. 2013 | 10. Aug. 2013 | Aktiv | Operations Director | Geschäftsführer | Rmg House Essex Road EN11 1FB Hoddesdon PO BOX 351 Hertfordshire England | England | British |
QMS (LYTHAM) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 15. Sept. 2010 | 05. Juni 2013 | Aktiv | Operations Director | Geschäftsführer | Chelford House CW9 9EY Northwich PO BOX 553 Cheshire United Kingdom | England | British |
ASTLEY PARK (NO. 1) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 01. Aug. 2010 | 16. Mai 2013 | Aktiv | Operations Director | Geschäftsführer | Essex Road EN11 0DR Hoddesdon Rmg Hertfordshire England | England | British |
ASTLEY PARK (NO.2) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 01. Aug. 2010 | 16. Mai 2013 | Aktiv | Operations Director | Geschäftsführer | PO BOX 553 Chelford House CW9 9EY Northwich Rmg House Cheshire England | England | British |
MOOR LANE (PRESTON) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 15. Sept. 2010 | 02. Mai 2013 | Aktiv | Operations Director | Geschäftsführer | Chelford House CW9 9EY Northwich PO BOX 553 Cheshire | England | British |
BREME PARK MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 15. Sept. 2010 | 02. Apr. 2013 | Aktiv | Operations Director | Geschäftsführer | PO BOX 553 Chelford House CW9 9EY Northwich Rmg House Cheshire United Kingdom | England | British |
RUNSHAW MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 15. Sept. 2010 | 01. Apr. 2013 | Aktiv | Operation Director | Geschäftsführer | Chelford House CW9 9EY Northwich PO BOX 553 Cheshire United Kingdom | England | British |
UPTON BLOCK 1-3 (MILLER HOMES) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 15. Sept. 2010 | 12. März 2013 | Aktiv | Operations Director | Geschäftsführer | Essex Road PO BOX 351 EN11 1FB Hoddesdon Rmg House Hertfordshire United Kingdom | England | British |
361 DEANSGATE LIMITED | 15. Sept. 2010 | 29. Jan. 2013 | Aktiv | Operations Director | Geschäftsführer | PO BOX 553 Chelford House CW9 9EY Northwich Rmg House Cheshire United Kingdom | England | British |
FIELDFARES PROPERTY MANAGEMENT COMPANY (ARCLID) LIMITED | 15. Sept. 2010 | 11. Dez. 2012 | Aktiv | Operations Director | Geschäftsführer | Chelford House CW9 9EY Northwich PO BOX 553 Cheshire United Kingdom | England | British |
HOPPING MILL MEADOW (MILFORD) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 15. Sept. 2010 | 28. Nov. 2012 | Aktiv | Operations Director | Geschäftsführer | Chelford House CW9 9EY Northwich PO BOX 553 Cheshire United Kingdom | England | British |
GREENCROFT (NO.1) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 01. Aug. 2010 | 22. Nov. 2012 | Aktiv | Operations Director | Geschäftsführer | Chelford House CW9 9EY Northwich PO BOX 553 Cheshire United Kingdom | England | British |
UPTON BLOCK 1-3 (MILLER HOMES) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 15. Sept. 2010 | 31. Okt. 2012 | Aktiv | Operations Director | Geschäftsführer | Chelford House CW9 9EY Northwich PO BOX 553 Cheshire United Kingdom | England | British |
AGECROFT APARTMENTS MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 06. Feb. 2012 | 11. Okt. 2012 | Aufgelöst | Operations Director | Geschäftsführer | Gadbrook Park CW9 7LN Northwich Chelford House Cheshire England | England | British |
WYCHWOOD VILLAGE (NANTWICH) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 15. Sept. 2010 | 27. Sept. 2012 | Aufgelöst | Operations Director | Geschäftsführer | Chelford House CW9 9EY Northwich PO BOX 553 Cheshire United Kingdom | England | British |
NORDEN LODGE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 15. Sept. 2010 | 03. Juli 2012 | Aktiv | Operations Director | Geschäftsführer | Chelford House CW9 9EY Northwich PO BOX 553 Cheshire United Kingdom | England | British |
NIGHTINGALE GARDENS (MONYHULL NO.2) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 15. Sept. 2010 | 15. Juni 2012 | Aktiv | Operations Director | Geschäftsführer | Chelford House CW9 9EY Northwich PO BOX 553 Cheshire United Kingdom | England | British |
HARDWICK HEIGHTS MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 19. Mai 2010 | 27. Apr. 2012 | Aktiv | Operations Director For A Property Management Co | Geschäftsführer | PO BOX 553 CW9 9EY Northwich Chelford House Cheshire | England | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0