FINE FARE PROPERTIES LIMITED

FINE FARE PROPERTIES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaFINE FARE PROPERTIES LIMITED
    Estado de la empresaConvertida/Cerrada
    Forma jurídicaConvertida o cerrada
    Número de empresa 00002907
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de FINE FARE PROPERTIES LIMITED?

    • (7020) /

    ¿Dónde se encuentra FINE FARE PROPERTIES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de FINE FARE PROPERTIES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    AERATED BREAD COMPANY LIMITED28 oct 186228 oct 1862

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de FINE FARE PROPERTIES LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el04 ene 2011
    Próximas cuentas vencen el04 oct 2011
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta02 ene 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para FINE FARE PROPERTIES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Certificado de registro de una Sociedad de Socorros Mutuos

    páginasCERTIPS

    Misceláneos

    Forms b and z- conversion to I &ps
    páginasMISC

    Resoluciones

    Resolutions
    páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Convert to I & ps 05/10/2010
    RES13

    Nombramiento de Mr Stephen Parry como secretario

    páginasAP03

    Déclaration annuelle établie au 01 sept 2010 avec liste complète des actionnaires

    páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital14 sept 2010

    Estado de capital el 14 sept 2010

    • Capital: GBP 20,045,030
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 02 ene 2010

    páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Timothy Hurrell el 01 ago 2010

    páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Stephen Humes el 01 ago 2010

    páginasCH01

    Domicilio social registrado cambiado de Somerfield House Whitchurch Lane Bristol BS14 0TJ el 23 feb 2010

    páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 02 may 2009

    páginasAA

    Exercice comptable en cours raccourci du 30 abr 2010 au 04 ene 2010

    páginasAA01

    Renuncia del auditor

    páginasAUD

    Cese del nombramiento de William Robson como director

    páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Caroline Jane Sellers como secretario

    páginasAP03

    Cese del nombramiento de Emily Martin como secretario

    páginasTM02

    legacy

    páginas363a

    legacy

    páginas288b

    legacy

    páginas363a

    legacy

    páginas288a

    legacy

    páginas288a

    legacy

    páginas288b

    legacy

    páginas288a

    Cuentas completas preparadas hasta el 26 abr 2008

    páginasAA

    legacy

    páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 28 abr 2007

    páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de FINE FARE PROPERTIES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PARRY, Stephen
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Secretario
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    154611440001
    SELLERS, Caroline Jane
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    M60 4es
    United Kingdom
    Secretario
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    M60 4es
    United Kingdom
    146911920001
    HUMES, Stephen
    c/o Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    United Kingdom
    Director
    c/o Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    United Kingdom
    United KingdomBritish84087790001
    HURRELL, Timothy
    c/o Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    United Kingdom
    Director
    c/o Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    United Kingdom
    United KingdomBritish99724260001
    BROWN, Michael Alfred
    Windrush Great Billing Park
    NN3 9BL Northampton
    Northamptonshire
    Secretario
    Windrush Great Billing Park
    NN3 9BL Northampton
    Northamptonshire
    British50692920001
    EGITTO, Joleen
    3 Abbots Close
    Whitchurch
    BS14 0UD Bristol
    Secretario
    3 Abbots Close
    Whitchurch
    BS14 0UD Bristol
    British61599540001
    GRANT, Stephen Martin
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Secretario
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    British20888800002
    GRANT, Stephen Martin
    2 Beechwood Close
    Battledown
    GL52 6QQ Cheltenham
    Gloucestershire
    Secretario
    2 Beechwood Close
    Battledown
    GL52 6QQ Cheltenham
    Gloucestershire
    British20888800001
    HENSHAW, Stephen Anthony
    Eastleigh Stables
    Bishopstrow
    BA12 9HW Warminster
    Wiltshire
    Secretario
    Eastleigh Stables
    Bishopstrow
    BA12 9HW Warminster
    Wiltshire
    British91828160006
    MARTIN, Emily Louise
    49 Henley Park
    Yatton
    BS49 4JJ Bristol
    Secretario
    49 Henley Park
    Yatton
    BS49 4JJ Bristol
    British115285710001
    ASHTON, Yvonne Margaret
    1 West Dene
    Stoke Bishop
    BS9 2BQ Bristol
    Avon
    Director
    1 West Dene
    Stoke Bishop
    BS9 2BQ Bristol
    Avon
    British45225070002
    BACK, Steven John
    Fennels 119 Bicester Road
    Lower End
    HP18 9EF Long Crendon
    Director
    Fennels 119 Bicester Road
    Lower End
    HP18 9EF Long Crendon
    United KingdomBritish85825120001
    CHEYNE, David George Thomson
    The Covert 98 Woodlands Road
    Ashurst
    SO40 7AH Southampton
    Hampshire
    Director
    The Covert 98 Woodlands Road
    Ashurst
    SO40 7AH Southampton
    Hampshire
    BritainBritish74956170001
    CLELAND, Jonathan Bradley
    70 Andes Close
    Ocean Village
    SO14 3HS Southampton
    Director
    70 Andes Close
    Ocean Village
    SO14 3HS Southampton
    British111624590001
    COATES, Philip Raymond
    2 Berestede Road
    W6 9NP London
    Director
    2 Berestede Road
    W6 9NP London
    United KingdomBritish60114990002
    COOPER, Geoffrey Ian
    Crossways House Old Coach Road
    Cross
    BS26 2EL Axbridge
    Somerset
    Director
    Crossways House Old Coach Road
    Cross
    BS26 2EL Axbridge
    Somerset
    British59071930001
    GATTO, Salvatore Martin
    11 Cavendish Lodge
    Cavendish Road
    BA1 2UD Bath
    Avon
    Director
    11 Cavendish Lodge
    Cavendish Road
    BA1 2UD Bath
    Avon
    United KingdomBritish37327260002
    GRANT, Stephen Martin
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    British20888800002
    HARTE, Damien Bernard
    13 Cambridge Park
    Redland
    BS6 6XW Bristol
    Director
    13 Cambridge Park
    Redland
    BS6 6XW Bristol
    British33922420001
    HENSHAW, Stephen Anthony
    2 Ashton Coombe Lower Road
    Bratton
    BA13 4JQ Westbury
    Wiltshire
    Director
    2 Ashton Coombe Lower Road
    Bratton
    BA13 4JQ Westbury
    Wiltshire
    British91828160003
    MITCHELL INNES, Alistair Campbell
    Langton Lodge Station Road
    Sunningdale
    SL5 0QR Ascot
    Berkshire
    Director
    Langton Lodge Station Road
    Sunningdale
    SL5 0QR Ascot
    Berkshire
    British1386650001
    NELLIST, Robert Henry Harger
    Spooners 28 Park St Lane
    Park Street
    AL2 2JB St Albans
    Hertfordshire
    Director
    Spooners 28 Park St Lane
    Park Street
    AL2 2JB St Albans
    Hertfordshire
    British5435750001
    ROBSON, William Henry Mark
    12 Kimble Close
    Knightcote
    CV47 2SJ Southam
    Warwickshire
    Director
    12 Kimble Close
    Knightcote
    CV47 2SJ Southam
    Warwickshire
    EnglandBritish57803420002
    SHARP, Ernest Henry
    36 Tufton Court Tufton Street
    Westminster
    SW1P 3QH London
    Director
    36 Tufton Court Tufton Street
    Westminster
    SW1P 3QH London
    British777200001
    SMITH, Alan Frank
    Brambledown Grove Farm
    Droitwich Road Feckenham
    B96 6JA Redditch
    Worcestershire
    Director
    Brambledown Grove Farm
    Droitwich Road Feckenham
    B96 6JA Redditch
    Worcestershire
    British46000100003
    SMITH, Neil Reynold
    27 Broom Farm Close
    Nailsea
    BS48 4YJ Bristol
    Director
    27 Broom Farm Close
    Nailsea
    BS48 4YJ Bristol
    British61599510002

    ¿Tiene FINE FARE PROPERTIES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Standard security
    Creado el 08 oct 1993
    Entregado el 18 oct 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H subjects at unit 1/2 (otherwise 182) township centre easterhouse glasgow t/no GLA101661.
    Personas con derecho
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent & Trustee for Itself & the Banks (As Defined in the Charge)
    Transacciones
    • 18 oct 1993Registro de un cargo (395)
    Standard security reg in scotland 06/09/93
    Creado el 06 sept 1993
    Entregado el 24 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the company to samuel montagu & co limited as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever under the terms of the composite guarantee and debenture
    Breve descripción
    Car park at weaver row srirling.
    Personas con derecho
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transacciones
    • 24 sept 1993Registro de un cargo (395)
    Standard security reg in scotland 06/09/93
    Creado el 06 sept 1993
    Entregado el 24 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the company to samuel montagu & co limited as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever under the terms of the composite gaurantee and debenture
    Breve descripción
    1588 great western road anniesland glasgow title no GLA100884.
    Personas con derecho
    • Samuel Montagu & Co Limitedasagent and Trustee for Itself and the Banks
    Transacciones
    • 24 sept 1993Registro de un cargo (395)
    Standard security reg in scotland 06/09/93
    Creado el 06 sept 1993
    Entregado el 24 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the company to samuel montagu & co limited as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever under the terms of the composite guarantee and debenture
    Breve descripción
    Subjects at new cross centre hamilton,l/h subjects at 88 graham street airdrie title no LAN95127,l/h subjects at 275/277 main street bellshill title no LAN95128,l/h subjects at 28/32 the plaza town centre east kilbride title no LAN95129,l/h subjects at 300 victoria road glasgow title no GLA100883,l/h subjects forming part of shillinghill alloa.
    Personas con derecho
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transacciones
    • 24 sept 1993Registro de un cargo (395)
    Standard security reg in scotland 06/09/93
    Creado el 06 sept 1993
    Entregado el 22 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the company to samuel montagu & co limited as agent and trusteee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever under the terms of the composite guarantee and debenture dated 05/07/93
    Breve descripción
    Area of ground in sinclair street helensburgh title no DMB11150 subjects under title no DMB16528 subjects on the south west side of carrochan road and north west side of lomond road balloch title no DMB18240.
    Personas con derecho
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transacciones
    • 22 sept 1993Registro de un cargo (395)
    Standard security reg in scotland 02/09/93
    Creado el 02 sept 1993
    Entregado el 22 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever
    Breve descripción
    Shop premises at high street lochee dundee.
    Personas con derecho
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transacciones
    • 22 sept 1993Registro de un cargo (395)
    Standard security reg in scotlands 02/09/93
    Creado el 02 sept 1993
    Entregado el 22 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever
    Breve descripción
    Retaildevelopment at high street cowdenbeath.
    Personas con derecho
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transacciones
    • 22 sept 1993Registro de un cargo (395)
    Standard security reg in scotland 02/09/93
    Creado el 02 sept 1993
    Entregado el 22 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever
    Breve descripción
    101/105 high street invergordon.
    Personas con derecho
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transacciones
    • 22 sept 1993Registro de un cargo (395)
    Standard security reg in scotland 02/09/93
    Creado el 02 sept 1993
    Entregado el 22 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever
    Breve descripción
    Retail store at 46/48 high street alness.
    Personas con derecho
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Banks (As Defined)
    Transacciones
    • 22 sept 1993Registro de un cargo (395)
    Standard security reg in scotland 02/09/93
    Creado el 02 sept 1993
    Entregado el 22 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever
    Breve descripción
    Subjects at shillinghill alloa and dingwall,l/h 15/17 and 26 main street prestwick,l/h 485 great western road aberdeen,l/h 26/30 swan street brechin,l/h 45 castle street forfar,l/h 114 dalry road edinburgh,l/h 23 unicorn way glenrothes,subjects at grampian road aviemore.
    Personas con derecho
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Banks (As Defined)
    Transacciones
    • 22 sept 1993Registro de un cargo (395)
    • 27 jul 1994Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 05 jul 1993
    Entregado el 16 jul 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due from the company,each other group company (as defined) andany other present or future subsidiary of gateway group limited (as defined) to the chargee and/or the facility agent and/or the security agent (as defined)
    Breve descripción
    See form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Samuel Montagu & Co. Limitedas Agent and Trustee for the Banks (As Defined)
    Transacciones
    • 16 jul 1993Registro de un cargo (395)
    • 18 mar 1994Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 13 ago 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental deed
    Creado el 05 jul 1993
    Entregado el 15 jul 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the lenders in respect of a guarantee & debenture dated 25/10/89 as amended by a supplemental deed dated 05/07/93
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee
    Transacciones
    • 15 jul 1993Registro de un cargo (395)
    • 18 mar 1994Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 13 ago 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security
    Creado el 19 sept 1991
    Entregado el 04 oct 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee (under the terms of the guarantee & debenture dated 25.10.89 and the charge
    Breve descripción
    Subjects k/a new cross centre, hamilton. (For full details refer to doc 395 ref M216C).
    Personas con derecho
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transacciones
    • 04 oct 1991Registro de una carga
    Standard security
    Creado el 19 sept 1991
    Entregado el 02 oct 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee and debenture dated 25.10.1991
    Breve descripción
    Shillinghill place alloa and others.
    Personas con derecho
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transacciones
    • 02 oct 1991Registro de un cargo (395)
    Standard security
    Creado el 19 sept 1991
    Entregado el 26 sept 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee & debenture dated 25.10.89 & all other security documents
    Breve descripción
    Area of ground at sinclair st, helensburgh county of dumbarton title no dmb 11150 & lease by strathclyde regional council in favour of the fine fare limited title no dmb 16528.
    Personas con derecho
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transacciones
    • 26 sept 1991Registro de una carga
    • 23 oct 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 29 oct 1990
    Entregado el 02 nov 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to be come due from each obligen to the chagee on any account whatsoever to the agent and the banks or any of them (as defined in the charge) under the terms of the financing documents to which such obliger is a party and of each olbiger to the subordinated lenders agent and to the subordinated lenders under the subordinated facilities agreement (all as defined in the charge).
    Breve descripción
    Various properties registered and unregistered, f'hold and r' hold. Please see form 395 (ref: M27) for full details.
    Personas con derecho
    • S G Warburg & Co LTD(As Security Agent)
    • G E Capital Corporate Finance Group Limited(As Subordinated Lenders Agent)
    Transacciones
    • 02 nov 1990Registro de una carga
    • 18 mar 1994Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 29 mar 1994Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 13 ago 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creado el 25 oct 1989
    Entregado el 31 oct 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee as agent & trustee for itself and for the banks as defined in the charge & to G.e capital corporate furnace group limited as agent & trustee for the subordinated lenders (as defined) on any account whatsoever under the terms of the financing docs as defined in the charge & the subordinated facilities agreement dated 17.4.89
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • S.G. Warburg & Co Limited
    Transacciones
    • 31 oct 1989Registro de una carga
    • 01 nov 1990Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 18 mar 1994Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 29 mar 1994Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 31 mar 1994Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 13 ago 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security registered in scotland
    Creado el 07 ago 1986
    Entregado el 21 ago 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    Charge over all the properties listed in the schedule attached to the form 395.
    Personas con derecho
    • Balfour Beatty Limited
    Transacciones
    • 21 ago 1986Registro de una carga
    Mortgage
    Creado el 24 nov 1939
    Entregado el 15 dic 1939
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due etc
    Breve descripción
    The camsden town bakery. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personas con derecho
    • National Prov Bank LTD
    Transacciones
    • 15 dic 1939Registro de una carga
    • 14 may 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 24 nov 1939
    Entregado el 15 dic 1939
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys etc
    Breve descripción
    29, kensington high st, london. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personas con derecho
    • National Provincial Bank LTD
    Transacciones
    • 15 dic 1939Registro de una carga
    Mortgage
    Creado el 24 nov 1939
    Entregado el 15 dic 1939
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due etc
    Breve descripción
    47, high st, floating, london. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personas con derecho
    • National Provincial Bank LTD
    Transacciones
    • 15 dic 1939Registro de una carga
    • 14 may 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 24 nov 1939
    Entregado el 15 dic 1939
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due etc
    Breve descripción
    23, golden green rd, 1, accomodation rd, london, middx. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personas con derecho
    • National Provincial Bank LTD
    Transacciones
    • 15 dic 1939Registro de una carga
    • 14 may 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 24 nov 1939
    Entregado el 15 dic 1939
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due etc
    Breve descripción
    11, princes parade, north finchley, middx. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personas con derecho
    • National Provincial Bank LTD
    Transacciones
    • 15 dic 1939Registro de una carga
    • 14 may 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0