BROOKMANN HOME MANCHESTER 1877 LTD

BROOKMANN HOME MANCHESTER 1877 LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBROOKMANN HOME MANCHESTER 1877 LTD
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00011136
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BROOKMANN HOME MANCHESTER 1877 LTD?

    • Comercio al por mayor de textiles (46410) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
    • Venta al por menor de textiles en establecimientos especializados (47510) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

    ¿Dónde se encuentra BROOKMANN HOME MANCHESTER 1877 LTD?

    Dirección de la sede social
    Kpmg Llp
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BROOKMANN HOME MANCHESTER 1877 LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    DAWSON HOME GROUP LIMITED20 ago 200820 ago 2008
    DORMA GROUP LIMITED18 jul 200218 jul 2002
    C.V. HOME FURNISHINGS LIMITED19 ene 187719 ene 1877

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BROOKMANN HOME MANCHESTER 1877 LTD?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 mar 2013
    Próximas cuentas vencen el31 dic 2013
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2012

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para BROOKMANN HOME MANCHESTER 1877 LTD?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta01 ago 2016
    Próxima declaración de confirmación vence15 ago 2016
    Vencido

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para BROOKMANN HOME MANCHESTER 1877 LTD?

    Declaración anual
    Última declaración anual
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BROOKMANN HOME MANCHESTER 1877 LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Restauración por orden judicial

    3 páginasAC92

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Informe de progreso del administrador hasta 01 may 2015

    18 páginas2.24B

    Aviso de cambio de la administración a la disolución el 22 may 2015

    19 páginas2.35B

    Informe de progreso del administrador hasta 22 may 2015

    19 páginas2.24B

    Domicilio social registrado cambiado de Kpmg Llp 1 St Peter's Square Manchester M2 3AE a Kpmg Llp 1 St Peter's Square Manchester M2 3AE el 29 ene 2015

    2 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de Kpmg Llp St James's Square Manchester M2 6DS a Kpmg Llp 1 St Peter's Square Manchester M2 3AE el 29 ene 2015

    2 páginasAD01

    Aviso de extensión del período de la administración

    21 páginas2.31B

    Informe de progreso del administrador hasta 24 may 2014

    22 páginas2.24B

    Notificación de finalización del acuerdo voluntario

    18 páginas1.4

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    1 páginasF2.18

    Declaración de la propuesta del administrador

    35 páginas2.17B

    Declaración de asuntos con el formulario 2.14B

    12 páginas2.16B

    Cese del nombramiento de Myron Mann como director

    4 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Charles Johnson como director

    2 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de , C/O Uhy Hacker Young, St James Building 79 Oxford Street, Manchester, M1 6HT, United Kingdom el 04 dic 2013

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un administrador

    1 páginas2.12B

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2012

    21 páginasAA

    Notificación al Registro Mercantil del acuerdo voluntario de empresas que entra en vigor

    14 páginas1.1

    Se ha suspendido la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS16(SOAS)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2011

    21 páginasAA

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Déclaration annuelle établie au 01 ago 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital15 ago 2012

    Estado de capital el 15 ago 2012

    • Capital: GBP 33,765,961
    SH01

    ¿Quiénes son los directivos de BROOKMANN HOME MANCHESTER 1877 LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CLUEIT, William Kenneth
    Samron Copthurst Lane
    Whittle Le Woods
    PR6 8LR Chorley
    Lancashire
    Secretario
    Samron Copthurst Lane
    Whittle Le Woods
    PR6 8LR Chorley
    Lancashire
    British42784900001
    CRANNY, Dennis John
    6 Applewood
    Chadderton
    OL9 9UD Oldham
    Greater Manchester
    Secretario
    6 Applewood
    Chadderton
    OL9 9UD Oldham
    Greater Manchester
    British60295060001
    CRANSTON, John Charles
    8 Nottingham Road
    NG25 0LF Southwell
    Nottinghamshire
    Secretario
    8 Nottingham Road
    NG25 0LF Southwell
    Nottinghamshire
    British145205440001
    HUNT, Kieron Anthony
    Heights House Heights Lane
    Fence
    BB12 9JF Burnley
    Lancs
    Secretario
    Heights House Heights Lane
    Fence
    BB12 9JF Burnley
    Lancs
    British10836030001
    HUNT, Malcolm Keith
    c/o Uhy Hacker Young
    79 Oxford Street
    M1 6HT Manchester
    St James Building
    United Kingdom
    Secretario
    c/o Uhy Hacker Young
    79 Oxford Street
    M1 6HT Manchester
    St James Building
    United Kingdom
    British150209980001
    SHINN, Stephen Andrew
    1 Hampshire Close
    SK13 8SA Glossop
    Derbyshire
    Secretario
    1 Hampshire Close
    SK13 8SA Glossop
    Derbyshire
    British116832630001
    ALBINSON, Glenn
    104 Lacey Green
    SK9 4BN Wilmslow
    Cheshire
    Director
    104 Lacey Green
    SK9 4BN Wilmslow
    Cheshire
    British104238290001
    ALBINSON, Glenn
    89 Heyes Lane
    SK9 7LN Alderley Edge
    Cheshire
    Director
    89 Heyes Lane
    SK9 7LN Alderley Edge
    Cheshire
    British74341470002
    BAIN, Neville Clifford, Dr
    High Trees
    Cavendish Road St Georges Hill
    KT13 0JX Weybridge
    Surrey
    Director
    High Trees
    Cavendish Road St Georges Hill
    KT13 0JX Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritish48436050001
    BARTMESS, Andrew Dwayne
    Building Five Universal Square
    Devonshire Street
    M12 6JH Ardwick
    Manchester
    Director
    Building Five Universal Square
    Devonshire Street
    M12 6JH Ardwick
    Manchester
    UsaAmerican118504930001
    BINCH, Richard Paul
    41 Coppice Avenue
    M33 4ND Sale
    Cheshire
    Director
    41 Coppice Avenue
    M33 4ND Sale
    Cheshire
    British71313480001
    CARRIE, James Kemp
    KY13 8GL Kinross
    Lochleven Mills
    Scotland
    Director
    KY13 8GL Kinross
    Lochleven Mills
    Scotland
    ScotlandBritish155134710001
    COOPER, David Gordon
    Building Five Universal Square
    Devonshire Street
    M12 6JH Ardwick
    Manchester
    Director
    Building Five Universal Square
    Devonshire Street
    M12 6JH Ardwick
    Manchester
    United KingdomBritish73528470001
    CRANSTON, John Charles
    8 Nottingham Road
    NG25 0LF Southwell
    Nottinghamshire
    Director
    8 Nottingham Road
    NG25 0LF Southwell
    Nottinghamshire
    EnglandBritish145205440001
    CRANSTON, John Charles
    8 Nottingham Road
    NG25 0LF Southwell
    Nottinghamshire
    Director
    8 Nottingham Road
    NG25 0LF Southwell
    Nottinghamshire
    EnglandBritish145205440001
    DOWDS, Brian Francis
    Little Orchard Sanley Road
    Grindleton
    Clitheroe
    Lancs
    Director
    Little Orchard Sanley Road
    Grindleton
    Clitheroe
    Lancs
    British10014630001
    FOLLEY, Keith
    Coniston 9 Noyna View
    BB8 7AU Colne
    Lancashire
    Director
    Coniston 9 Noyna View
    BB8 7AU Colne
    Lancashire
    British2845500001
    HARTLEY, Michael George
    70 Ravensden Road,
    Renhold,
    MK41 0JY Bedford,
    Bedfordshire
    Director
    70 Ravensden Road,
    Renhold,
    MK41 0JY Bedford,
    Bedfordshire
    United KingdomBritish56889040004
    HARTLEY, Michael George
    Summerfield House White Tor Road
    Starkholmes
    DE4 5JF Matlock
    Derbyshire
    Director
    Summerfield House White Tor Road
    Starkholmes
    DE4 5JF Matlock
    Derbyshire
    British56889040003
    HARTLEY, Michael George
    Summerfield House White Tor Road
    Starkholmes
    DE4 5JF Matlock
    Derbyshire
    Director
    Summerfield House White Tor Road
    Starkholmes
    DE4 5JF Matlock
    Derbyshire
    British56889040003
    HEALY, Christopher William
    50 Marville Road
    Fulham
    SW6 7BD London
    Director
    50 Marville Road
    Fulham
    SW6 7BD London
    United KingdomBritish58484770001
    HOLDEN, William
    2 Belmont Road
    Hindley
    WN2 4JD Wigan
    Lancashire
    Director
    2 Belmont Road
    Hindley
    WN2 4JD Wigan
    Lancashire
    British14591750001
    HUNT, Kieron Anthony
    Heights House Heights Lane
    Fence
    BB12 9JF Burnley
    Lancs
    Director
    Heights House Heights Lane
    Fence
    BB12 9JF Burnley
    Lancs
    EnglandBritish10836030001
    JOHNSON, Charles Senter Brook
    c/o Uhy Hacker Young
    79 Oxford Street
    M1 6HT Manchester
    St James Building
    England
    Director
    c/o Uhy Hacker Young
    79 Oxford Street
    M1 6HT Manchester
    St James Building
    England
    Conneticut UsaAmerican168544270001
    JOHNSON, Charles Senter Brook
    c/o Uhy Hacker Young
    79 Oxford Street
    M1 6HT Manchester
    St James Building
    United Kingdom
    Director
    c/o Uhy Hacker Young
    79 Oxford Street
    M1 6HT Manchester
    St James Building
    United Kingdom
    United StatesAmerican160235650001
    JOHNSON, David Alan
    1 Paddock Chase
    SK12 1XR Poynton
    Cheshire
    Director
    1 Paddock Chase
    SK12 1XR Poynton
    Cheshire
    British51671920001
    LEA, Jonathan David
    Little Manor
    Fulmer Road
    SL9 7EF Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    Little Manor
    Fulmer Road
    SL9 7EF Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish67105270002
    LEWIS, Gareth Howell
    23 The Croft
    Euxton
    PR7 6LH Chorley
    Lancashire
    Director
    23 The Croft
    Euxton
    PR7 6LH Chorley
    Lancashire
    British74425250001
    LUCAS, Bernard
    2 Bledlow Close
    Eccles
    M30 9LP Manchester
    Lancashire
    Director
    2 Bledlow Close
    Eccles
    M30 9LP Manchester
    Lancashire
    British14591740001
    MANN, Myron Tennyson
    Universal Square
    Devonshire Street Ardwick
    M12 6JH Manchester
    Building Five
    United Kingdom
    Director
    Universal Square
    Devonshire Street Ardwick
    M12 6JH Manchester
    Building Five
    United Kingdom
    United KingdomAustralian160235690002
    NIXON, Blake Andrew
    103 Arthur Road
    SW19 7DR Wimbledon
    London
    Director
    103 Arthur Road
    SW19 7DR Wimbledon
    London
    EnglandBritish5872150007
    OST, Michael Stuart
    Pinelawns Chanctonbury Drive
    SL5 9PT Sunningdale
    Berkshire
    Director
    Pinelawns Chanctonbury Drive
    SL5 9PT Sunningdale
    Berkshire
    British16322990001
    RUSSELL, Stephen Barrie
    9 The Close
    Upton
    NG23 5SS Newark
    Nottinghamshire
    Director
    9 The Close
    Upton
    NG23 5SS Newark
    Nottinghamshire
    EnglandBritish4830590001
    SWAIN, Glynn David
    9 Esk Avenue
    Ramsbottom
    BL0 0JA Bury
    Lancashire
    Director
    9 Esk Avenue
    Ramsbottom
    BL0 0JA Bury
    Lancashire
    British14591770001
    SYKES, Sydney Albert
    Breeze Cottage
    6 Cliffe Road
    SK13 8NY Glossop
    Derbyshire
    Director
    Breeze Cottage
    6 Cliffe Road
    SK13 8NY Glossop
    Derbyshire
    British14591780001

    ¿Tiene BROOKMANN HOME MANCHESTER 1877 LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 01 ago 2012
    Entregado el 07 ago 2012
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Aldermore Invoice Finance, a Division of Aldermore Bank PLC
    Transacciones
    • 07 ago 2012Registro de un cargo (MG01)
    Full form debenture
    Creado el 17 may 2011
    Entregado el 24 may 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Leumi Abl Limited ("Leumi")
    Transacciones
    • 24 may 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 29 ago 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creado el 17 may 2011
    Entregado el 21 may 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Dawson International Public Limited
    Transacciones
    • 21 may 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 29 ago 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Creado el 01 mar 2011
    Entregado el 05 mar 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 05 mar 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 28 jul 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A composite guarantee and floating charge
    Creado el 14 feb 2005
    Entregado el 26 feb 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the issuer and from the company to the chargee and all monies due or to become due from the scottish group companies on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    A floating charge over all assets being the whole of the property (including uncalled capital) which is or may be from time to time comprised in the property and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transacciones
    • 26 feb 2005Registro de un cargo (395)
    • 20 ene 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 11 feb 2005
    Entregado el 18 feb 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Gmac Commercial Finance PLC
    Transacciones
    • 18 feb 2005Registro de un cargo (395)
    • 13 may 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    An assignment of credit and other insurance policies
    Creado el 11 feb 2005
    Entregado el 18 feb 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The policy and the whole right title benefit and interest in the policy and all sums arising thereunder. The policy means the credit and other insurance detailed as insurer: euler hermes UK PLC policy no. 185409101, zurich insurance policy no. LE453675, KV453611, GL453716. For details are further policies charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Gmac Commercial Finance PLC
    Transacciones
    • 18 feb 2005Registro de un cargo (395)
    • 13 may 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Charge of deposit
    Creado el 11 feb 2005
    Entregado el 16 feb 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All deposits now and in the future credited to account designation 63106876 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 16 feb 2005Registro de un cargo (395)
    • 13 may 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Trust deed
    Creado el 28 may 1971
    Entregado el 04 jun 1974
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £12,323,906 debenture stock of carrington viyella LTD
    Breve descripción
    Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Commercial Union Assurance Co. LTD
    Transacciones
    • 04 jun 1974Registro de una carga
    • 27 sept 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene BROOKMANN HOME MANCHESTER 1877 LTD algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    28 may 2013Fecha de la reunión para aprobar el CVA
    25 nov 2013Fecha de finalización o terminación del CVA
    Acuerdo voluntario de reestructuración empresarial (CVA)
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Profesional
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Paul Andrew Flint
    Kpmg
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Profesional
    Kpmg
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    2
    FechaTipo
    22 may 2015Fin de la administración
    25 nov 2013Inicio de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Profesional
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Paul Andrew Flint
    Kpmg
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Profesional
    Kpmg
    St James' Square
    M2 6DS Manchester

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0