UNITED LEARNING LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaUNITED LEARNING LTD
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00018582
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de UNITED LEARNING LTD?

    • Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra UNITED LEARNING LTD?

    Dirección de la sede social
    Worldwide House
    Thorpe Wood
    PE3 6SB Peterborough
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de UNITED LEARNING LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    UNITED CHURCH SCHOOLS FOUNDATION LTD03 nov 200403 nov 2004
    THE UNITED CHURCH SCHOOLS FOUNDATION LTD07 jul 200407 jul 2004
    THE CHURCH SCHOOLS FOUNDATION LIMITED18 ene 199318 ene 1993
    CHURCH SCHOOLS COMPANY LIMITED (THE)12 jul 188312 jul 1883

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de UNITED LEARNING LTD?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 ago 2024
    Próximas cuentas vencen el31 may 2025
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 ago 2023

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para UNITED LEARNING LTD?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta30 mar 2025
    Próxima declaración de confirmación vence13 abr 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta30 mar 2024
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para UNITED LEARNING LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Nombramiento de Mr Paul Stuart Mustow como director el 13 feb 2025

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Zoe Asensio Sanchez como director el 24 sept 2024

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Richard Cecil Greenhalgh como director el 23 may 2024

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Christian Norman Brodie como director el 18 abr 2024

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 30 mar 2024 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 ago 2023

    106 páginasAA

    Segunda presentación para el nombramiento de Mr David Brown como director

    3 páginasRP04AP01

    Cambio de datos del director Ms Zoe Asensio-Sanchez el 16 ene 2024

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Ms Zoe Asensio-Sanchez como director el 01 ene 2024

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr David Brown como director el 01 ene 2024

    3 páginasAP01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    29 ene 2024Clarification A second filed ap01 was registered on 29/01/24

    Cese del nombramiento de Stephen Richard Critchley como director el 20 nov 2023

    1 páginasTM01

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed united church schools foundation LTD\certificate issued on 20/07/23
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name20 jul 2023

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 06 jul 2023

    RES15

    Declaración de confirmación presentada el 30 mar 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 ago 2022

    96 páginasAA

    Nombramiento de Mr Neil Andrew Macdonald como director el 30 nov 2022

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Christie Darren Spurling como director el 30 nov 2022

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Michael John Litchfield como director el 21 nov 2022

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Michael David George como director el 21 nov 2022

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Richard Colin Neil Davidson como director el 06 jul 2022

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 30 mar 2022 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 ago 2021

    94 páginasAA

    Cancelación total de la carga 000185820044

    1 páginasMR04

    Cancelación parcial de la carga 000185820038

    1 páginasMR04

    Cancelación parcial de la carga 000185820039

    1 páginasMR04

    Cancelación parcial de la carga 35

    1 páginasMR04

    ¿Quiénes son los directivos de UNITED LEARNING LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HUSSAIN, Alison Laura
    Thorpe Wood
    PE3 6SB Peterborough
    Worldwide House
    England
    Secretario
    Thorpe Wood
    PE3 6SB Peterborough
    Worldwide House
    England
    265457170001
    BRODIE, Christian Norman
    Thorpe Wood
    PE3 6SB Peterborough
    Worldwide House
    England
    Director
    Thorpe Wood
    PE3 6SB Peterborough
    Worldwide House
    England
    United KingdomBritishRetired Banker112114640001
    BROWN, David Nicholas
    Thorpe Wood
    PE3 6SB Peterborough
    Worldwide House
    England
    Director
    Thorpe Wood
    PE3 6SB Peterborough
    Worldwide House
    England
    EnglandBritishChartered Accountant275783940001
    GORDON, Joseph Benjamin
    Thorpe Wood
    PE3 6SB Peterborough
    Worldwide House
    England
    Director
    Thorpe Wood
    PE3 6SB Peterborough
    Worldwide House
    England
    EnglandBritishDirector And Chartered Civil Engineer221045860001
    MACDONALD, Neil Andrew
    Thorpe Wood
    PE3 6SB Peterborough
    Worldwide House
    England
    Director
    Thorpe Wood
    PE3 6SB Peterborough
    Worldwide House
    England
    United KingdomBritishRetired3696630003
    MUSTOW, Paul Stuart
    Thorpe Wood
    PE3 6SB Peterborough
    Worldwide House
    England
    Director
    Thorpe Wood
    PE3 6SB Peterborough
    Worldwide House
    England
    EnglandBritishCivil Engineer / Civil Servant332804490001
    SPURLING, Christie Darren
    Thorpe Wood
    PE3 6SB Peterborough
    Worldwide House
    England
    Director
    Thorpe Wood
    PE3 6SB Peterborough
    Worldwide House
    England
    EnglandBritishCeo208764720001
    HOLMES, Andrew Charles David
    Nene Valley Business Park
    Oundle
    PE8 4HN Peterborough
    Fairline House
    Secretario
    Nene Valley Business Park
    Oundle
    PE8 4HN Peterborough
    Fairline House
    191820050001
    NICHOLSON, James Adam
    Nene Valley Business Park
    Oundle
    PE8 4HN Peterborough
    Fairline House
    United Kingdom
    Secretario
    Nene Valley Business Park
    Oundle
    PE8 4HN Peterborough
    Fairline House
    United Kingdom
    BritishChartered Accountant80044490001
    SMITH, Alan Louis Pottier
    Colwood Park
    Cross Colwood Lane, Bolney
    RH17 5RY Haywards Heath
    West Sussex
    Secretario
    Colwood Park
    Cross Colwood Lane, Bolney
    RH17 5RY Haywards Heath
    West Sussex
    British77667770001
    WALLACE, Charles Hugh
    5 Kings Road
    Oundle
    PE8 4AX Peterborough
    Secretario
    5 Kings Road
    Oundle
    PE8 4AX Peterborough
    British22780750003
    WHIFFEN, Stephen John
    Thorpe Wood
    PE3 6SB Peterborough
    Worldwide House
    England
    Secretario
    Thorpe Wood
    PE3 6SB Peterborough
    Worldwide House
    England
    194325930001
    ASENSIO SANCHEZ, Zoe
    Thorpe Wood
    PE3 6SB Peterborough
    Worldwide House
    England
    Director
    Thorpe Wood
    PE3 6SB Peterborough
    Worldwide House
    England
    EnglandBritishArchitect318045090002
    BAILEY, Richard Charles
    Rose Villa
    Lilling
    YO60 6RP York
    North Yorkshire
    Director
    Rose Villa
    Lilling
    YO60 6RP York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishChartered Accountant63937810001
    BARNES, David Chapman
    Nene Valley Business Park
    Oundle
    PE8 4HN Peterborough
    Fairline House
    United Kingdom
    Director
    Nene Valley Business Park
    Oundle
    PE8 4HN Peterborough
    Fairline House
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant28673750001
    BATHO, Gordon Richard, Emeritus Professor
    3 Archery Rise
    DH1 4LA Durham
    County Durham
    Director
    3 Archery Rise
    DH1 4LA Durham
    County Durham
    BritishEmeritus Professor10338390001
    BEARDWELL, John Hugh William
    32 Newlands Avenue
    WD7 8EL Radlett
    Hertfordshire
    Director
    32 Newlands Avenue
    WD7 8EL Radlett
    Hertfordshire
    BritishStockbroker11979590001
    BREWSTER, David Pearson, Reverend Doctor
    The Vicarage Meerut Road
    SO42 7TD Brockenhurst
    Hampshire
    Director
    The Vicarage Meerut Road
    SO42 7TD Brockenhurst
    Hampshire
    BritishClergyman & Lecturer48446610001
    CAREY, George Leonard, Lord
    Nene Valley Business Park
    Oundle
    PE8 4HN Peterborough
    Fairline House
    United Kingdom
    Director
    Nene Valley Business Park
    Oundle
    PE8 4HN Peterborough
    Fairline House
    United Kingdom
    United KingdomBritishRetired Archbishop Of Canter97704390002
    CLARK, Michael Jeremy, Professor
    Nene Valley Business Park
    Oundle
    PE8 4HN Peterborough
    Fairline House
    United Kingdom
    Director
    Nene Valley Business Park
    Oundle
    PE8 4HN Peterborough
    Fairline House
    United Kingdom
    United KingdomBritishUniversity Professor15098210001
    CRITCHLEY, Stephen Richard, Dr
    Thorpe Wood
    PE3 6SB Peterborough
    Worldwide House
    England
    Director
    Thorpe Wood
    PE3 6SB Peterborough
    Worldwide House
    England
    United KingdomBritishRetired83014270001
    CROWE, Angela Mary
    Thorpe Wood
    PE3 6SB Peterborough
    Worldwide House
    England
    Director
    Thorpe Wood
    PE3 6SB Peterborough
    Worldwide House
    England
    United KingdomBritishBusiness159436400001
    DAVIDSON, Richard Colin Neil
    Thorpe Wood
    PE3 6SB Peterborough
    Worldwide House
    England
    Director
    Thorpe Wood
    PE3 6SB Peterborough
    Worldwide House
    England
    United KingdomBritishCompany Director110114680001
    FAIRBURN, James Jeffrey
    3 Hunt Court
    Aldwark
    YO1 2DE York
    North Yorkshire
    Director
    3 Hunt Court
    Aldwark
    YO1 2DE York
    North Yorkshire
    BritishRetired Director Of Techer Education11909560001
    FOWLES, Sylvia Patricia
    Horsell Vicarage
    GU21 4QQ Woking
    Surrey
    Director
    Horsell Vicarage
    GU21 4QQ Woking
    Surrey
    BritishRetired Lecturer11909570001
    GEORGE, Michael David
    Thorpe Wood
    PE3 6SB Peterborough
    Worldwide House
    England
    Director
    Thorpe Wood
    PE3 6SB Peterborough
    Worldwide House
    England
    EnglandBritishDirector56114600003
    GOULD, Edward John Humphrey
    Nene Valley Business Park
    Oundle
    PE8 4HN Peterborough
    Fairline House
    United Kingdom
    Director
    Nene Valley Business Park
    Oundle
    PE8 4HN Peterborough
    Fairline House
    United Kingdom
    United KingdomBritishRetired101405800001
    GRAYDON, Michael James, Air Chief Marshal Sir
    Nene Valley Business Park
    PE8 4HN Oundle
    Fairline House
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Director
    Nene Valley Business Park
    PE8 4HN Oundle
    Fairline House
    Northamptonshire
    United Kingdom
    EnglandBritishConsultant51709530002
    GREENER, Anthony Armitage, Sir
    Thorpe Wood
    PE3 6SB Peterborough
    Worldwide House
    England
    Director
    Thorpe Wood
    PE3 6SB Peterborough
    Worldwide House
    England
    EnglandBritishDirector52841020003
    GREENHALGH, Richard Cecil
    Thorpe Wood
    PE3 6SB Peterborough
    Worldwide House
    England
    Director
    Thorpe Wood
    PE3 6SB Peterborough
    Worldwide House
    England
    United KingdomBritishExecutive59863820001
    GREY, Frederick Spencer
    15 Melrose Road
    Upper Shirley
    SO15 2BP Southampton
    Hampshire
    Director
    15 Melrose Road
    Upper Shirley
    SO15 2BP Southampton
    Hampshire
    BritishRetired3917750001
    HALL, Michael Lindsay Bracbridge
    60 Upper Kings Drive
    BN20 9AS Eastbourne
    East Sussex
    Director
    60 Upper Kings Drive
    BN20 9AS Eastbourne
    East Sussex
    BritishDistribution Manager U S P G11909580001
    HUNT, Madge
    25 Dumbrells Court
    Ditchling
    BN6 8TG Hassocks
    West Sussex
    Director
    25 Dumbrells Court
    Ditchling
    BN6 8TG Hassocks
    West Sussex
    BritishRetired Headmistress11909670001
    IRWIN, John Gordon
    Nene Valley Business Park
    Oundle
    PE8 4HN Peterborough
    Fairline House
    United Kingdom
    Director
    Nene Valley Business Park
    Oundle
    PE8 4HN Peterborough
    Fairline House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor75131710002
    LAING, David Eric
    Nene Valley Business Park
    Oundle
    PE8 4HN Peterborough
    Fairline House
    United Kingdom
    Director
    Nene Valley Business Park
    Oundle
    PE8 4HN Peterborough
    Fairline House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director8027200005

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para UNITED LEARNING LTD?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    30 mar 2017La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene UNITED LEARNING LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 15 may 2018
    Entregado el 05 jun 2018
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    The freehold property situate at poole dorset and registered at hm land registry under title number DT388020.
    Contiene una promesa negativa:
    Personas con derecho
    • Jeffrey Bainbridge
    • Colin James Bainbridge
    • Judith Bainbridge
    Transacciones
    • 05 jun 2018Registro de una carga (MR01)
    • 28 ene 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 05 oct 2016
    Entregado el 07 oct 2016
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    The freehold property situate at poole dorset and registered at hm land registry under title number DT388020.
    Contiene una promesa negativa:
    Personas con derecho
    • Judith Bainbridge
    • Colin James Bainbridge
    • Jeffrey Bainbridge
    Transacciones
    • 07 oct 2016Registro de una carga (MR01)
    • 07 jun 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 29 jul 2016
    Entregado el 09 ago 2016
    Pendiente
    Breve descripción
    By way of legal mortgage, the property known as dunottar school and registered at hm land registry under title numbers SY665565 and SY186888.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transacciones
    • 09 ago 2016Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 29 jul 2016
    Entregado el 09 ago 2016
    Pendiente
    Breve descripción
    By way of legal mortgage, the property known as hampshire collegiate school and registered at hm land registry under title numbers HP430277, HP730954, HP650777, HP535832, HP379591, HP630850, HP446771, HP638176, HP652519 and HP630851.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transacciones
    • 09 ago 2016Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 29 jul 2016
    Entregado el 09 ago 2016
    Pendiente
    Breve descripción
    By way of legal mortgage, the property known as greenacre school for girls and registered at hm land registry under title numbers SY728886, SY586786, SY367234, SY435130, SY303083, SY122647, SY274751, SY380812 and SY166512.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transacciones
    • 09 ago 2016Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 29 jul 2016
    Entregado el 09 ago 2016
    Parcialmente satisfecho
    Breve descripción
    N/A.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transacciones
    • 09 ago 2016Registro de una carga (MR01)
    • 02 jun 2021Satisfacción parcial de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 26 feb 2014
    Entregado el 01 mar 2014
    Parcialmente satisfecho
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transacciones
    • 01 mar 2014Registro de una carga (MR01)
    • 02 jun 2021Satisfacción parcial de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 19 nov 2010
    Entregado el 24 nov 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H properties k/a surbiton high school, surbiton crescent, surbiton including 147 maple road and 2 surbiton hall crescent t/no's SGL704140, SY323420, SGL9302, SY228320 and SGL13318. For details of further property charged please refer to form MG01.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 24 nov 2010Registro de un cargo (MG01)
    Legal charge
    Creado el 12 jul 2005
    Entregado el 14 jul 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a ashford school, ashford, kent, embley park school, romseromsey, hampshire, friars school, great chart, ashford t/no's K802878, HP446771, HP638176, HP379591, HP630850, HP630851, HP652519, HP650777, K280234, K283827, K865533 and K486625.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 14 jul 2005Registro de un cargo (395)
    • 21 jul 2016Parte del bien o empresa ha sido liberada de la carga (MR05)
    Debenture
    Creado el 20 jul 2004
    Entregado el 31 jul 2004
    Parcialmente satisfecho
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 31 jul 2004Registro de un cargo (395)
    • 02 jun 2021Satisfacción parcial de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 20 jul 2004
    Entregado el 31 jul 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/H property being guildford high school london road guildford surrey t/no SY54593, t/no SY211539, t/no SY408774, t/no SY442115, t/no SY442116, t/no SY442117 & t/no SY442118.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 31 jul 2004Registro de un cargo (395)
    Legal mortgage
    Creado el 10 mar 2004
    Entregado el 17 mar 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £1,500,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Armstrong james building and C.D.T. annexe, ryhope road, sunderland.
    Personas con derecho
    • The University of Sunderland
    Transacciones
    • 17 mar 2004Registro de un cargo (395)
    • 21 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 12 jul 2002
    Entregado el 19 jul 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All f/h land and buildings referred to in a transfer dated 12 july 2002 made between genergy PLC (1) the church schools foundation limited (2) and ttg properties limited (3) and all fixtures fittings plant machinery apparatus goods and materials affixed to or placed upon such property.
    Personas con derecho
    • Ttg Properties Limited
    Transacciones
    • 19 jul 2002Registro de un cargo (395)
    • 21 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 28 feb 2001
    Entregado el 09 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The f/h property k/a lindum view 3 wragby road lincoln t/n's LL14126 and LL160151. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 09 mar 2001Registro de un cargo (395)
    • 21 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 06 jun 2000
    Entregado el 13 jun 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a five parcels of land k/a the cathedral school lincoln lincolnshire t/no LL159809. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 13 jun 2000Registro de un cargo (395)
    • 21 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 21 jun 1999
    Entregado el 01 jul 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The f/hold property known as clifton hall & bede tower burdon road sunderland tyne & wear t/no: TY351855. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 01 jul 1999Registro de un cargo (395)
    • 21 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 21 abr 1998
    Entregado el 11 may 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/Hold property known as property in upper lindum street lincoln lincolnshire (formerly part of st joseph's school); t/no ll 28480. and the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 11 may 1998Registro de un cargo (395)
    • 21 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 21 abr 1998
    Entregado el 11 may 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/Hold property known as the lodge lindum road lincoln lincolnshire; t/no ll 69852. and the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 11 may 1998Registro de un cargo (395)
    • 21 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 15 abr 1997
    Entregado el 21 abr 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a stonefield house and adjoining land chuch lane lincoln lincolnshire t/nos: LL19311 and LL86540 and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 abr 1997Registro de un cargo (395)
    • 21 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 17 sept 1996
    Entregado el 02 oct 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Carlton house mowbray road sunderland and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 02 oct 1996Registro de un cargo (395)
    • 21 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 05 jul 1996
    Entregado el 15 jul 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H k/a land & buildings k/a the surbiton assembley rooms claremont road surbiton surrey t/no sy 41581 and the proceeds of sale thereof & A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 15 jul 1996Registro de un cargo (395)
    • 26 abr 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 29 sept 1995
    Entregado el 20 oct 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a caterham school harestone valley road and caterham school playing fields park avenue caterham t/n sy 651595, sy 651597, sy 651306, sy 651175, sy 651126, sy 311578, sy 651600, sy 651593, sy 651598 and sy 651307 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 20 oct 1995Registro de un cargo (395)
    • 21 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 16 ago 1994
    Entregado el 23 ago 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a the former college of estate management sports ground, manor road, south hinchley wood, surrey and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 23 ago 1994Registro de un cargo (395)
    • 21 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 18 jul 1994
    Entregado el 29 jul 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a northcliffe school, grove place, nursling, southampton and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 29 jul 1994Registro de un cargo (395)
    • 21 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 30 abr 1993
    Entregado el 10 may 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The f/h property high school hull and proceeds of sale thereof and an assignment of the goodwill and connection of any business,,together with the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 10 may 1993Registro de un cargo (395)
    • 21 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0