LONDON TOURIST PUBS LIMITED

LONDON TOURIST PUBS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaLONDON TOURIST PUBS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00023925
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de LONDON TOURIST PUBS LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra LONDON TOURIST PUBS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Resolve Partners Limited 22 York Buildings
    John Adams Street
    WC2N 6JU London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LONDON TOURIST PUBS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CLEVELAND PLACE NOMINEE COMPANY (NO.3) LIMITED25 oct 199325 oct 1993
    GRAND METROPOLITAN NOMINEE COMPANY (NO.6) LIMITED28 may 199128 may 1991
    NORTHAMPTON BREWERY COMPANY,LIMITED(THE)09 feb 188709 feb 1887

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de LONDON TOURIST PUBS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta22 ago 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para LONDON TOURIST PUBS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Declaración de confirmación presentada el 02 mar 2019 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    10 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 11 ene 2018

    9 páginasLIQ03

    Declaración de confirmación presentada el 02 mar 2018 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NL a Resolve Partners Limited 22 York Buildings John Adams Street London WC2N 6JU el 12 sept 2017

    2 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 02 mar 2017 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom a Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NL el 10 feb 2017

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 12 ene 2017

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    9 páginas4.70

    Nombramiento de Lindsay Anne Keswick como secretario el 25 abr 2016

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Claire Susan Stewart como secretario el 25 abr 2016

    1 páginasTM02

    Domicilio social registrado cambiado de Sunrise House Ninth Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 3JZ a Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT el 07 mar 2016

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 02 mar 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 mar 2016

    Estado de capital el 02 mar 2016

    • Capital: GBP 491,168
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 22 ago 2015

    3 páginasAA

    Cese del nombramiento de Jonathan Robert Langford como director el 26 ene 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Daryl Antony Kelly como director el 26 ene 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Lucy Jane Bell como director el 26 ene 2016

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Kirk Dyson Davis como director el 21 dic 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Henry Jones como secretario el 04 dic 2015

    1 páginasTM02

    Exercice comptable en cours raccourci du 24 ago 2016 au 30 abr 2016

    1 páginasAA01

    Cese del nombramiento de Patrick James Gallagher como director el 23 jun 2015

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 02 mar 2015 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 mar 2015

    Estado de capital el 02 mar 2015

    • Capital: GBP 491,168
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 23 ago 2014

    3 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de LONDON TOURIST PUBS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    KESWICK, Lindsay Anne
    22 York Buildings
    John Adams Street
    WC2N 6JU London
    Resolve Partners Limited
    Secretario
    22 York Buildings
    John Adams Street
    WC2N 6JU London
    Resolve Partners Limited
    207523730001
    DAVIS, Kirk Dyson
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish158484730001
    ADAMS, Susanne Margaret
    Azalea
    167 High Street Northchurch
    HP4 3QT Berkhamsted
    Hertfordshire
    Secretario
    Azalea
    167 High Street Northchurch
    HP4 3QT Berkhamsted
    Hertfordshire
    British28738400002
    CUTHBERTSON, Colin
    5 Hill Gardens
    LE16 9EB Market Harborough
    Leicestershire
    Secretario
    5 Hill Gardens
    LE16 9EB Market Harborough
    Leicestershire
    British26369940001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Secretario
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Secretario
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    JONES, Henry
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    180592240001
    KENDALL, Timothy James
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    Secretario
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    British117397470002
    RUDD, Susan Clare
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    172445100001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Secretario
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEVENS, Mark
    5 Lyon Drive
    Murieston
    EH54 9HF Livingston
    West Lothian
    Secretario
    5 Lyon Drive
    Murieston
    EH54 9HF Livingston
    West Lothian
    British80951870001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    181021970001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Other130369890001
    WALMSLEY, Derek Kerr
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    Secretario
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    British135181230001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    BELL, Lucy Jane
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish164754670001
    BUBB, Stewart Edmund Conyers
    Clare Cottage
    42 Lammas Lane
    KT10 8PD Esher
    Surrey
    Director
    Clare Cottage
    42 Lammas Lane
    KT10 8PD Esher
    Surrey
    British36779040001
    CUMMING, Johanna Louise
    18 Prospect Quay
    98 Point Pleasant
    SW18 1PR London
    Director
    18 Prospect Quay
    98 Point Pleasant
    SW18 1PR London
    United KingdomBritish111108910001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141395280001
    GALLAGHER, Patrick James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish205366190001
    GODWIN-BRATT, Robert James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish170184800001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Director
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Director
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    JONES, Karen Elisabeth Dind
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    Director
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    United KingdomBritish47793260007
    KELLY, Daryl Antony
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish86246470001
    KNIGHT, Andrew Ronald
    89 Main Street
    DE13 7ED Alrewas
    Staffordshire
    Director
    89 Main Street
    DE13 7ED Alrewas
    Staffordshire
    British81555100002
    LANGFORD, Jonathan Robert
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish135408140001
    MARGERRISON, Russell John
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish170590800001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Director
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    British42019620001
    MILLER, Louise
    13 Traquair Park West
    EH12 7AN Edinburgh
    Midlothian
    Director
    13 Traquair Park West
    EH12 7AN Edinburgh
    Midlothian
    British63895470001
    MYDDELTON, Roger Hugh
    21 Lawford Road
    NW5 2LH London
    Director
    21 Lawford Road
    NW5 2LH London
    British399500001
    PEAREY, Michael John
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    Director
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    British46305030001
    PEAREY, Michael John
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    Director
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    British46305030001
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish63043630002

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para LONDON TOURIST PUBS LIMITED?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    02 mar 2017La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene LONDON TOURIST PUBS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Security agreement
    Creado el 15 dic 2003
    Entregado el 31 dic 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transacciones
    • 31 dic 2003Registro de un cargo (395)
    • 09 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene LONDON TOURIST PUBS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    12 ene 2017Inicio de la liquidación
    15 abr 2019Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Simon Harris
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    Profesional
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    Ben David Woodthorpe
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    Profesional
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0