FIRST QUENCH RETAILING LIMITED

FIRST QUENCH RETAILING LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaFIRST QUENCH RETAILING LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00030129
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de FIRST QUENCH RETAILING LIMITED?

    • (5225) /

    ¿Dónde se encuentra FIRST QUENCH RETAILING LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O KPMG LLP
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de FIRST QUENCH RETAILING LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CATER STOFFELL & FORTT LIMITED13 nov 188913 nov 1889

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de FIRST QUENCH RETAILING LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta28 jun 2008

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para FIRST QUENCH RETAILING LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para FIRST QUENCH RETAILING LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Informe de progreso del administrador hasta 28 oct 2014

    24 páginas2.24B

    Aviso de cambio de la administración a la disolución el 28 oct 2014

    24 páginas2.35B

    Informe de progreso del administrador hasta 28 abr 2014

    20 páginas2.24B

    Cese del nombramiento de Johan Peter Van De Steen como director el 31 dic 2013

    2 páginasTM01

    Informe de progreso del administrador hasta 28 oct 2013

    19 páginas2.24B

    Informe de progreso del administrador hasta 28 abr 2013

    23 páginas2.24B

    Aviso de extensión del período de la administración

    1 páginas2.31B

    ¿Quiénes son los directivos de FIRST QUENCH RETAILING LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    TJG SECRETARIES LIMITED
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    Secretario corporativo
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    61729550002
    BODEN, Martin Brett, Mr.
    The Green
    Adderbury
    OX17 3NE Banbury
    South House
    Oxfordshire
    Director
    The Green
    Adderbury
    OX17 3NE Banbury
    South House
    Oxfordshire
    EnglandBritish146698050001
    CLELAND, Jonathan Bradley
    Copse Lane
    Chilworth
    SO16 7JY Southampton
    Green Lawns
    Hampshire
    Director
    Copse Lane
    Chilworth
    SO16 7JY Southampton
    Green Lawns
    Hampshire
    United KingdomBritish146698270001
    RICH, Andrew Peter
    Basuto Road
    SW6 4BL London
    41
    Director
    Basuto Road
    SW6 4BL London
    41
    UkBritish138241610001
    BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    Secretario
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    British637110001
    FAIRHURST, Russell William
    37 Windermere Road
    Muswell Hill
    N10 2RD London
    Secretario
    37 Windermere Road
    Muswell Hill
    N10 2RD London
    British44556020003
    HALLETT, Peter John
    The Square House 5 Shakespeare Road
    NN16 9RB Kettering
    Northamptonshire
    Secretario
    The Square House 5 Shakespeare Road
    NN16 9RB Kettering
    Northamptonshire
    British20621770001
    WARNE, Robert Brian
    Oak Tree Cottage Chase Lane
    GU27 3AG Haslemere
    Surrey
    Secretario
    Oak Tree Cottage Chase Lane
    GU27 3AG Haslemere
    Surrey
    British17696870002
    AINLEY, Harvey Bertenshaw
    Hawthorn Hill
    Warfield
    RG42 6HE Bracknell
    Tudor Lodge
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Hawthorn Hill
    Warfield
    RG42 6HE Bracknell
    Tudor Lodge
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish134262810001
    ALEXANDER, Stephen Harold
    40 Thurleigh Road
    SW12 8UD London
    Director
    40 Thurleigh Road
    SW12 8UD London
    British9796990001
    ALLEN, Matthew Charles
    75 Park Road
    W4 3EY London
    Director
    75 Park Road
    W4 3EY London
    EnglandBritish37599910001
    BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    Director
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    British637110001
    BYNG-MADDICK, Zillah
    14 Claremont Gardens
    SL7 1BS Marlow
    Bucks
    Director
    14 Claremont Gardens
    SL7 1BS Marlow
    Bucks
    British98032690002
    DERKACH, John
    Pryor House The Green
    Preston
    SG4 7UD Hitchin
    Hertfordshire
    Director
    Pryor House The Green
    Preston
    SG4 7UD Hitchin
    Hertfordshire
    British48115510001
    FENNEY, Paul Francis
    Porch House
    Church Street Buckden
    PE19 5SX St Neots
    Cambridgeshire
    Director
    Porch House
    Church Street Buckden
    PE19 5SX St Neots
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish97980790001
    FROST, Graham Edward
    Apartment 5 Marloes
    Park Road Bowdon
    WA14 3JF Altrincham
    Cheshire
    Director
    Apartment 5 Marloes
    Park Road Bowdon
    WA14 3JF Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish124882190001
    GOZZETT, Kim
    Hill Farm
    Kelvedon Road Inworth
    CO5 9SX Colchester
    Essex
    Director
    Hill Farm
    Kelvedon Road Inworth
    CO5 9SX Colchester
    Essex
    United KingdomBritish122205910001
    HALLETT, Peter John
    The Square House 5 Shakespeare Road
    NN16 9RB Kettering
    Northamptonshire
    Director
    The Square House 5 Shakespeare Road
    NN16 9RB Kettering
    Northamptonshire
    EnglandBritish20621770001
    HAMMOND, Michael Paul Holway
    18 Picton Way
    Caversham
    RG4 8NJ Reading
    Berkshire
    Director
    18 Picton Way
    Caversham
    RG4 8NJ Reading
    Berkshire
    British29979320002
    HEALY, Martin William Oliver
    Elgin Avenue
    W9 1HT London
    59 Biddulph Mansions
    Director
    Elgin Avenue
    W9 1HT London
    59 Biddulph Mansions
    EnglandIrish134003120001
    JOHNSON, Michael Charles
    19 Hillsleigh Road
    W8 7LE London
    Director
    19 Hillsleigh Road
    W8 7LE London
    British71905430001
    JONES, Bruce Abbott
    1 Hall Drive
    DE13 8TF Hanbury
    Staffordshire
    Director
    1 Hall Drive
    DE13 8TF Hanbury
    Staffordshire
    British29595900002
    KENDALL, Robert Bradley
    32 Russell Road
    W14 8HU London
    Director
    32 Russell Road
    W14 8HU London
    United KingdomBritish81809130002
    MASTERS, John Stephen
    Perryfield House
    Stratton Chase Drive
    HP8 4NS Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Director
    Perryfield House
    Stratton Chase Drive
    HP8 4NS Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish189531480001
    MILLER, Stewart
    King Hams Meadow
    Hudnall Lane
    HP4 1QE Little Gaddesden
    Hertfordshire
    Director
    King Hams Meadow
    Hudnall Lane
    HP4 1QE Little Gaddesden
    Hertfordshire
    British123083780001
    OGINSKY, Kenneth Arnold
    41 Pinfold Hill
    WS14 0JN Shenstone
    Staffordshire
    Director
    41 Pinfold Hill
    WS14 0JN Shenstone
    Staffordshire
    British39198500001
    PERELMAN, Alan Steven
    66 Woodside Avenue
    Highgate
    N6 4ST London
    Director
    66 Woodside Avenue
    Highgate
    N6 4ST London
    British And Australian78359020001
    RANKIN, Yvonne Rose
    The Maples
    Holmes Chapel Road
    WA16 9RD Over Peover
    Cheshire
    Director
    The Maples
    Holmes Chapel Road
    WA16 9RD Over Peover
    Cheshire
    British107621540001
    RICHARDSON, David Hedley
    47b Church End
    Biddenham
    MK40 4AS Bedford
    Director
    47b Church End
    Biddenham
    MK40 4AS Bedford
    United KingdomBritish148710820001
    STEPHENS, Lloyd Anthony
    South Bank
    Warren Farm
    MK43 0TS Ridgmont
    Bedfordshire
    Director
    South Bank
    Warren Farm
    MK43 0TS Ridgmont
    Bedfordshire
    British125923300001
    STEWART, Quentin Richard
    62 Anchor Brew House
    Shad Thames
    SE1 2LY London
    Director
    62 Anchor Brew House
    Shad Thames
    SE1 2LY London
    United KingdomBritish94880800002
    THOMSON, David Malcolm
    60 Brookmans Avenue
    AL9 7QQ Brookmans Park
    Hertfordshire
    Director
    60 Brookmans Avenue
    AL9 7QQ Brookmans Park
    Hertfordshire
    United KingdomBritish103213380001
    VAN DE STEEN, Johan Peter
    Grandison Road
    SW11 6LS London
    27
    Director
    Grandison Road
    SW11 6LS London
    27
    UkBelgian96948750004
    WAGGETT, Colin
    41 Spring Grove
    W4 3NH London
    Director
    41 Spring Grove
    W4 3NH London
    British62266600001
    WALTON, Jeremy Eugene
    Polars
    Wood End Widdington
    CB11 3SN Saffron Walden
    Essex
    Director
    Polars
    Wood End Widdington
    CB11 3SN Saffron Walden
    Essex
    British33776610001

    ¿Tiene FIRST QUENCH RETAILING LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 28 abr 2009
    Entregado el 06 may 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 06 may 2009Registro de un cargo (395)
    Security agreement
    Creado el 28 abr 2009
    Entregado el 01 may 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    3 station road cuffley t/no:HD21998 l/h /91 breck road liverpool merseyside t/no:MS4862 f/h / 43 and 45 st johns way corringham standford le hope essex t/no:EX817947 f/h please see form for further properties charged fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Haig Luxembourg Holdco Sarl
    Transacciones
    • 01 may 2009Registro de un cargo (395)
    Deed of charge over credit balances
    Creado el 27 nov 2006
    Entregado el 08 dic 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Barclays bank PLC re first quench retailing limited business premium account account number 40385840. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 08 dic 2006Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 23 ago 2004
    Entregado el 01 sept 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The properties being 135 cold bath road harrogate t/n MYK284668, 205 earls court road kensington london, l/h, LN110204, 4 lupus street pimlico london t/n LN178939,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transacciones
    • 01 sept 2004Registro de un cargo (395)
    • 30 abr 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent charge
    Creado el 15 ago 2003
    Entregado el 05 sept 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £4,873.00 due from the company to the chargee
    Breve descripción
    617 roundhay rd,leeds.
    Personas con derecho
    • Accenti Kitchens Limited
    Transacciones
    • 05 sept 2003Registro de un cargo (395)
    • 30 ene 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creado el 21 jul 2003
    Entregado el 26 jul 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £4,375.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The interest in the deposit account.
    Personas con derecho
    • Leonard James Lewis, Philip John Bradford, Union Pension Trustees Limited
    Transacciones
    • 26 jul 2003Registro de un cargo (395)
    • 24 ene 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 1 december 2000 and
    Creado el 17 nov 2000
    Entregado el 15 dic 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and carmelite acquisitions limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    620 crow road glasgow, 423 dumbarton road glasgow, 676 edinburgh road glasgow (for details of further properties charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 15 dic 2000Registro de un cargo (395)
    • 15 jul 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security agreement between the company carmelite acquisitions limited and the security agent
    Creado el 16 oct 2000
    Entregado el 23 oct 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities of the chargors to any funding party (as defined) under each funding document (as defined) to which the chargors are a party except for the obligation which if it were so included would result in the deed contravening section 151 of the companies act 1985
    Breve descripción
    Each of the chargors secures by way of a first equitable mortgage all estates or interests of the chargors in any freehold property or long leasehold property (other than in scotland) and all shares and stocks owned by it or held by any nominee on its behalf and a floating charge (1) all its assets not otherwise effectively mortgaged or charged and (2) all its assets situated in scotland. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC (The Security Agent) as Security Agent and Trustee for the Funding Parties
    Transacciones
    • 23 oct 2000Registro de un cargo (395)
    • 16 sept 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 10 nov 1999
    Entregado el 15 nov 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 15 nov 1999Registro de un cargo (395)
    • 27 oct 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture (creating assignments over advance purchase agreements and a floating charge over tobacco stocks)
    Creado el 11 dic 1998
    Entregado el 21 dic 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the financing documents (as defined in the debenture)
    Breve descripción
    The tobacco stocks together with all the company's right title and interest in and to all and each of the advance purchase agreements and all proceeds of any claim or action under the same. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 dic 1998Registro de un cargo (395)
    • 27 nov 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene FIRST QUENCH RETAILING LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    29 oct 2009Inicio de la administración
    28 oct 2014Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Richard Dixon Fleming
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profesional
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Michael Vincent Mcloughlin
    Kpmg Llp
    Po Box 695
    EC4Y 8BB 8 Salisbury Square
    London
    Profesional
    Kpmg Llp
    Po Box 695
    EC4Y 8BB 8 Salisbury Square
    London
    Ian James Corfield
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Profesional
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profesional
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0