RAB 100 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaRAB 100 LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00043117
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de RAB 100 LIMITED?

    • (2513) /

    ¿Dónde se encuentra RAB 100 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Victoria Works
    Thrumpton Lane
    DN22 6HH Retford
    Nottinghamshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RAB 100 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ICON WARNE LIMITED05 oct 200005 oct 2000
    WILLIAM WARNE LIMITED31 dic 198031 dic 1980
    WILLIAM WARNE AND COMPANY,LIMITED23 ene 189523 ene 1895

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de RAB 100 LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 sept 2011
    Próximas cuentas vencen el30 jun 2012
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2010

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para RAB 100 LIMITED?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta01 jun 2017
    Próxima declaración de confirmación vence15 jun 2017
    Vencido

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para RAB 100 LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para RAB 100 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cese del nombramiento de Shaun Raymond Finn como secretario el 09 oct 2012

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Timothy Denzil Pryce como director el 09 oct 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Shaun Raymond Finn como director el 09 oct 2012

    1 páginasTM01

    Restauración por orden judicial

    3 páginasAC92

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed icon warne LIMITED\certificate issued on 23/02/12
    2 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name23 feb 2012

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 13 feb 2012

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 07 feb 2012

    • Capital: GBP 0.104060
    4 páginasSH19

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Share premium cancelled 06/02/2012
    RES13

    Cambio de datos del director Mr Timothy Denzil Pryce el 24 ago 2011

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2010

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Timothy Denzil Pryce el 31 may 2010

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2009

    7 páginasAA

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    1 páginas190

    legacy

    1 páginas353

    ¿Quiénes son los directivos de RAB 100 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    FINN, Shaun Raymond
    11 Nottingham Road
    Lowdham
    NG14 7AL Nottingham
    Secretario
    11 Nottingham Road
    Lowdham
    NG14 7AL Nottingham
    BritishFinance Director112482850001
    HARRIS, Mark Smeeth
    21 Oakdene
    Sunningdale
    SL5 0BU Ascot
    Berkshire
    Secretario
    21 Oakdene
    Sunningdale
    SL5 0BU Ascot
    Berkshire
    BritishAccountant104260670001
    RUFFLE, Anthony John Howard
    8 Hurstwood Drive
    BR1 2JF Bromley
    Kent
    Secretario
    8 Hurstwood Drive
    BR1 2JF Bromley
    Kent
    British10489270001
    SUNTER, Amanda Jane
    664 Rayleigh Road
    Hutton
    CM13 1SJ Brentwood
    Essex
    Secretario
    664 Rayleigh Road
    Hutton
    CM13 1SJ Brentwood
    Essex
    British44240520002
    ASHFORD, Leslie Ernest Thomas
    27 Beckenham Road
    BR4 0QR West Wickham
    Kent
    Director
    27 Beckenham Road
    BR4 0QR West Wickham
    Kent
    EnglandBritishChief Executive398670001
    ASHURST, Norman
    5 De Narde Road
    NR19 2HQ Dereham
    Norfolk
    Director
    5 De Narde Road
    NR19 2HQ Dereham
    Norfolk
    BritishDirector70931510001
    BARNES, Raymond
    27 Chestwood Close
    CM12 0PB Billericay
    Essex
    Director
    27 Chestwood Close
    CM12 0PB Billericay
    Essex
    BritishCompany Director10489290001
    CALLAN, Maurice Simon
    Ayres Cottage
    71 Bicester Road Long Crendon
    HP18 9EE Aylesbury
    Buckinghamshire
    Director
    Ayres Cottage
    71 Bicester Road Long Crendon
    HP18 9EE Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishOperations Director72172980001
    DORRELL, Michael John
    29 Onslow Gardens
    CM5 9BG Ongar
    Essex
    Director
    29 Onslow Gardens
    CM5 9BG Ongar
    Essex
    BritishCompany Director10489280001
    FINN, Shaun Raymond
    11 Nottingham Road
    Lowdham
    NG14 7AL Nottingham
    Director
    11 Nottingham Road
    Lowdham
    NG14 7AL Nottingham
    EnglandBritishFinance Director112482850001
    GOGERTY, Richard Howard
    Marriner Crescent
    LN2 1BB Lincoln
    2
    Lincolnshire
    Director
    Marriner Crescent
    LN2 1BB Lincoln
    2
    Lincolnshire
    EnglandBritishManaging Director83926860003
    HARPER, Peter Joseph
    Mayhall Lodge
    Oakway
    HP6 5PQ Amersham
    Buckinghamshire
    Director
    Mayhall Lodge
    Oakway
    HP6 5PQ Amersham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director133340001
    HARRIS, Mark Smeeth
    21 Oakdene
    Sunningdale
    SL5 0BU Ascot
    Berkshire
    Director
    21 Oakdene
    Sunningdale
    SL5 0BU Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritishAccountant104260670001
    HOOPER, Harry
    33 Leicester Close
    NN16 8EZ Kettering
    Northamptonshire
    Director
    33 Leicester Close
    NN16 8EZ Kettering
    Northamptonshire
    BritishDirector72172830001
    MURRAY, Keith Alexander
    4 Copperfield Orchard
    Kemsing
    TN15 6QH Sevenoaks
    Kent
    Director
    4 Copperfield Orchard
    Kemsing
    TN15 6QH Sevenoaks
    Kent
    BritishCompany Director10489300001
    PRYCE, Timothy Denzil
    Thrumpton Lane
    DN22 6HH Retford
    Victoria Works
    Nottinghamshire
    Director
    Thrumpton Lane
    DN22 6HH Retford
    Victoria Works
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishDirector139882140005
    RUFFLE, Anthony John Howard
    8 Hurstwood Drive
    BR1 2JF Bromley
    Kent
    Director
    8 Hurstwood Drive
    BR1 2JF Bromley
    Kent
    BritishCompany Director10489270001
    SLADE, Peter Andrew
    Mavis Cottage
    Forest Road, Binfield
    RG42 4DU Bracknell
    Berkshire
    Director
    Mavis Cottage
    Forest Road, Binfield
    RG42 4DU Bracknell
    Berkshire
    EnglandBritishDirector66030400002
    STEVENSON, Anthony Robert
    1 Glamis Gardens
    Longthorpe
    PE3 9PQ Peterborough
    Cambridgeshire
    Director
    1 Glamis Gardens
    Longthorpe
    PE3 9PQ Peterborough
    Cambridgeshire
    BritishCompany Director39591520001
    SUNTER, Amanda Jane
    664 Rayleigh Road
    Hutton
    CM13 1SJ Brentwood
    Essex
    Director
    664 Rayleigh Road
    Hutton
    CM13 1SJ Brentwood
    Essex
    BritishG Fin Director44240520002
    THOMAS, Christopher John
    Whateley House
    9 Wheatley Green Four Oaks
    B74 2RL Sutton Coldfield
    West Midlands
    Director
    Whateley House
    9 Wheatley Green Four Oaks
    B74 2RL Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritishChief Executive37235920002
    WILKINSON, Neil Freeman
    Larkswood Jordans Way
    Jordans
    HP9 2SP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    Larkswood Jordans Way
    Jordans
    HP9 2SP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChartered Accountant638810003

    ¿Tiene RAB 100 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creado el 24 dic 2004
    Entregado el 12 ene 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 12 ene 2005Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 24 dic 2004
    Entregado el 07 ene 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any loan note holder under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transacciones
    • 07 ene 2005Registro de un cargo (395)
    Omnibus letter of set-off
    Creado el 12 dic 2002
    Entregado el 19 dic 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum standing to the credit of an account,as defined,whether in sterling or any other currency and the debt from time to time owing by the bank represented by that sum and "credit balances"; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 19 dic 2002Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 12 dic 2002
    Entregado el 19 dic 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any loan note holder under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited (The Trustee)
    Transacciones
    • 19 dic 2002Registro de un cargo (395)
    • 05 ene 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 12 dic 2002
    Entregado el 19 dic 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 19 dic 2002Registro de un cargo (395)
    Debenture deed
    Creado el 11 sept 2001
    Entregado el 19 sept 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All money and liabilites whether actual or contingent which then were or at any time thereafter may be due owing or incurred by the company to the chargee and/or any new loan note holder pursuant to the new guarantee (all terms as defined)
    Breve descripción
    The property being land and buildings lying to the west of gascoigne road barking essex title number EGL320163. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited (The "Trustee")
    Transacciones
    • 19 sept 2001Registro de un cargo (395)
    • 12 jul 2002Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 05 ene 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture deed
    Creado el 20 jun 2000
    Entregado el 06 jul 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transacciones
    • 06 jul 2000Registro de un cargo (395)
    • 12 jul 2002Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 05 ene 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture deed
    Creado el 20 jun 2000
    Entregado el 06 jul 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 06 jul 2000Registro de un cargo (395)
    • 12 jul 2002Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 23 oct 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 28 sept 1999
    Entregado el 05 oct 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 05 oct 1999Registro de un cargo (395)
    • 18 jul 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 24 dic 1993
    Entregado el 14 ene 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever pursuant to the intercreditor agreement (as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Trustee for the Securedbeneficiaries(As Defined)
    Transacciones
    • 14 ene 1994Registro de un cargo (395)
    • 18 jul 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Floating charge
    Creado el 14 jun 1963
    Entregado el 25 jun 1963
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Schroder Executor & Trustee Compny Limited
    Transacciones
    • 25 jun 1963Registro de una carga
    • 10 dic 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0