EUROPEAN CELLARS LIMITED

EUROPEAN CELLARS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaEUROPEAN CELLARS LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00044627
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de EUROPEAN CELLARS LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra EUROPEAN CELLARS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    20 Montford Place
    Kennington
    SE11 5DE London
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de EUROPEAN CELLARS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GRANTS OF ST JAMES'S LIMITED04 mar 199104 mar 1991
    EUROPEAN CELLARS LIMITED.30 ago 198830 ago 1988
    GRANTS OF ST JAMES'S LIMITED16 jul 189516 jul 1895

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de EUROPEAN CELLARS LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 jun 2024
    Próximas cuentas vencen el31 mar 2025
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2023

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para EUROPEAN CELLARS LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta01 jun 2025
    Próxima declaración de confirmación vence15 jun 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta01 jun 2024
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para EUROPEAN CELLARS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2023

    1 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2022

    1 páginasAA

    Cambio de datos del director Edward Fells el 19 oct 2022

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Stuart Macnab como director el 31 mar 2022

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2021

    1 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2020

    1 páginasAA

    Cambio de datos del director Edward Fells el 07 dic 2020

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Edward Fells como director el 01 oct 2020

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Vincent Turpin como director el 30 sept 2020

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de Chivas House 72 Chancellors Road London W6 9RS a 20 Montford Place Kennington London SE11 5DE el 01 jul 2020

    1 páginasAD01

    Modification des détails de Allied Domecq Spirits & Wine Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 jul 2020

    3 páginasPSC05

    Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Modification des détails de Allied Domecq Spirits & Wine Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016

    2 páginasPSC05

    Cambio de datos del director Mr Stuart Macnab el 13 may 2020

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2019

    1 páginasAA

    Nombramiento de Stuart Andrew Ferrie Mckechnie como director el 11 dic 2019

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2018

    1 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2017

    1 páginasAA

    Nombramiento de Vincent Turpin como director el 01 sept 2017

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de EUROPEAN CELLARS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    FELLS, Edward
    Montford Place
    Kennington
    SE11 5DE London
    20
    England
    Director
    Montford Place
    Kennington
    SE11 5DE London
    20
    England
    United KingdomBritishChief Finance Officer274854930003
    MCKECHNIE, Stuart Andrew Ferrie
    Montford Place
    Kennington
    SE11 5DE London
    20
    England
    Director
    Montford Place
    Kennington
    SE11 5DE London
    20
    England
    ScotlandBritishChartered Accountant264144930001
    ARMSTRONG, Philippa
    162 Muller Road
    Horfield
    BS7 9QX Bristol
    Avon
    Secretario
    162 Muller Road
    Horfield
    BS7 9QX Bristol
    Avon
    British108400480001
    BROWN, Charles Bennett
    The Old Library
    High Street
    BS40 5QA Wrington Bristol
    Avon
    Secretario
    The Old Library
    High Street
    BS40 5QA Wrington Bristol
    Avon
    British107840600001
    EGAN, Jane
    11 Mccrorie Place
    PA10 2BF Kilbarchan
    Renfrewshire
    Secretario
    11 Mccrorie Place
    PA10 2BF Kilbarchan
    Renfrewshire
    British112277750001
    GILES, Nicholas David Martin
    Millbridge Cottage
    Redcliffe Street
    BS27 3ND Cheddar
    Somerset
    Secretario
    Millbridge Cottage
    Redcliffe Street
    BS27 3ND Cheddar
    Somerset
    British104193490001
    HUGHES, Sarah Helen
    85 Devonshire Road
    Westbury Park
    BS6 7NH Bristol
    Secretario
    85 Devonshire Road
    Westbury Park
    BS6 7NH Bristol
    British90664870001
    MACNAB, Stuart
    6 Station Rise
    PA12 4NA Lochwinnoch
    Renfrewshire
    Secretario
    6 Station Rise
    PA12 4NA Lochwinnoch
    Renfrewshire
    British77024740001
    MAINS, Thomas Gordon
    The Meadows
    Duck Lane
    BA5 1EZ Westbury-Sub-Mendip
    Somerset
    Secretario
    The Meadows
    Duck Lane
    BA5 1EZ Westbury-Sub-Mendip
    Somerset
    BritishCompany Secretary46135720001
    MAINS, Thomas Gordon
    The Meadows
    Duck Lane
    BA5 1EZ Westbury-Sub-Mendip
    Somerset
    Secretario
    The Meadows
    Duck Lane
    BA5 1EZ Westbury-Sub-Mendip
    Somerset
    BritishCompany Secretary46135720001
    TOMLINSON, John Michael
    11 Selwood Crescent
    BA11 2HX Frome
    Somerset
    Secretario
    11 Selwood Crescent
    BA11 2HX Frome
    Somerset
    British1356620001
    WOOTERS, Joseph Michael
    Denny House Knowle Hill Farm
    Knowle Hill Chew Magna
    BS18 8TE Bristol
    Avon
    Secretario
    Denny House Knowle Hill Farm
    Knowle Hill Chew Magna
    BS18 8TE Bristol
    Avon
    American40396870001
    ARTIS, Iain Norris James
    Urchinwood Manor Cottage
    Wrington Road, Congresbury
    BS19 5AR Bristol
    Avon
    Director
    Urchinwood Manor Cottage
    Wrington Road, Congresbury
    BS19 5AR Bristol
    Avon
    BritishCompany Director46141510003
    BENNETT, Michael Peter
    45 Drakes Way
    Portishead
    BS20 6LD Bristol
    Director
    45 Drakes Way
    Portishead
    BS20 6LD Bristol
    EnglandBritishFinancial Accountant86546430001
    BROWN, Charles Bennett
    The Old Library
    High Street
    BS40 5QA Wrington Bristol
    Avon
    Director
    The Old Library
    High Street
    BS40 5QA Wrington Bristol
    Avon
    BritishChartered Secretary107840600001
    BURRELL, Peter Martin
    Orchard House 42 The Crescent
    Brinklow
    CV23 0LR Rugby
    Warwickshire
    Director
    Orchard House 42 The Crescent
    Brinklow
    CV23 0LR Rugby
    Warwickshire
    BritishChartered Accountant1970490001
    DANE, Michael Glyn
    Abbots Holt Cottage
    Tilford Road
    GU10 2DE Farnham
    Surrey
    Director
    Abbots Holt Cottage
    Tilford Road
    GU10 2DE Farnham
    Surrey
    United KingdomBritishDirector80692650001
    FETTER, Herve Denis Michel
    Spear Mews
    SW5 9NA London
    6
    Director
    Spear Mews
    SW5 9NA London
    6
    EnglandFrenchFinance Director133848930001
    FITZSIMONS, Ian Terence
    5 Rue Gounod,
    75017
    Paris
    Director
    5 Rue Gounod,
    75017
    Paris
    BritishGeneral Counsel116030190001
    HETHERINGTON, Graham Charles
    Badgers Acre
    Stone Allerton
    BS26 2NW Axbridge
    Somerset
    Director
    Badgers Acre
    Stone Allerton
    BS26 2NW Axbridge
    Somerset
    BritishDirector49219850001
    HETHERINGTON, Graham Charles
    Badgers Acre
    Stone Allerton
    BS26 2NW Axbridge
    Somerset
    Director
    Badgers Acre
    Stone Allerton
    BS26 2NW Axbridge
    Somerset
    BritishAccountant49219850001
    KELLEY, Russell Phelps
    206 Sussex Mansions
    71-77 Old Brompton Road
    SW7 3JZ London
    Director
    206 Sussex Mansions
    71-77 Old Brompton Road
    SW7 3JZ London
    United StatesGeneral Counsel & Company Secr68327770001
    LYSTER, Peter John
    Arch Barn
    Quarry Springs Goathurst
    TA5 2DH Bridgwater
    Somerset
    Director
    Arch Barn
    Quarry Springs Goathurst
    TA5 2DH Bridgwater
    Somerset
    EnglandBritishDirector34011420003
    MACNAB, Stuart
    Montford Place
    Kennington
    SE11 5DE London
    20
    England
    Director
    Montford Place
    Kennington
    SE11 5DE London
    20
    England
    United KingdomBritishAccountant77024740001
    MAINS, Thomas Gordon
    The Meadows
    Duck Lane
    BA5 1EZ Westbury-Sub-Mendip
    Somerset
    Director
    The Meadows
    Duck Lane
    BA5 1EZ Westbury-Sub-Mendip
    Somerset
    United KingdomBritishChartered Secretary46135720001
    MITCHELL, David Smith
    16 Walpole Gardens
    TW2 5SJ Twickenham
    Middlesex
    Director
    16 Walpole Gardens
    TW2 5SJ Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Secretary1970560001
    QUARANTO, Leonard Anthony
    Glebe House
    Naunton
    GL54 3AT Cheltenham
    Director
    Glebe House
    Naunton
    GL54 3AT Cheltenham
    AmericanGeneral Counsel & Company Secr77989690001
    ROSEWELL, Peter William
    Ridgeway House
    Penn Lane Hardington Mandeville
    BA22 9PQ Yeovil
    Somerset
    Director
    Ridgeway House
    Penn Lane Hardington Mandeville
    BA22 9PQ Yeovil
    Somerset
    BritishDirector34582580001
    SCHOFIELD, Anthony
    Lomond House
    9 Zetland Place
    EH5 3HU Edinburgh
    Director
    Lomond House
    9 Zetland Place
    EH5 3HU Edinburgh
    United KingdomBritishFinance Director53680030002
    SCOTLAND, David
    Lerburn House
    BS28 4EB Wedmore
    Somerset
    Director
    Lerburn House
    BS28 4EB Wedmore
    Somerset
    BritishDirector58674560001
    SMITH, Graham Hammond
    The Granary
    Station Road Wellow
    BA2 8QB Bath
    Avon
    Director
    The Granary
    Station Road Wellow
    BA2 8QB Bath
    Avon
    BritishCompany Director36016160001
    TOMLINSON, John Michael
    11 Selwood Crescent
    BA11 2HX Frome
    Somerset
    Director
    11 Selwood Crescent
    BA11 2HX Frome
    Somerset
    BritishChartered Secretary1356620001
    TURPIN, Vincent
    Montford Place
    Kennington
    SE11 5DE London
    20
    England
    Director
    Montford Place
    Kennington
    SE11 5DE London
    20
    England
    EnglandFrenchChief Financial Officer237432170001
    WOOD, Peter Adrian Kinnear
    Aller House
    Chapel Allerton
    BS26 2AD Axbridge
    Somerset
    Director
    Aller House
    Chapel Allerton
    BS26 2AD Axbridge
    Somerset
    BritishDirector43170740001
    WOOTERS, Joseph Michael
    Denny House Knowle Hill Farm
    Knowle Hill Chew Magna
    BS18 8TE Bristol
    Avon
    Director
    Denny House Knowle Hill Farm
    Knowle Hill Chew Magna
    BS18 8TE Bristol
    Avon
    AmericanDirector40378020001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de EUROPEAN CELLARS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Montford Place
    Kennington
    SE11 5DE London
    20
    England
    06 abr 2016
    Montford Place
    Kennington
    SE11 5DE London
    20
    England
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro00703977
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene EUROPEAN CELLARS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Supplemental trust deed
    Creado el 23 nov 1983
    Entregado el 25 nov 1983
    Satisfecho
    Cantidad garantizada
    £75,000,000 11 3/4 debenture stock 2009 of allied lyons PLC.
    Breve descripción
    Undertaking and all assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Corporation PLC.
    • Drayton Premier Investment Trust PLC
    Transacciones
    • 25 nov 1983Registro de una carga
    Equitable charge without instrument
    Creado el 22 jun 1983
    Entregado el 13 jul 1983
    Satisfecho
    Cantidad garantizada
    £7,500,000 debenture stock of allied lyons PLC
    Breve descripción
    Floating charge on the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Corporation Plcas Trustees
    • Drayton Premier Investment Trust PLC
    Transacciones
    • 13 jul 1983Registro de una carga
    Trust deed.
    Creado el 15 mar 1978
    Entregado el 30 mar 1978
    Satisfecho
    Cantidad garantizada
    Debenture stock of allied breweries limited amounting to £1,352,930 created under the terms of a trust deed dated 6TH june 1962 & supplemental thereto.
    Breve descripción
    Floating charge on undertaking and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Corporation, Limited
    • Drayton Premier Investment Trust Limited
    Transacciones
    • 30 mar 1978Registro de una carga
    Trust deed
    Creado el 04 abr 1972
    Entregado el 17 abr 1972
    Satisfecho
    Cantidad garantizada
    Debenture stock of allied breweries limited amounting to £100,000
    Breve descripción
    Floating charge on undertaking and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Corporation Limited
    • The Premier Investment Company Limited
    Transacciones
    • 17 abr 1972Registro de una carga
    Trust deed
    Creado el 11 mar 1968
    Entregado el 25 mar 1968
    Satisfecho
    Cantidad garantizada
    Debenture stock of allied breweries limited amounting to £12,000,000
    Breve descripción
    Floating charge on undertaking and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Corporation Limited
    • The Premier Investment Company Limited
    Transacciones
    • 25 mar 1968Registro de una carga
    Trust deed
    Creado el 25 ago 1965
    Entregado el 07 sept 1965
    Satisfecho
    Cantidad garantizada
    Debenture stock of allied breweries limited amounting to £1,000,000
    Breve descripción
    Floating charge on undertaking and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • The Premier Investment Company Limited
    • The Law Debenture Corporation Limited
    Transacciones
    • 07 sept 1965Registro de una carga
    Trust deed
    Creado el 16 jun 1965
    Entregado el 17 jun 1965
    Satisfecho
    Cantidad garantizada
    Debenture stock of allied breweries limited amounting to £2,000,000
    Breve descripción
    Floating charge on undertaking and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Corporation Limited
    • The Premier Investment Company Limited
    Transacciones
    • 17 jun 1965Registro de una carga
    Trust deed
    Creado el 14 ago 1964
    Entregado el 18 ago 1964
    Satisfecho
    Cantidad garantizada
    Debenture stock of allied breweries limited amouting to £10,000,000
    Breve descripción
    Floating charge on undertaking and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • The Premier Investment Company Limited
    • The Law Debenture Corporation Limited
    Transacciones
    • 18 ago 1964Registro de una carga
    Trust deed
    Creado el 14 ago 1964
    Entregado el 18 ago 1964
    Satisfecho
    Cantidad garantizada
    Debenture stock of allied breweries limited amounting to £2,623,369
    Breve descripción
    Floating charge on undertaking and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • The Premier Investment Company Limited
    • The Law Debenture Corporation Limited
    Transacciones
    • 18 ago 1964Registro de una carga
    Trust deed
    Creado el 19 feb 1964
    Entregado el 21 feb 1964
    Satisfecho
    Cantidad garantizada
    Debenture stock of allied breweries limited amounting to £10,342,599
    Breve descripción
    Floating charge on undertaking and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Corporation Limited
    • The Premier Investment Company Limited
    Transacciones
    • 21 feb 1964Registro de una carga
    Trust deed
    Creado el 18 ene 1963
    Entregado el 24 ene 1963
    Satisfecho
    Cantidad garantizada
    Further securing debenture stock amounting to £5,000,000 of ind coope tetley ansell limited.
    Breve descripción
    Floating charge on undertaking and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Corporation Limited
    • The Premier Investment Company Limited
    Transacciones
    • 24 ene 1963Registro de una carga
    Trust deed
    Creado el 29 ago 1962
    Entregado el 03 sept 1962
    Satisfecho
    Cantidad garantizada
    Further securing £840,035 debenture stock of ind coope tetley ansell limited
    Breve descripción
    Floating charge on undertaking and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Corporation Limited
    • The Premier Investment Company Limited
    Transacciones
    • 03 sept 1962Registro de una carga
    Trust deed
    Creado el 29 ago 1962
    Entregado el 03 sept 1962
    Satisfecho
    Cantidad garantizada
    Further securing £7,854,882 debenture stock of ind coope tetley ansell limited
    Breve descripción
    Floating charge on undertaking and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Cooperation Limited
    • The Premier Investment Company Limited
    Transacciones
    • 03 sept 1962Registro de una carga
    Trust deed
    Creado el 06 jun 1962
    Entregado el 07 jun 1962
    Satisfecho
    Cantidad garantizada
    Further securing debenture stock amounting to £15,347,651 of ind coope tetley ansell limited.
    Breve descripción
    Floating charge on undertaking and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • The Premier Investment Company Limited.
    Transacciones
    • 07 jun 1962Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0