EUROPEAN CELLARS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | EUROPEAN CELLARS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 00044627 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de EUROPEAN CELLARS LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra EUROPEAN CELLARS LIMITED?
Dirección de la sede social | 20 Montford Place Kennington SE11 5DE London England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de EUROPEAN CELLARS LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
GRANTS OF ST JAMES'S LIMITED | 04 mar 1991 | 04 mar 1991 |
EUROPEAN CELLARS LIMITED. | 30 ago 1988 | 30 ago 1988 |
GRANTS OF ST JAMES'S LIMITED | 16 jul 1895 | 16 jul 1895 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de EUROPEAN CELLARS LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 30 jun 2024 |
Próximas cuentas vencen el | 31 mar 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para EUROPEAN CELLARS LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 01 jun 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 15 jun 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 01 jun 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para EUROPEAN CELLARS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2023 | 1 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2022 | 1 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Edward Fells el 19 oct 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Stuart Macnab como director el 31 mar 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2021 | 1 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2020 | 1 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Edward Fells el 07 dic 2020 | 2 páginas | CH01 | ||
Nombramiento de Edward Fells como director el 01 oct 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Vincent Turpin como director el 30 sept 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Chivas House 72 Chancellors Road London W6 9RS a 20 Montford Place Kennington London SE11 5DE el 01 jul 2020 | 1 páginas | AD01 | ||
Modification des détails de Allied Domecq Spirits & Wine Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 jul 2020 | 3 páginas | PSC05 | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Modification des détails de Allied Domecq Spirits & Wine Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC05 | ||
Cambio de datos del director Mr Stuart Macnab el 13 may 2020 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2019 | 1 páginas | AA | ||
Nombramiento de Stuart Andrew Ferrie Mckechnie como director el 11 dic 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2018 | 1 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2017 | 1 páginas | AA | ||
Nombramiento de Vincent Turpin como director el 01 sept 2017 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de EUROPEAN CELLARS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELLS, Edward | Director | Montford Place Kennington SE11 5DE London 20 England | United Kingdom | British | Chief Finance Officer | 274854930003 | ||||
MCKECHNIE, Stuart Andrew Ferrie | Director | Montford Place Kennington SE11 5DE London 20 England | Scotland | British | Chartered Accountant | 264144930001 | ||||
ARMSTRONG, Philippa | Secretario | 162 Muller Road Horfield BS7 9QX Bristol Avon | British | 108400480001 | ||||||
BROWN, Charles Bennett | Secretario | The Old Library High Street BS40 5QA Wrington Bristol Avon | British | 107840600001 | ||||||
EGAN, Jane | Secretario | 11 Mccrorie Place PA10 2BF Kilbarchan Renfrewshire | British | 112277750001 | ||||||
GILES, Nicholas David Martin | Secretario | Millbridge Cottage Redcliffe Street BS27 3ND Cheddar Somerset | British | 104193490001 | ||||||
HUGHES, Sarah Helen | Secretario | 85 Devonshire Road Westbury Park BS6 7NH Bristol | British | 90664870001 | ||||||
MACNAB, Stuart | Secretario | 6 Station Rise PA12 4NA Lochwinnoch Renfrewshire | British | 77024740001 | ||||||
MAINS, Thomas Gordon | Secretario | The Meadows Duck Lane BA5 1EZ Westbury-Sub-Mendip Somerset | British | Company Secretary | 46135720001 | |||||
MAINS, Thomas Gordon | Secretario | The Meadows Duck Lane BA5 1EZ Westbury-Sub-Mendip Somerset | British | Company Secretary | 46135720001 | |||||
TOMLINSON, John Michael | Secretario | 11 Selwood Crescent BA11 2HX Frome Somerset | British | 1356620001 | ||||||
WOOTERS, Joseph Michael | Secretario | Denny House Knowle Hill Farm Knowle Hill Chew Magna BS18 8TE Bristol Avon | American | 40396870001 | ||||||
ARTIS, Iain Norris James | Director | Urchinwood Manor Cottage Wrington Road, Congresbury BS19 5AR Bristol Avon | British | Company Director | 46141510003 | |||||
BENNETT, Michael Peter | Director | 45 Drakes Way Portishead BS20 6LD Bristol | England | British | Financial Accountant | 86546430001 | ||||
BROWN, Charles Bennett | Director | The Old Library High Street BS40 5QA Wrington Bristol Avon | British | Chartered Secretary | 107840600001 | |||||
BURRELL, Peter Martin | Director | Orchard House 42 The Crescent Brinklow CV23 0LR Rugby Warwickshire | British | Chartered Accountant | 1970490001 | |||||
DANE, Michael Glyn | Director | Abbots Holt Cottage Tilford Road GU10 2DE Farnham Surrey | United Kingdom | British | Director | 80692650001 | ||||
FETTER, Herve Denis Michel | Director | Spear Mews SW5 9NA London 6 | England | French | Finance Director | 133848930001 | ||||
FITZSIMONS, Ian Terence | Director | 5 Rue Gounod, 75017 Paris | British | General Counsel | 116030190001 | |||||
HETHERINGTON, Graham Charles | Director | Badgers Acre Stone Allerton BS26 2NW Axbridge Somerset | British | Director | 49219850001 | |||||
HETHERINGTON, Graham Charles | Director | Badgers Acre Stone Allerton BS26 2NW Axbridge Somerset | British | Accountant | 49219850001 | |||||
KELLEY, Russell Phelps | Director | 206 Sussex Mansions 71-77 Old Brompton Road SW7 3JZ London | United States | General Counsel & Company Secr | 68327770001 | |||||
LYSTER, Peter John | Director | Arch Barn Quarry Springs Goathurst TA5 2DH Bridgwater Somerset | England | British | Director | 34011420003 | ||||
MACNAB, Stuart | Director | Montford Place Kennington SE11 5DE London 20 England | United Kingdom | British | Accountant | 77024740001 | ||||
MAINS, Thomas Gordon | Director | The Meadows Duck Lane BA5 1EZ Westbury-Sub-Mendip Somerset | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 46135720001 | ||||
MITCHELL, David Smith | Director | 16 Walpole Gardens TW2 5SJ Twickenham Middlesex | United Kingdom | British | Company Secretary | 1970560001 | ||||
QUARANTO, Leonard Anthony | Director | Glebe House Naunton GL54 3AT Cheltenham | American | General Counsel & Company Secr | 77989690001 | |||||
ROSEWELL, Peter William | Director | Ridgeway House Penn Lane Hardington Mandeville BA22 9PQ Yeovil Somerset | British | Director | 34582580001 | |||||
SCHOFIELD, Anthony | Director | Lomond House 9 Zetland Place EH5 3HU Edinburgh | United Kingdom | British | Finance Director | 53680030002 | ||||
SCOTLAND, David | Director | Lerburn House BS28 4EB Wedmore Somerset | British | Director | 58674560001 | |||||
SMITH, Graham Hammond | Director | The Granary Station Road Wellow BA2 8QB Bath Avon | British | Company Director | 36016160001 | |||||
TOMLINSON, John Michael | Director | 11 Selwood Crescent BA11 2HX Frome Somerset | British | Chartered Secretary | 1356620001 | |||||
TURPIN, Vincent | Director | Montford Place Kennington SE11 5DE London 20 England | England | French | Chief Financial Officer | 237432170001 | ||||
WOOD, Peter Adrian Kinnear | Director | Aller House Chapel Allerton BS26 2AD Axbridge Somerset | British | Director | 43170740001 | |||||
WOOTERS, Joseph Michael | Director | Denny House Knowle Hill Farm Knowle Hill Chew Magna BS18 8TE Bristol Avon | American | Director | 40378020001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de EUROPEAN CELLARS LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allied Domecq Spirits & Wine Limited | 06 abr 2016 | Montford Place Kennington SE11 5DE London 20 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene EUROPEAN CELLARS LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Supplemental trust deed | Creado el 23 nov 1983 Entregado el 25 nov 1983 | Satisfecho | Cantidad garantizada £75,000,000 11 3/4 debenture stock 2009 of allied lyons PLC. | |
Breve descripción Undertaking and all assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Equitable charge without instrument | Creado el 22 jun 1983 Entregado el 13 jul 1983 | Satisfecho | Cantidad garantizada £7,500,000 debenture stock of allied lyons PLC | |
Breve descripción Floating charge on the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Trust deed. | Creado el 15 mar 1978 Entregado el 30 mar 1978 | Satisfecho | Cantidad garantizada Debenture stock of allied breweries limited amounting to £1,352,930 created under the terms of a trust deed dated 6TH june 1962 & supplemental thereto. | |
Breve descripción Floating charge on undertaking and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Trust deed | Creado el 04 abr 1972 Entregado el 17 abr 1972 | Satisfecho | Cantidad garantizada Debenture stock of allied breweries limited amounting to £100,000 | |
Breve descripción Floating charge on undertaking and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Trust deed | Creado el 11 mar 1968 Entregado el 25 mar 1968 | Satisfecho | Cantidad garantizada Debenture stock of allied breweries limited amounting to £12,000,000 | |
Breve descripción Floating charge on undertaking and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Trust deed | Creado el 25 ago 1965 Entregado el 07 sept 1965 | Satisfecho | Cantidad garantizada Debenture stock of allied breweries limited amounting to £1,000,000 | |
Breve descripción Floating charge on undertaking and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Trust deed | Creado el 16 jun 1965 Entregado el 17 jun 1965 | Satisfecho | Cantidad garantizada Debenture stock of allied breweries limited amounting to £2,000,000 | |
Breve descripción Floating charge on undertaking and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Trust deed | Creado el 14 ago 1964 Entregado el 18 ago 1964 | Satisfecho | Cantidad garantizada Debenture stock of allied breweries limited amouting to £10,000,000 | |
Breve descripción Floating charge on undertaking and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Trust deed | Creado el 14 ago 1964 Entregado el 18 ago 1964 | Satisfecho | Cantidad garantizada Debenture stock of allied breweries limited amounting to £2,623,369 | |
Breve descripción Floating charge on undertaking and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Trust deed | Creado el 19 feb 1964 Entregado el 21 feb 1964 | Satisfecho | Cantidad garantizada Debenture stock of allied breweries limited amounting to £10,342,599 | |
Breve descripción Floating charge on undertaking and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Trust deed | Creado el 18 ene 1963 Entregado el 24 ene 1963 | Satisfecho | Cantidad garantizada Further securing debenture stock amounting to £5,000,000 of ind coope tetley ansell limited. | |
Breve descripción Floating charge on undertaking and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Trust deed | Creado el 29 ago 1962 Entregado el 03 sept 1962 | Satisfecho | Cantidad garantizada Further securing £840,035 debenture stock of ind coope tetley ansell limited | |
Breve descripción Floating charge on undertaking and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Trust deed | Creado el 29 ago 1962 Entregado el 03 sept 1962 | Satisfecho | Cantidad garantizada Further securing £7,854,882 debenture stock of ind coope tetley ansell limited | |
Breve descripción Floating charge on undertaking and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Trust deed | Creado el 06 jun 1962 Entregado el 07 jun 1962 | Satisfecho | Cantidad garantizada Further securing debenture stock amounting to £15,347,651 of ind coope tetley ansell limited. | |
Breve descripción Floating charge on undertaking and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0