ROADWAYS CONTAINER LOGISTICS LIMITED

ROADWAYS CONTAINER LOGISTICS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaROADWAYS CONTAINER LOGISTICS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00046913
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ROADWAYS CONTAINER LOGISTICS LIMITED?

    • Transporte de mercancías por carretera (49410) / Transporte y almacenamiento

    ¿Dónde se encuentra ROADWAYS CONTAINER LOGISTICS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Begbies Traynor (Central) Llp Town Wall House
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Essex
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ROADWAYS CONTAINER LOGISTICS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    P&O ROADWAYS LIMITED18 abr 199218 abr 1992
    P & O DISTRIBUTION LIMITED01 ene 199001 ene 1990
    BUTLER'S WAREHOUSING & DISTRIBUTION LIMITED20 feb 189620 feb 1896

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ROADWAYS CONTAINER LOGISTICS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta27 jun 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ROADWAYS CONTAINER LOGISTICS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    13 páginasLIQ13

    Domicilio social registrado cambiado de Maritime House Clickett Hill Road Felixstowe Suffolk IP11 4AX a Begbies Traynor (Central) Llp Town Wall House Balkerne Hill Colchester Essex CO3 3AD el 10 jul 2021

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 23 jun 2021

    LRESSP

    Cancelación total de la carga 000469130008

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 000469130009

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 000469130010

    1 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 17 jul 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Registro de la carga 000469130010, creada el 06 jul 2020

    24 páginasMR01

    Registro de la carga 000469130009, creada el 06 jul 2020

    16 páginasMR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 27 jun 2019

    5 páginasAA

    Cancelación total de la carga 000469130005

    1 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 17 jul 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 000469130006

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 000469130007

    1 páginasMR04

    Registro de la carga 000469130008, creada el 29 may 2019

    23 páginasMR01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 27 jun 2018

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 17 jul 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 27 jun 2017

    4 páginasAA

    Estado de capital el 16 ene 2018

    • Capital: GBP 1.00
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    ¿Quiénes son los directivos de ROADWAYS CONTAINER LOGISTICS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MCNICOL, Alan
    Clickett Hill Road
    IP11 4AX Felixstowe
    Maritime House
    Suffolk
    England
    Secretario
    Clickett Hill Road
    IP11 4AX Felixstowe
    Maritime House
    Suffolk
    England
    190446290001
    WILLIAMS, John Howard
    Town Wall House
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Begbies Traynor (Central) Llp
    Essex
    Director
    Town Wall House
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Begbies Traynor (Central) Llp
    Essex
    United KingdomBritishDirector78365030002
    CHEESEMAN, Guy Robert
    60 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JP London
    Secretario
    60 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JP London
    British7865940001
    FOWLE, David John
    320 New North Road
    IG6 3ES Ilford
    Capital Gate
    Essex
    Secretario
    320 New North Road
    IG6 3ES Ilford
    Capital Gate
    Essex
    BritishChartered Accountant93860420001
    KILBY, John, Mr.
    2a Raynham Way
    LU2 9SH Luton
    Bedfordshire
    Secretario
    2a Raynham Way
    LU2 9SH Luton
    Bedfordshire
    British76247880001
    SMITH, Colin Greenough
    2 The Cove
    Hale
    WA15 8RZ Altrincham
    Cheshire
    Secretario
    2 The Cove
    Hale
    WA15 8RZ Altrincham
    Cheshire
    British38361850002
    ZIMMER, Kaarina Ann
    Riowstraat 43
    2585 Gs
    The Hague
    Netherlands
    Secretario
    Riowstraat 43
    2585 Gs
    The Hague
    Netherlands
    British104894830001
    BLACKMORE, John Terence
    22 Ashley Meadows
    SO51 7LT Romsey
    Hampshire
    Director
    22 Ashley Meadows
    SO51 7LT Romsey
    Hampshire
    BritishManager708780001
    CARMICHAEL, Ian James
    36 Balmoral Close
    WS14 9SP Lichfield
    Staffordshire
    Director
    36 Balmoral Close
    WS14 9SP Lichfield
    Staffordshire
    BritishGeneral Manager34799640001
    CHENERY, David Richard Alan
    4 Hangmans Lane
    AL6 0TJ Welwyn
    Hertfordshire
    Director
    4 Hangmans Lane
    AL6 0TJ Welwyn
    Hertfordshire
    EnglandBritishAccountant57754090002
    CLARKE, Graeme Ingram
    103 Barnstaple Road
    SS1 3PN Thorpe Bay
    Essex
    Director
    103 Barnstaple Road
    SS1 3PN Thorpe Bay
    Essex
    BritishShipping Executive92667540001
    COLLINS, Allan
    47 Tabors Avenue
    Great Baddow
    CM2 7EJ Chelmsford
    Essex
    Director
    47 Tabors Avenue
    Great Baddow
    CM2 7EJ Chelmsford
    Essex
    BritishChartered Accountant46168870001
    CURTIS, Paul David
    Hawarden 80 Main Road
    Danbury
    CM3 4DH Chelmsford
    Essex
    Director
    Hawarden 80 Main Road
    Danbury
    CM3 4DH Chelmsford
    Essex
    BritishGeneral Manager46168730001
    FALCON, Thomas William
    Plumpton Farm
    Hinxhill
    TN25 5NT Ashford
    Kent
    Director
    Plumpton Farm
    Hinxhill
    TN25 5NT Ashford
    Kent
    UkBritishOperations Manager105534120001
    FOWLE, David John
    320 New North Road
    IG6 3ES Ilford
    Capital Gate
    Essex
    Director
    320 New North Road
    IG6 3ES Ilford
    Capital Gate
    Essex
    EnglandBritishChartered Accountant93860420001
    FOWLE, David John
    10 The Heythrop
    CM4 9HG Ingatestone
    Essex
    Director
    10 The Heythrop
    CM4 9HG Ingatestone
    Essex
    EnglandBritishChartered Accountant93860420001
    FROST, Andrew
    320 New North Road
    IG6 3ES Ilford
    Capital Gate
    Essex
    Director
    320 New North Road
    IG6 3ES Ilford
    Capital Gate
    Essex
    EnglandBritishOperations Director98438290001
    GREGORY, Robert Benedict
    320 New North Road
    IG6 3ES Ilford
    Capital Gate
    Essex
    Director
    320 New North Road
    IG6 3ES Ilford
    Capital Gate
    Essex
    EnglandBritishDirector53006640001
    GUTHRIE, Robert Macgregor
    12 Tor Bryan
    CM4 9HJ Ingatestone
    Essex
    Director
    12 Tor Bryan
    CM4 9HJ Ingatestone
    Essex
    BritishDirector708760001
    HOOPER, John Kenneth
    Stone Cottage
    Old Haverhill Road
    CB9 7UG Little Wratting
    Suffolk
    Director
    Stone Cottage
    Old Haverhill Road
    CB9 7UG Little Wratting
    Suffolk
    BritishSales Manager28451230002
    KINGSBURY, Clare
    Cartref
    Croydon Road
    TN16 1TX Westerham
    Kent
    Director
    Cartref
    Croydon Road
    TN16 1TX Westerham
    Kent
    BritishDirector62948050001
    KINGSTON, Michael John
    8 Hoppers Way
    TN23 4GP Ashford
    Kent
    Director
    8 Hoppers Way
    TN23 4GP Ashford
    Kent
    UkBritishFinance Director83677410001
    KJAEDEGAARD, Jesper
    37 New Road
    KT10 9NU Esher
    Surrey
    Director
    37 New Road
    KT10 9NU Esher
    Surrey
    Great BritainDanishChief Executive Officer106348200004
    KNIGHT, Raymond Antony
    Furzewood Barden Road
    Speldhurst
    TN3 0LE Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    Furzewood Barden Road
    Speldhurst
    TN3 0LE Tunbridge Wells
    Kent
    BritishDirector2198910001
    LAWRENSON, Christopher
    107 Faulkeners Way
    Trimley St Mary
    IP11 0FF Felixstowe
    Suffolk
    Director
    107 Faulkeners Way
    Trimley St Mary
    IP11 0FF Felixstowe
    Suffolk
    United KingdomBritishCompany Director118002810001
    MATTHEWS, Nicholas
    320 New North Road
    IG6 3ES Ilford
    Capital Gate
    Essex
    Director
    320 New North Road
    IG6 3ES Ilford
    Capital Gate
    Essex
    EnglandBritishOperations Director135427510002
    MCNEIL, John
    4 Holmes Court
    Locking Stumps
    WA3 7MH Warrington
    Cheshire
    Director
    4 Holmes Court
    Locking Stumps
    WA3 7MH Warrington
    Cheshire
    BritishRoad Haulier802030001
    MCNICOL, Alan
    New North Road
    IG6 3ES Ilford
    Capital Gate
    Essex
    England
    Director
    New North Road
    IG6 3ES Ilford
    Capital Gate
    Essex
    England
    EnglandBritishFinancial Director81163340003
    NIELSEN, Jens Holger
    12 Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    Director
    12 Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    DanishManaging Director83281860001
    O'BRIEN, Bernadette Mary
    10 Stormont Road
    Highgate
    N6 4NL London
    Director
    10 Stormont Road
    Highgate
    N6 4NL London
    EnglandIrishDirector95129740001
    PACKER, Andrew Mark
    Astley House Bishopscourt Gardens
    Springfield
    CM2 6AZ Chelmsford
    Essex
    Director
    Astley House Bishopscourt Gardens
    Springfield
    CM2 6AZ Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritishTransport Executive19720530001
    PARKER, Christopher John
    320 New North Road
    IG6 3ES Ilford
    Capital Gate
    Essex
    Director
    320 New North Road
    IG6 3ES Ilford
    Capital Gate
    Essex
    United KingdomBritishDirector91475230002
    PATON, James Hendry
    Brook House 9 Ladythorn Crescent
    Bramhall
    SK7 2HB Stockport
    Cheshire
    Director
    Brook House 9 Ladythorn Crescent
    Bramhall
    SK7 2HB Stockport
    Cheshire
    BritishTransport Executive10210030001
    PUSEY, Nigel Simon
    Roslyns
    Water Lane
    CB9 7AL Helions Bumpstead
    Suffolk
    Director
    Roslyns
    Water Lane
    CB9 7AL Helions Bumpstead
    Suffolk
    BritishDirector83149350005
    REVOIR, Peter Joseph
    26 Brodie Road
    Chingford
    E4 7HF London
    Director
    26 Brodie Road
    Chingford
    E4 7HF London
    BritishTransport Executive41499410001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ROADWAYS CONTAINER LOGISTICS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mr John Howard Williams
    Town Wall House
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Begbies Traynor (Central) Llp
    Essex
    22 jul 2016
    Town Wall House
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Begbies Traynor (Central) Llp
    Essex
    No
    Nacionalidad: British
    País de residencia: England
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Tiene ROADWAYS CONTAINER LOGISTICS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 06 jul 2020
    Entregado el 10 jul 2020
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    A fixed and floating charge over all assets.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 10 jul 2020Registro de una carga (MR01)
    • 22 jun 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 06 jul 2020
    Entregado el 09 jul 2020
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    The leasehold property known as birmingham intermodal freight terminal 27 acres at birch coppice business park watling street dordon tamworth registered at hm land registry with title number WK420996.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Hsbc UK Bank PLC
    Transacciones
    • 09 jul 2020Registro de una carga (MR01)
    • 22 jun 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 29 may 2019
    Entregado el 30 may 2019
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    A fixed and floating charge over all assets.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Hsbc UK Bank PLC
    Transacciones
    • 30 may 2019Registro de una carga (MR01)
    • 22 jun 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 06 oct 2014
    Entregado el 07 oct 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 07 oct 2014Registro de una carga (MR01)
    • 04 jun 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 08 ago 2014
    Entregado el 11 ago 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    The company with full title guarantee hereby charges with the payment of all money and liabilities and other sums hereby agreed to be paid by the company to the bank and all other money and liabilities expressed to be secured hereby (including without limitation, any expenses and charges arising out of or in connection with the acts or matters referred to in clauses 10,13, 14,18 and 23) and all other obligations and liabilities of the company under this debenture and so that the charges hereby created shall be a continuing security:. 1. the freehold and leasehold property of the company both present and future in the schedule and all buildings, fixtures of the company in or over land of whatever description both present and future;. 2. the intellectual property rights; and. 3. the undertaking and all property and assets of the company both present and future including heritable property and all other property and assets in scotland.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 11 ago 2014Registro de una carga (MR01)
    • 04 jun 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 08 ago 2014
    Entregado el 11 ago 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    As continuing security for the payment and/or discharge of all monies, obligations and liabilities which are from time to time due, owing or incurred by the chargor to lbcf, whether actually or contingently, solely or jointly and whether as principal or surety, including discount charges and interest (as well after as before judgement) commission and other fees and charges at the rates and on the terms agreed between the chargor and lbcf from time to time, together with all fees, costs, charges and expenses covenanted to be paid by the chargor, and all amounts owing in respect of indemnified events plus, in each case, interest at the rate agreed with the chargor, from that date the same are incurred to the date of payment in full compounded monthly or otherwise in accordance with lbcf, the chargor with full title guarantee charges to lbcf:. 1. by way of legal mortgage, the property (if any) described in schedule 1;. 2. by way of fixed charge any freehold or leasehold property now and in the future owned by the chargor or in which the chargor may have an interest; and. 3. by way of fixed charge, all the chargor’s intellectual property from time to time not disposed of in the ordinary course of the chargor’s business.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 11 ago 2014Registro de una carga (MR01)
    • 08 ene 2020Satisfacción de una carga (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creado el 18 dic 2008
    Entregado el 06 ene 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each of the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transacciones
    • 06 ene 2009Registro de un cargo (395)
    • 27 ago 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 18 dic 2008
    Entregado el 24 dic 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to each of the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Ansley hall drive birch coppice business park dordon tamworth t/no WK420996,valley farm way wakefield road stourton leeds t/no's WYK86702,WYK226146 and WYK674299,test lane nursling industrial estate southampton t/no HP597120 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Richard Douglas Michael John Summers as Security Trustee on Behalf of the Lenders
    Transacciones
    • 24 dic 2008Registro de un cargo (395)
    • 27 ago 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Works deposit deed
    Creado el 12 oct 2001
    Entregado el 19 oct 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £250,000 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The sum of £250,000 deposited by the chargor with the chargees' solicitors messrs mills & reeve.
    Personas con derecho
    • The Master Fellows and Scholars of the College of the Holy and Undivided Trinity within Thetown and University of Cambridge of King Henry Viii's Foundation (Otherwise Trinity College Cambridge)
    Transacciones
    • 19 oct 2001Registro de un cargo (395)
    • 14 jun 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment and charge
    Creado el 03 abr 1975
    Entregado el 10 abr 1975
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from town & city properties LTD to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    Leasehold warehouse at:- st. Brendan's way, avonmouth, avon.
    Personas con derecho
    • Manufacturers Hanover Trust Company
    Transacciones
    • 10 abr 1975Registro de una carga
    • 18 oct 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene ROADWAYS CONTAINER LOGISTICS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    23 jun 2021Inicio de la liquidación
    30 nov 2022Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Richard Howard Toone
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Profesional
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Lee De'Ath
    Town Wall House Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Essex
    Profesional
    Town Wall House Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Essex

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0