MARSTON, THOMPSON & EVERSHED LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MARSTON, THOMPSON & EVERSHED LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00048254 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MARSTON, THOMPSON & EVERSHED LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra MARSTON, THOMPSON & EVERSHED LIMITED?
| Dirección de la sede social | St Johns House St Johns Square WV2 4BH Wolverhampton United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MARSTON, THOMPSON & EVERSHED LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MARSTON THOMPSON & EVERSHED P L C | 09 jun 1896 | 09 jun 1896 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MARSTON, THOMPSON & EVERSHED LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 sept 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 jun 2027 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 27 sept 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para MARSTON, THOMPSON & EVERSHED LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 31 ene 2027 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 14 feb 2027 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 31 ene 2026 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MARSTON, THOMPSON & EVERSHED LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 27 sept 2025 | 9 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2026 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Stephen Robert Hopson como director el 01 dic 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Hayleigh Lupino como director el 27 sept 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 sept 2024 | 9 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2023 | 9 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Andrew Andonis Andrea como director el 17 nov 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Registro de la carga 000482540011, creada el 28 abr 2023 | 35 páginas | MR01 | ||
Registro de la carga 000482540012, creada el 28 abr 2023 | 35 páginas | MR01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 01 oct 2022 | 9 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Mr Andrew Andonis Andrea el 29 dic 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Edward John Hancock el 29 dic 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Robert Anthony Leach el 29 dic 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del secretario Mrs Michelle Louise Woodall el 29 dic 2022 | 1 páginas | CH03 | ||
Cambio de datos del director Mrs Hayleigh Lupino el 29 dic 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2023 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Modification des détails de Marston's Trading Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 dic 2022 | 2 páginas | PSC05 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Marston's House Brewery Road Wolverhampton WV1 4JT a St Johns House St Johns Square Wolverhampton WV2 4BH el 30 dic 2022 | 1 páginas | AD01 | ||
Cessation de W. & D. Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 sept 2022 | 1 páginas | PSC07 | ||
Notification de Marston's Trading Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 sept 2022 | 2 páginas | PSC02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 27 jun 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 02 oct 2021 | 9 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Anne Marie Brennan como secretario el 05 oct 2021 | 1 páginas | TM02 | ||
¿Quiénes son los directivos de MARSTON, THOMPSON & EVERSHED LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOODALL, Michelle Louise | Secretario | St Johns Square WV2 4BH Wolverhampton St Johns House United Kingdom | 288186530001 | |||||||
| HANCOCK, Edward John | Director | St Johns Square WV2 4BH Wolverhampton St Johns House United Kingdom | United Kingdom | British | 288133210002 | |||||
| HOPSON, Stephen Robert | Director | St Johns Square WV2 4BH Wolverhampton St Johns House United Kingdom | United Kingdom | British | 293724950001 | |||||
| LEACH, Robert Anthony | Director | St Johns Square WV2 4BH Wolverhampton St Johns House United Kingdom | United Kingdom | British | 194085550001 | |||||
| BRENNAN, Anne Marie | Secretario | Marston's House WV1 4JT Wolverhampton West Midlands | British | 109935620001 | ||||||
| BROWN, Willis Ian | Secretario | The Old Rectory Church Road Egginton DE65 6HP Derby | British | 57038740002 | ||||||
| FORD, Graham Evan | Secretario | 22 Braithwell Road Maltby S66 8JU Rotherham South Yorkshire | British | 33315710002 | ||||||
| PORTER, Hugh Leslie | Secretario | The Wolverhampton & Dudley Breweries Plc PO BOX 26 WV1 4NY Park Brewery Bath Road Wolverhampton | British | 63443690002 | ||||||
| ANDREA, Andrew Andonis | Director | St Johns Square WV2 4BH Wolverhampton St Johns House United Kingdom | England | British | 137383120011 | |||||
| ANDREW, Derek | Director | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House West Midlands | British | 39071260003 | ||||||
| BENTLEY, Peter John | Director | White Lodge Layer Marney CO5 9UR Colchester Essex | British | 16394920002 | ||||||
| BROWN, Willis Ian | Director | The Old Rectory Church Road Egginton DE65 6HP Derby | England | British | 57038740002 | |||||
| DALZELL, Peter | Director | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House United Kingdom | England | British | 163616170001 | |||||
| DARBY, Alistair William | Director | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House West Midlands | British | 87846880002 | ||||||
| DUNSMORE, John Michael | Director | 42 Cedar Street DE22 1GD Derby Derbyshire | British | 34568410002 | ||||||
| FINDLAY, Ralph Graham | Director | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marstons House West Midlands | England | British | 129897400001 | |||||
| GILHAM, Paul | Director | Starlings 8 Midway KT12 3HY Walton On Thames Surrey | British | 61363940001 | ||||||
| GORDON, David Watson | Director | The Beeches Bagot Street, Abbots Bromley WS15 3DB Rugeley Staffordshire | British | 70575910001 | ||||||
| HURDLE, Maurice Frederick | Director | Redmullion 94 Ashby Road DE15 Burton Upon Trent Staffordshire | British | 16394870001 | ||||||
| HURDLE, Michael William Frederick | Director | Yew Tree Farm Drointon ST18 0LX Stafford Staffordshire | England | British | 77971360002 | |||||
| INGLETT, Paul | Director | Marston's House WV1 4JT Wolverhampton West Midlands | British | 81617110002 | ||||||
| LETCHET, Nicholas Hugh | Director | 10 Bamburgh Grove CV32 6RL Leamington Spa Warwickshire | British | 40552250002 | ||||||
| LUPINO, Hayleigh | Director | St Johns Square WV2 4BH Wolverhampton St Johns House United Kingdom | United Kingdom | British | 207826950002 | |||||
| MARTEN, Anthony Derek | Director | Blakenhall Barr Lane Barton Under Needwood DE13 8AJ Burton On Trent Staffordshire | British | 32009960003 | ||||||
| MATTHEWS, Michael David Evelyn Mynors | Director | Blackwood Auld Girth DG2 0UA Dumfries | British | 773230001 | ||||||
| METCALF, Simon Railton | Director | 52 Rivermead Court Ranelagh Gardens SW6 3RY London | British | 7870850002 | ||||||
| MILLER, James David Frederick | Director | Blairuskin Lodge Kinlochard FK8 3TP Aberfoyle Stirling | British | 27537080001 | ||||||
| OLIVER, Stephen John | Director | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House West Midlands | British | 66123690003 | ||||||
| ORR, John Carmichael | Director | 24 Denbigh Gardens TW10 6EL Richmond Surrey | British | 7480830001 | ||||||
| THOMPSON, David George Fossett | Director | Albrighton Hall Albrighton WV7 3JQ Wolverhampton West Midlands | United Kingdom | English | 4188260001 | |||||
| THOMPSON, Michael Robert | Director | Park Road Alrewas DE13 7AG Burton On Trent 20 Staffordshire | British | 134817070001 | ||||||
| TWEDDELL, Crispin Noel Stephen | Director | 28 Leamington Road Villas W11 1HT London | England | British | 3687790001 | |||||
| WESTWOOD, Richard James | Director | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House United Kingdom | England | British | 314691870001 | |||||
| WOMACK, Martin | Director | 10 Friars Street WV16 4BJ Bridgnorth Shropshire | British | 75969860001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de MARSTON, THOMPSON & EVERSHED LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marston's Trading Limited | 05 sept 2022 | St Johns Square WV2 4BH Wolverhampton St Johns House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| W. & D. Limited | 06 abr 2016 | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0