DAVENPORT VERNON HIGH WYCOMBE LIMITED

DAVENPORT VERNON HIGH WYCOMBE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaDAVENPORT VERNON HIGH WYCOMBE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00052182
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de DAVENPORT VERNON HIGH WYCOMBE LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra DAVENPORT VERNON HIGH WYCOMBE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive, Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DAVENPORT VERNON HIGH WYCOMBE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    DAVENPORT VERNON & COMPANY LIMITED15 abr 189715 abr 1897

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de DAVENPORT VERNON HIGH WYCOMBE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para DAVENPORT VERNON HIGH WYCOMBE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 14 jul 2017

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Reduce share prem a/c 29/06/2017
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 17 ene 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Hilary Claire Sykes como director el 01 ene 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Hilary Claire Sykes como secretario el 01 ene 2017

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Richard James Maloney como secretario el 01 ene 2017

    2 páginasAP03

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 17 ene 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital19 ene 2016

    Estado de capital el 19 ene 2016

    • Capital: GBP 14,793
    SH01

    Cambio de datos del director Timothy Paul Holden el 26 oct 2015

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 17 ene 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital21 ene 2015

    Estado de capital el 21 ene 2015

    • Capital: GBP 14,793
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 17 ene 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital22 ene 2014

    Estado de capital el 22 ene 2014

    • Capital: GBP 14,793
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    6 páginasAA

    Cancelación total de la carga 4

    4 páginasMR04

    Déclaration annuelle établie au 17 ene 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 17 ene 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    6 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de DAVENPORT VERNON HIGH WYCOMBE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MALONEY, Richard James
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive, Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Secretario
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive, Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    222149230001
    HOLDEN, Timothy Paul
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive, Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive, Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish148034310003
    EVANS HALSHAW MOTORS LIMITED
    2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Director corporativo
    2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro2304195
    38967740005
    JAMES, Clive Michael
    19 Lime Avenue
    MK18 7JJ Buckingham
    Buckinghamshire
    Secretario
    19 Lime Avenue
    MK18 7JJ Buckingham
    Buckinghamshire
    British58586570001
    LACEY, Pamela Anne
    Orchard Cottage Green Lane
    Prestwood
    HP16 0QA Great Missenden
    Buckinghamshire
    Secretario
    Orchard Cottage Green Lane
    Prestwood
    HP16 0QA Great Missenden
    Buckinghamshire
    British3665020001
    PITT, Andrew Joseph
    45 Westholme Road
    Bidford On Avon
    B50 4AL Alcester
    Warwickshire
    Secretario
    45 Westholme Road
    Bidford On Avon
    B50 4AL Alcester
    Warwickshire
    British10739800001
    SYKES, Hilary Claire
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive, Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Secretario
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive, Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    British41559790001
    ADAMS, Anthony Grant
    71 Townsend Lane
    AL5 2RE Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    71 Townsend Lane
    AL5 2RE Harpenden
    Hertfordshire
    British24182780001
    ARCHER, Anthony Bernard
    The Moat Barn
    Glasshouse Lane
    B94 6PU Lapworth
    Warwickshire
    Director
    The Moat Barn
    Glasshouse Lane
    B94 6PU Lapworth
    Warwickshire
    British46351440001
    BAKER, Donald John
    Kings Ash Farm
    Kings Ash
    HP16 9NP Great Missenden
    Buckinghamshire
    Director
    Kings Ash Farm
    Kings Ash
    HP16 9NP Great Missenden
    Buckinghamshire
    British11327670002
    BENNETT, Michael Ronald
    2 Kentmere Road
    HP21 7HZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Director
    2 Kentmere Road
    HP21 7HZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritish75618940001
    CAMERON, Charles Donald Ewen
    Orchard Manor
    Church Lane Martin Hussingtree
    WR3 8TQ Worcester
    Worcestershire
    Director
    Orchard Manor
    Church Lane Martin Hussingtree
    WR3 8TQ Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish113187140001
    DALE, Arthur Geoffrey
    Kimberley
    Poolhead Lane
    B94 5ED Tanworth In Arden Solihull
    West Midlands
    Director
    Kimberley
    Poolhead Lane
    B94 5ED Tanworth In Arden Solihull
    West Midlands
    British10739820001
    DENNE, David Ralph
    Bucks Barn
    Highmoor
    RG9 5PE Henley On Thames
    Oxfordshire
    Director
    Bucks Barn
    Highmoor
    RG9 5PE Henley On Thames
    Oxfordshire
    British35524210001
    MURPHY, Patrick Francis
    32 Aldrich Drive
    Willen
    MK15 9LU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Director
    32 Aldrich Drive
    Willen
    MK15 9LU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British30408640002
    STYLES, William
    Hyfirs
    Downley Road Naphill
    HP14 4QY High Wycombe
    Bucks
    Director
    Hyfirs
    Downley Road Naphill
    HP14 4QY High Wycombe
    Bucks
    British24499510001
    SYKES, Hilary Claire
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive, Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive, Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish41559790001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de DAVENPORT VERNON HIGH WYCOMBE LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Evans Halshaw Motor Holdings Limited
    Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    06 abr 2016
    Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland & Wales
    Número de registro1212182
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene DAVENPORT VERNON HIGH WYCOMBE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A security agreement
    Creado el 13 may 2009
    Entregado el 21 may 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    For details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties (The Override Agent)
    Transacciones
    • 21 may 2009Registro de un cargo (395)
    • 07 may 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 17 ago 1988
    Entregado el 26 ago 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or 7 other companies named on the schedule to elf oil(ge) limited, under the terms of the charge.
    Breve descripción
    F/H petrol filling station & premises fronting london rd high wycombe, buckinghamshire. Described in the 1ST schedule of a deed of exchange on 17/09/65 land situate at london rd, high wycombe comprised in a conveyance - 28/03/74 f/h property in high wycombe comprised in a conveyance- 2/8/66 f/h land situate in high wycombe comprised in a conveyance - 30/11/65 (please see form M39-304C- for further details).
    Personas con derecho
    • Elf Oil (GB) Limited
    Transacciones
    • 26 ago 1988Registro de una carga
    • 27 may 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Floating charge
    Creado el 12 nov 1986
    Entregado el 13 nov 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Floating charge over all stocks or new and used mechanically propelled vehicles owned by the company and intended or adapted for use upon roads &/or the proceeds of sale of any such vehicles. (See doc M531/14NOV/cr for full details).
    Personas con derecho
    • Forward Trust Limited
    Transacciones
    • 13 nov 1986Registro de una carga
    • 26 feb 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 28 jul 1980
    Entregado el 11 ago 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/Hold land & premises at london road, high wycombe. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 11 ago 1980Registro de una carga
    • 02 mar 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0