WOOLLEN AND COMPANY,LIMITED

WOOLLEN AND COMPANY,LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaWOOLLEN AND COMPANY,LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00055238
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de WOOLLEN AND COMPANY,LIMITED?

    • Otras actividades de servicios n.c.p. (96090) / Otras actividades de servicios

    ¿Dónde se encuentra WOOLLEN AND COMPANY,LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de WOOLLEN AND COMPANY,LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta06 ene 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para WOOLLEN AND COMPANY,LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 31 jul 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Cws (No.1) Limited como director el 12 jul 2019

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Jonathan Michael Wormald como director el 12 jul 2019

    2 páginasAP01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 09 ene 2019

    • Capital: GBP 100.00
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Declaración de confirmación presentada el 31 jul 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 06 ene 2018

    4 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 11 ene 2017

    4 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 jul 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 11 ene 2016

    4 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 jul 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Nombramiento de Mr David Roberts como director el 01 abr 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Steven Clive Bailey como director el 01 abr 2016

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 31 jul 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 ago 2015

    Estado de capital el 06 ago 2015

    • Capital: GBP 30,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 11 ene 2015

    3 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 02 ene 2014

    3 páginasAA

    Exercice comptable en cours prolongé du 02 ene 2015 au 11 ene 2015

    1 páginasAA01

    Déclaration annuelle établie au 31 jul 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital28 ago 2014

    Estado de capital el 28 ago 2014

    • Capital: GBP 30,000
    SH01

    Déclaration annuelle établie au 16 abr 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital24 abr 2014

    Estado de capital el 24 abr 2014

    • Capital: GBP 30,000
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Steven Clive Bailey el 27 feb 2014

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de WOOLLEN AND COMPANY,LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SELLERS, Caroline Jane
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Secretario
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    150062600001
    ROBERTS, David Francis
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Director
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish200852560001
    WORMALD, Jonathan Michael
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Director
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    EnglandBritish201020490001
    ELDRIDGE, Katherine Elizabeth
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    Secretario
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    British110230860001
    FRENCH, John Leslie
    23 Sicey Lane
    S5 0RR Sheffield
    South Yorkshire
    Secretario
    23 Sicey Lane
    S5 0RR Sheffield
    South Yorkshire
    British103190910001
    HOWARTH, Michael
    Underhill Road
    Barlborough
    S43 4UX Chesterfield
    2
    Derbyshire
    Secretario
    Underhill Road
    Barlborough
    S43 4UX Chesterfield
    2
    Derbyshire
    British61681710001
    WARBURTON, Joan
    571 Wordsworth Avenue
    S5 9JF Sheffield
    South Yorkshire
    Secretario
    571 Wordsworth Avenue
    S5 9JF Sheffield
    South Yorkshire
    British26416610001
    WHITHAM, John Edward
    45 Rivelin Park Crescent
    S6 5GF Sheffield
    South Yorkshire
    Secretario
    45 Rivelin Park Crescent
    S6 5GF Sheffield
    South Yorkshire
    British101985790001
    UCL SECRETARY LIMITED
    United Co Operatives Limited
    Sandbrook Park Sandbrook Way
    OL11 1RY Rochdale
    Lancashire
    Secretario corporativo
    United Co Operatives Limited
    Sandbrook Park Sandbrook Way
    OL11 1RY Rochdale
    Lancashire
    111685670001
    BAILEY, Steven Clive
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Director
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish95753690002
    DAVIDSON, Colin Campbell
    256 Dobbin Hill
    S11 7JG Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    256 Dobbin Hill
    S11 7JG Sheffield
    South Yorkshire
    British3907100001
    FRENCH, John Leslie
    23 Sicey Lane
    S5 0RR Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    23 Sicey Lane
    S5 0RR Sheffield
    South Yorkshire
    British103190910001
    HOWARTH, Michael
    Underhill Road
    Barlborough
    S43 4UX Chesterfield
    2
    Derbyshire
    Director
    Underhill Road
    Barlborough
    S43 4UX Chesterfield
    2
    Derbyshire
    EnglandBritish61681710001
    HUMES, Stephen
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    Director
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    United KingdomBritish84087790001
    HURRELL, Timothy
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    Director
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    United KingdomBritish99724260001
    KERSHAW, Clifford Harold
    83 Riverdale Road
    S10 3FE Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    83 Riverdale Road
    S10 3FE Sheffield
    South Yorkshire
    British3907110001
    KERSHAW, Jessie
    Highlands Farm
    Northill
    SG18 9AW Biggleswade
    Bedfordshire
    Director
    Highlands Farm
    Northill
    SG18 9AW Biggleswade
    Bedfordshire
    British26416620002
    KERSHAW, Paul
    14 Clark Grove
    Stannington
    S6 6AY Sheffield
    Director
    14 Clark Grove
    Stannington
    S6 6AY Sheffield
    British49702830002
    MCCRACKEN, Philip Guy
    The Bothy
    Bere Court Farm Pangbourne
    RG8 8HT Reading
    Berkshire
    Director
    The Bothy
    Bere Court Farm Pangbourne
    RG8 8HT Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish106997230001
    SILVER, Steven Russell
    Farr Royd House
    72 Sun Lane
    LS29 7LT Burley In Wharfedale
    West Yorkshire
    Director
    Farr Royd House
    72 Sun Lane
    LS29 7LT Burley In Wharfedale
    West Yorkshire
    EnglandBritish182256460001
    WHITHAM, John Edward
    45 Rivelin Park Crescent
    S6 5GF Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    45 Rivelin Park Crescent
    S6 5GF Sheffield
    South Yorkshire
    British101985790001
    CWS (NO.1) LIMITED
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Director corporativo
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro1925625
    130695310001
    UCL DIRECTOR 1 LIMITED
    United Co-Operatives Limited
    Sandbrook Park
    OL11 1RY Rochdale
    Director corporativo
    United Co-Operatives Limited
    Sandbrook Park
    OL11 1RY Rochdale
    110868260001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para WOOLLEN AND COMPANY,LIMITED?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    31 jul 2016La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene WOOLLEN AND COMPANY,LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 28 may 2004
    Entregado el 12 jun 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £30,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    F/H property being 19 love street sheffield & f/h land and buildings on the north side of love street sheffield (now known as 2 love st) t/no SYK266430.
    Personas con derecho
    • Sheffield Co-Operative Society Limited
    Transacciones
    • 12 jun 2004Registro de un cargo (395)
    • 19 feb 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 21 jun 1999
    Entregado el 01 jul 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The f/hold property known as land & buildings on the north side of love street sheffield south yorkshire t/no: SYK266430. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 01 jul 1999Registro de un cargo (395)
    • 14 feb 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 28 oct 1996
    Entregado el 01 nov 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a 19 love street, sheffield and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 01 nov 1996Registro de un cargo (395)
    • 14 feb 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0