SHEFFIELD CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

SHEFFIELD CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSHEFFIELD CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social
    Número de empresa 00064569
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SHEFFIELD CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY?

    • Actividades de organizaciones profesionales de miembros (94120) / Otras actividades de servicios

    ¿Dónde se encuentra SHEFFIELD CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY?

    Dirección de la sede social
    Westfield House
    Charter Row
    S1 3FZ Sheffield
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SHEFFIELD CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SHEFFIELD AND ROTHERHAM CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY29 oct 199329 oct 1993
    SHEFFIELD CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY01 may 199101 may 1991
    SHEFFIELD CHAMBER OF COMMERCE & MANUFACTURERS(INCORPORATED)(THE)19 dic 189919 dic 1899

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SHEFFIELD CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 mar 2025
    Próximas cuentas vencen el31 dic 2025
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para SHEFFIELD CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta04 jun 2025
    Próxima declaración de confirmación vence18 jun 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta04 jun 2024
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SHEFFIELD CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cese del nombramiento de Daniel Craig Kirkland como director el 14 mar 2025

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Karen Susan Mosley como director el 14 mar 2025

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Emma Louise Marshall como director el 14 mar 2025

    1 páginasTM01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Extend the term of all existing chamber by one year . update membership t&c 14/11/2022
    RES13

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2024

    10 páginasAA

    Memorándum y Estatutos

    19 páginasMA

    Domicilio social registrado cambiado de Westfield House Charter Row Sheffield S1 3FS United Kingdom a Westfield House Charter Row Sheffield S1 3FZ el 02 sept 2024

    1 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de John Banner Centre 620 Attercliffe Road Sheffield South Yorkshire S9 3QS United Kingdom a Westfield House Charter Row Sheffield S1 3FS el 02 sept 2024

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 04 jun 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Ms Erica Thompson como director el 25 abr 2024

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Ms Amy Elizabeth Grey como director el 25 abr 2024

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Dr Samuel John Chapman como director el 25 abr 2024

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Martin James Claude Mckervey como director el 27 feb 2024

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de James Berry como director el 27 feb 2024

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2023

    10 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 04 jun 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de James Needham como director el 13 dic 2022

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Victoria Mary Brown como director el 14 nov 2022

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Ms Jenna Selwood como secretario el 14 nov 2022

    2 páginasAP03

    Nombramiento de Mrs Louisa Jane Walker como director el 01 nov 2022

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2022

    10 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 04 jun 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Wan Loi Cheung como director el 01 mar 2021

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Ms Emma Louise Marshall como director el 01 mar 2021

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Martin James Claude Mckervey como director el 01 mar 2021

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de SHEFFIELD CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SELWOOD, Jenna
    Charter Row
    S1 3FZ Sheffield
    Westfield House
    United Kingdom
    Secretario
    Charter Row
    S1 3FZ Sheffield
    Westfield House
    United Kingdom
    302626080001
    CHAPMAN, Samuel John
    Charter Row
    S1 3FZ Sheffield
    Westfield House
    United Kingdom
    Director
    Charter Row
    S1 3FZ Sheffield
    Westfield House
    United Kingdom
    United KingdomBritishNed130753950002
    CHEUNG, Wan Loi
    Charter Row
    S1 3FZ Sheffield
    Westfield House
    United Kingdom
    Director
    Charter Row
    S1 3FZ Sheffield
    Westfield House
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector92544350001
    GREY, Amy Elizabeth
    Charter Row
    S1 3FZ Sheffield
    Westfield House
    United Kingdom
    Director
    Charter Row
    S1 3FZ Sheffield
    Westfield House
    United Kingdom
    EnglandBritishNed278829990001
    KRACHAI, Alexis John
    Charter Row
    S1 3FZ Sheffield
    Westfield House
    United Kingdom
    Director
    Charter Row
    S1 3FZ Sheffield
    Westfield House
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director133768500005
    RAMJI, Faaiza
    Charter Row
    S1 3FZ Sheffield
    Westfield House
    United Kingdom
    Director
    Charter Row
    S1 3FZ Sheffield
    Westfield House
    United Kingdom
    CanadaCanadianFounder & Director290577750001
    THOMPSON, Erica
    Charter Row
    S1 3FZ Sheffield
    Westfield House
    United Kingdom
    Director
    Charter Row
    S1 3FZ Sheffield
    Westfield House
    United Kingdom
    EnglandBritishNed322965500001
    WALKER, Louisa Jane
    Charter Row
    S1 3FZ Sheffield
    Westfield House
    United Kingdom
    Director
    Charter Row
    S1 3FZ Sheffield
    Westfield House
    United Kingdom
    EnglandBritishCeo115032780005
    AINSWORTH, Matthew Robert
    Albion House
    Savile Street
    S4 7UD Sheffield
    S Yorkshire
    Secretario
    Albion House
    Savile Street
    S4 7UD Sheffield
    S Yorkshire
    174031810001
    BROWN, Ian
    620 Attercliffe Road
    S9 3QS Sheffield
    John Banner Centre
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Secretario
    620 Attercliffe Road
    S9 3QS Sheffield
    John Banner Centre
    South Yorkshire
    United Kingdom
    203588770001
    BULLOCK, James Andrew Douglas
    Albion House
    Savile Street
    S4 7UD Sheffield
    S Yorkshire
    Secretario
    Albion House
    Savile Street
    S4 7UD Sheffield
    S Yorkshire
    155565270001
    KNEEN, David Anthony
    124 Marlcliffe Road
    S6 4AJ Sheffield
    South Yorkshire
    Secretario
    124 Marlcliffe Road
    S6 4AJ Sheffield
    South Yorkshire
    British36744810001
    MITCHELL, Stephen Edward
    20 Lord Haddon Road
    DE7 8AW Ilkeston
    Derbyshire
    Secretario
    20 Lord Haddon Road
    DE7 8AW Ilkeston
    Derbyshire
    BritishCompany Secretary101068970002
    ROE, Michael Charles
    24 Belford Close
    Bramley
    S66 3YS Rotherham
    South Yorkshire
    Secretario
    24 Belford Close
    Bramley
    S66 3YS Rotherham
    South Yorkshire
    British60112900001
    ADSETTS, William Norman, Sir
    28 Endcliffe Hall Avenue
    S10 3EL Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    28 Endcliffe Hall Avenue
    S10 3EL Sheffield
    South Yorkshire
    BritishDirector54290001
    ARMATYS, Brian Dennison
    94 Westbourne Road
    S10 2QT Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    94 Westbourne Road
    S10 2QT Sheffield
    South Yorkshire
    BritishSolicitor - Retired5044250001
    BAMFORD, Alan Maxwell
    Stonecroft 53 Vicarage Lane
    Dore
    S17 3GX Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    Stonecroft 53 Vicarage Lane
    Dore
    S17 3GX Sheffield
    South Yorkshire
    BritishCompany Director11424620001
    BECK, Hermann
    Rivelin Filter Cottage
    Manchester Road
    S6 5SP Sheffield
    Director
    Rivelin Filter Cottage
    Manchester Road
    S6 5SP Sheffield
    United KingdomGermanCompany Director73185820001
    BEELEY, Steven Charles
    7 Gladstone Road
    Ranmoor
    S10 3GT Sheffield
    Director
    7 Gladstone Road
    Ranmoor
    S10 3GT Sheffield
    BritishChief Executive34270290001
    BERRY, James
    620 Attercliffe Road
    S9 3QS Sheffield
    John Banner Centre
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    620 Attercliffe Road
    S9 3QS Sheffield
    John Banner Centre
    South Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishPartner231063790001
    BLADEN, Simon Luke
    463a Glossop Road
    S10 2QD Sheffield
    Pegasus House
    South Yorkshire
    England
    Director
    463a Glossop Road
    S10 2QD Sheffield
    Pegasus House
    South Yorkshire
    England
    EnglandEnglishChartered Accountant184430680001
    BOOTH, Christine Janet
    Meadow Bank Avenue
    S7 1PB Sheffield
    42
    South Yorkshire
    Director
    Meadow Bank Avenue
    S7 1PB Sheffield
    42
    South Yorkshire
    United KingdomBritishPro Vice-Chancellor Of Uni121875460001
    BRINDLEY, Peter
    178 Bawtry Road
    DN4 7BU Doncaster
    South Yorkshire
    Director
    178 Bawtry Road
    DN4 7BU Doncaster
    South Yorkshire
    United KingdomBritishManager Property & Administrat17237200001
    BROWN, Victoria Mary
    620 Attercliffe Road
    S9 3QS Sheffield
    John Banner Centre
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    620 Attercliffe Road
    S9 3QS Sheffield
    John Banner Centre
    South Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector192248110001
    CATTERALL, Valerie Ann
    Bala Dreen 2 Wesley Place
    South Anston
    S31 7DZ Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    Bala Dreen 2 Wesley Place
    South Anston
    S31 7DZ Sheffield
    South Yorkshire
    BritishDirector36744730001
    CHILD, David Malcolm
    Albion House
    Savile Street
    S4 7UD Sheffield
    S Yorkshire
    Director
    Albion House
    Savile Street
    S4 7UD Sheffield
    S Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director49704620002
    CORNER, John Michael
    11 Winchester Crescent
    S10 4ED Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    11 Winchester Crescent
    S10 4ED Sheffield
    South Yorkshire
    BritishMd Public Relations Company9321860001
    CORNER, John Michael
    11 Winchester Crescent
    S10 4ED Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    11 Winchester Crescent
    S10 4ED Sheffield
    South Yorkshire
    BritishMd Public Relations Company9321860001
    CORNICK, Peter Charles
    Moorgate House 2 Cavendish Avenue
    S17 3NJ Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    Moorgate House 2 Cavendish Avenue
    S17 3NJ Sheffield
    South Yorkshire
    BritishCompany Director5914860001
    COWIE, Duncan
    15 Glade Croft
    Gleadless
    S12 2UZ Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    15 Glade Croft
    Gleadless
    S12 2UZ Sheffield
    South Yorkshire
    BritishManaging Director/Hotelier37603310001
    CULLEY, Howard Eric
    Eastwood House
    Church Bank, Hathersage
    S32 1AJ Hope Valley
    Derbyshire
    Director
    Eastwood House
    Church Bank, Hathersage
    S32 1AJ Hope Valley
    Derbyshire
    EnglandBritishSolicitor8297970003
    DANIELS, Keith
    25 Haugh Lane
    S11 9SA Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    25 Haugh Lane
    S11 9SA Sheffield
    South Yorkshire
    BritishChartered Accountant84929880001
    FACEY, Hugh David
    Clifford House
    Ecclesall Road South
    S11 9PX Sheffield
    Director
    Clifford House
    Ecclesall Road South
    S11 9PX Sheffield
    EnglandBritishManaging Director81575880001
    FROST, Richard Anthony
    Snaithing Spring
    3 Grange Cliff Close
    S11 9JE Millhouses Lane
    South Yorkshire
    Director
    Snaithing Spring
    3 Grange Cliff Close
    S11 9JE Millhouses Lane
    South Yorkshire
    EnglandBritishChartered Accountant9855630002
    GILMARTIN, Paul Anthony Lawrence
    Homewood 11 Endcliffe Hall Avenue
    S10 3EL Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    Homewood 11 Endcliffe Hall Avenue
    S10 3EL Sheffield
    South Yorkshire
    BritishManaging Director13647940001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para SHEFFIELD CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    04 jun 2017La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0