VITREOUS ENAMELS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | VITREOUS ENAMELS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00065362 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de VITREOUS ENAMELS LIMITED?
- (7499) /
¿Dónde se encuentra VITREOUS ENAMELS LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Glen Dimplex Home Appliances Ltd, Stoney Lane L35 2XW Prescot Merseyside |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de VITREOUS ENAMELS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| T.I. VITREOUS ENAMELS LIMITED | 16 mar 1900 | 16 mar 1900 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de VITREOUS ENAMELS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2011 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para VITREOUS ENAMELS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2011 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Stephen John Yarwood como secretario el 01 ago 2011 | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Stephen John Yarwood como director el 01 ago 2011 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Charles Mc Cooey como secretario el 31 jul 2011 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Charles Mc Cooey como director el 31 jul 2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 13 ago 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Denver Thomas Bud Hewlett el 09 feb 2011 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director John Charles Mc Cooey el 09 feb 2011 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario John Charles Mc Cooey el 09 feb 2011 | 3 páginas | CH03 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2010 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 13 ago 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2009 | 12 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 mar 2008 | 6 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 mar 2007 | 6 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 2 páginas | 363a | ||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 mar 2006 | 6 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 2 páginas | 363a | ||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 mar 2005 | 6 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 2 páginas | 363a | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 353 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de VITREOUS ENAMELS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARWOOD, Stephen John | Secretario | C/O Glen Dimplex Home Appliances Ltd, Stoney Lane L35 2XW Prescot Merseyside | 162944500001 | |||||||
| HEWLETT, Denver Thomas Bud | Director | Stoney Lane L35 2XW Prescot Merseyside United Kingdom | United Kingdom | British | 75937380003 | |||||
| YARWOOD, Stephen John | Director | C/O Glen Dimplex Home Appliances Ltd, Stoney Lane L35 2XW Prescot Merseyside | United Kingdom | British | 142131830001 | |||||
| AMIN, Shailesh | Secretario | 268 Oldfield Lane North UB6 8PS Greenford Middlesex | British | 44718970001 | ||||||
| BATES, James Reid | Secretario | 36 Littlecote Gardens Appleton WA4 5DL Warrington Cheshire | British | 19943020001 | ||||||
| FRANKLIN, Gordon Francis | Secretario | The Cottage Little End Hunningham CV33 9DT Leamington Spa Warwickshire | British | 29905900001 | ||||||
| HADLEY, Keith Edward | Secretario | 13 Rushton Drive Upton CH2 1RE Chester Cheshire | British | 56533420001 | ||||||
| LUCARELLI, Rudolfo | Secretario | 111 Belgrave Road SW1 London | British | 34183990001 | ||||||
| MC COOEY, John Charles | Secretario | Stoney Lane L35 2XW Prescot Merseyside United Kingdom | Irish | 77850570007 | ||||||
| PARKER, Neil Anthony | Secretario | 18 Stokes End Haddenham HP17 8DX Aylesbury Buckinghamshire | British | 71102540002 | ||||||
| PRESLEY, Roger | Secretario | 101 Common Lane Culcheth WA3 4HQ Warrington Cheshire | British | 4919340002 | ||||||
| SLAUGHTER, Ian Richard Holder | Secretario | 34 Morley Road TW1 2HF Twickenham Middlesex | British | 39851430001 | ||||||
| BATES, James Reid | Director | 36 Littlecote Gardens Appleton WA4 5DL Warrington Cheshire | British | 19943020001 | ||||||
| CAIO, Francesco | Director | Via Monte Leggero 3 FOREIGN Ivrea Italy | Italian | 73843190002 | ||||||
| COLA, Enrico | Director | Via Madonna Delle Grazie 28 60043 Cerreto D'Esi (An) Italy | Italian | 53813650001 | ||||||
| COLA, Mauro | Director | Flat 5 Grange Court Grange Road WA14 3EU Bowdon Cheshire | Italian | 46346520002 | ||||||
| CRATHORNE, John Roger | Director | Highams Farm Howletts End Wimbish CB10 2XT Saffron Walden Essex | British | 6113170002 | ||||||
| CUCCURULLO, Antonio | Director | Via Degli Ulivi/S Rufina Cittaducale (Rieti) 02010 FOREIGN Italy | Italian | 54958560001 | ||||||
| DEL NERI, Edoardo | Director | Via Mameli 10 I-60044 Fabriano FOREIGN An Italy | Italian | 41908340001 | ||||||
| FARROW, Brian | Director | 87 Belgrave Road BB3 2SF Darwen Lancashire | British | 34108090001 | ||||||
| FISHER, George | Director | 13 Little Fosters Chaddesley Glen BH13 7PB Poole Dorset | England | British | 109412800001 | |||||
| FRANKLIN, Gordon Francis | Director | The Cottage Little End Hunningham CV33 9DT Leamington Spa Warwickshire | England | British | 29905900001 | |||||
| GNAGNATTI, Giuliano | Director | Havelock North Old Mill Lane, Bray SL6 2BD Maidenhead Berkshire | British | 67353700001 | ||||||
| HASSALL, Michael | Director | 1 Hornbeam Drive CW8 2GA Hartford Cheshire | British | 48866820001 | ||||||
| MC COOEY, John Charles | Director | Stoney Lane L35 2XW Prescot Merseyside United Kingdom | United Kingdom | Irish | 77850570008 | |||||
| MILANI, Marco | Director | Via Mastro Marino 15 60044 Fabriano Italy | Italy | Italian | 52049990001 | |||||
| NICHOLSON, John Evans | Director | 89 Dove Close Birchwood WA3 6QH Warrington Cheshire | British | 44212980001 | ||||||
| NICOLAI, Carlo | Director | Fraz Monteprandone I-63033 Centobuchi Italy | Italian | 41902500001 | ||||||
| PHILBY, Patrick Montague | Director | Firs Hill Bloxham OX15 4HR Banbury Oxfordshire | British | 14690620001 | ||||||
| ROBERTS, John Wyn | Director | 21 Romilly Crescent Hakin SA73 3NH Milford Haven Dyfed | British | 47219700001 | ||||||
| SAMSON, Joseph Ephraim | Director | 19 Canonbury Place N1 2NS London | British | 6097740001 | ||||||
| SANTINI, Francesco | Director | Via Silvio Pellico 4 I-60044 Fabriano FOREIGN Italy | Italian | 41902620001 | ||||||
| SLAUGHTER, Ian Richard Holder | Director | 34 Morley Road TW1 2HF Twickenham Middlesex | British | 39851430001 | ||||||
| WARD, Joseph | Director | 7 Eden Close Rainhill L35 0ND Prescot Merseyside | British | 14156550001 |
¿Tiene VITREOUS ENAMELS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debenture | Creado el 02 ago 1994 Entregado el 04 ago 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the companyand/or all or any other companies named therein to the chargees under the terms of the facilities agreement the working capital facility letter the loan stock instrument the loan stock the intercreditor agreement and this deed | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0