GRAHAM BUILDERS MERCHANTS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | GRAHAM BUILDERS MERCHANTS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00066738 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GRAHAM BUILDERS MERCHANTS LIMITED?
- (7499) /
¿Dónde se encuentra GRAHAM BUILDERS MERCHANTS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Tower Bridge House St Katharine'S Way E1W 1DD London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GRAHAM BUILDERS MERCHANTS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2009 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para GRAHAM BUILDERS MERCHANTS LIMITED?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GRAHAM BUILDERS MERCHANTS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 4 páginas | 4.71 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 14 dic 2014 | 7 páginas | 4.68 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 14 dic 2013 | 4 páginas | 4.68 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 14 dic 2012 | 5 páginas | 4.68 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 14 dic 2011 | 5 páginas | 4.68 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * Saint-Gobain House Binley Business Park Coventry CV3 2TT* el 04 ene 2011 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 3 páginas | 4.70 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Philip Edward Moore como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Thierry Lambert como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Thierry Lambert el 24 jun 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Alun Roy Oxenham el 28 abr 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Alun Roy Oxenham el 28 abr 2010 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 mar 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2008 | 6 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288c | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 287 | ||||||||||
legacy | 4 páginas | 363a | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288a | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2007 | 6 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 4 páginas | 363a | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de GRAHAM BUILDERS MERCHANTS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXENHAM, Alun Roy | Secretario | Binley Business Park CV3 2TT Coventry Saint-Gobain House United Kingdom | British | 72478560002 | ||||||
| MOORE, Philip Edward | Director | Binley Business Park CV3 2TT Coventry Saint-Gobain House United Kingdom | United Kingdom | British | 60599570002 | |||||
| OXENHAM, Alun Roy | Director | Binley Business Park CV3 2TT Coventry Saint-Gobain House United Kingdom | United Kingdom | British | 72478560002 | |||||
| FARNELL, David Roy | Secretario | 4 Hayfield Close Holmfirth HD7 1XQ Huddersfield West Yorkshire | British | 694920001 | ||||||
| HOGG, Jennifer Mary | Secretario | Wandle Cottage 284 London Road SM6 7DJ Wallington Surrey | British | 67292170002 | ||||||
| LEATHLEY, Stephen Grant | Secretario | 89 Hough Top LS13 4QN Leeds West Yorkshire | British | 72040150001 | ||||||
| BARKER, Stephen | Director | Brierleigh Upper Sutherland Road HX3 8NT Halifax West Yorkshire | British | 48745450001 | ||||||
| BAYLISS, Michael Clifford | Director | 11 Willow Green WA16 6AX Knutsford Cheshire | British | 39034590001 | ||||||
| BOND, Francis Keith | Director | Hartfield Sheardale Honley HD7 2RU Huddersfield West Yorkshire | British | 36284300002 | ||||||
| BURNS, Peter Lawrence | Director | 138 Stocks Bank Road WF14 0EY Mirfield West Yorkshire | British | 16506700001 | ||||||
| BURTON, Amanda Jane | Director | 25 Ravensdon Street SE11 4AQ London | United Kingdom | British | 526080001 | |||||
| BUYS, William Frederick | Director | Brawns Bix RG9 4RY Henley On Thames Oxfordshire | British | 97730001 | ||||||
| CAHILL, Jack | Director | 16 Larch Grove Lady Lane Bingley BD16 4SF Bradford West Yorkshire | British | 37460910001 | ||||||
| CURRIE, Gordon Bell | Director | Curlaw 296 Kirk Road ML2 7BZ Wishaw Lanarkshire | Scotland | British | 39034850001 | |||||
| EASTWOOD, Rodney | Director | 4 Heathwood Drive Golcar HD7 4PH Huddersfield West Yorkshire | British | 1907000001 | ||||||
| EDWARDS, John Frederick | Director | 32 High Street CV34 4AX Warwick Warwickshire | England | British | 2548360001 | |||||
| ELSMORE, Robert John | Director | 40 Hill Village Road B75 5BA Sutton Coldfield West Midlands | United Kingdom | British | 17206330002 | |||||
| FARNELL, David Roy | Director | 4 Hayfield Close Holmfirth HD7 1XQ Huddersfield West Yorkshire | British | 694920001 | ||||||
| FELL, Raymond Anthony | Director | 33 Rosafield Avenue B62 9BU Halesowen West Midlands | British | 39034630001 | ||||||
| GRIFFITHS, Peter Frank | Director | 10 Shepherds Mead Greenhill LU7 8AH Leighton Buzzard Bedfordshire | British | 39035070001 | ||||||
| HOGG, Jennifer Mary | Director | Wandle Cottage 284 London Road SM6 7DJ Wallington Surrey | British | 67292170002 | ||||||
| HOOPER, Ormond James | Director | 18 Catton Lane Rosliston DE12 8JP Swadlincote Derbyshire | England | British | 39034790001 | |||||
| LAMBERT, Thierry | Director | Binley Business Park CV3 2TT Coventry Merchant House United Kingdom | French | 136578380002 | ||||||
| LAZARD, Roland, Mr. | Director | Aldwych House 81 Aldwych WC2B 4HQ London | French | 105253300003 | ||||||
| LEATHLEY, Stephen Grant | Director | 89 Hough Top LS13 4QN Leeds West Yorkshire | England | British | 72040150001 | |||||
| MILLS, Ian | Director | Sheraton House 4 Swan Road HG1 2SS Harrogate North Yorkshire | British | 38854930001 | ||||||
| MOORE, Cedric Brian Granville | Director | Clover Patch 28 Wynmore Avenue Bramhope LS16 9DE Leeds West Yorkshire | British | 70195050001 | ||||||
| MOORE, Dean | Director | Bleak House Oaks Road LE67 5UP Whitwick Leicestershire | British | 94541520001 | ||||||
| POSTON, Lindsay | Director | 5 Wavel Mews West Hampstead NW6 3AB London | England | British | 70173330001 | |||||
| RHODES, Robert Edward | Director | Linden 5 Wilton Road LS29 9PG Ilkley West Yorkshire | British | 36284180001 | ||||||
| STEAD, Brian Leslie | Director | 12 Windermere Drive Alwoodley LS17 7UZ Leeds West Yorkshire England | British | 68173410001 | ||||||
| STEVENS, Kelvin Eugene | Director | 42 Tarragon Way Auclum Green Burghfield Common RG7 3YU Reading | British | 58170400001 | ||||||
| WARD, David | Director | Dean Farm House Church Road RH5 5DL Newdigate Surrey | England | British | 81549710001 |
¿Tiene GRAHAM BUILDERS MERCHANTS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Trust deed | Creado el 28 jun 1974 Entregado el 18 jul 1974 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Trust deed for securign an interes in the rate of interest payable on debenture stock of thomas tilling LTD amounting to £10,179,477 outstanding undr and seured a trust deed dated 6/12/65 and deeds supplemental thereto. | |
Breve descripción Fixed floating charge upon the (see doc 11 for futher details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Trust deed | Creado el 02 abr 1974 Entregado el 02 abr 1974 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Trust deed for securing debenture stock of thomas tilling LTD amunding to £681,199. | |
Breve descripción By way of floating charge upon the see doc 109 for futher details. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Supplemental trust deed | Creado el 22 dic 1969 Entregado el 01 ene 1970 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Supplemental trust deed for futher securing debenture stock of thomas tilling LTD amounting to £10,000,000 seucred by a trastdeed dated 6TH december 1965 | |
Breve descripción By way of a floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene GRAHAM BUILDERS MERCHANTS LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0